LAKELAND SMOLT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLAKELAND SMOLT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02146786
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LAKELAND SMOLT LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich LAKELAND SMOLT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o DWF LLP
    1 Scott Place
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LAKELAND SMOLT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COOLWAY LIMITED13. Juli 198713. Juli 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAKELAND SMOLT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für LAKELAND SMOLT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    16 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mrs Patricia Anne Duzinkewycz als Sekretär am 11. März 2022

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Lorraine Elizabeth Thompson als Sekretär am 11. März 2022

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    14 SeitenAA

    Notification of Marine Harvest Holdings As as a person with significant control on 17. Juni 2020

    2 SeitenPSC02

    Change of details for Mowi Asa as a person with significant control on 17. Juni 2020

    2 SeitenPSC05

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Marine Harvest Asa as a person with significant control on 01. Jan. 2019

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    14 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Gideon Macdonald Pringle als Geschäftsführer am 26. Nov. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LAKELAND SMOLT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DUZINKEWYCZ, Patricia Anne
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    Sekretär
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    293515490001
    HADFIELD, Benjamin
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    Geschäftsführer
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    NorwayBritish204214080001
    KAPINOS, Piotr
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    Geschäftsführer
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    ScotlandPolish243484720001
    IRVING, Paul Barrie
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    Sekretär
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    British24916240001
    TETLOW, John Richard
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    British68445840001
    THOMPSON, Lorraine Elizabeth
    c/o Marine Harvest Scotland
    88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Ratho Park
    Midlothian
    Scotland
    Sekretär
    c/o Marine Harvest Scotland
    88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Ratho Park
    Midlothian
    Scotland
    183551610001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    112938080001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    BLAIR, Colin Ian
    Fernoch Crescent
    PA31 8AE Lochgilphead
    9
    Argyll
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Fernoch Crescent
    PA31 8AE Lochgilphead
    9
    Argyll
    United Kingdom
    United KingdomScottish83104090001
    IRVING, Paul Barrie
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Little Oak,Lowthian Gill
    Low Hesket
    CA4 0DB Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish24916240001
    LISTON, William Munro
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58492580002
    MCINTOSH, Kenneth James
    c/o Marine Harvest Scotland
    88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Ratho Park
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    c/o Marine Harvest Scotland
    88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Ratho Park
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish124854160002
    MYRSETH, Bjorn
    Riplegarden 40
    N 5031 Laksevaag
    Norway
    Geschäftsführer
    Riplegarden 40
    N 5031 Laksevaag
    Norway
    NorwayNorwegian43530500001
    PRINGLE, Gideon Macdonald
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    Geschäftsführer
    c/o Dwf Llp
    2 Hardman Street
    M3 3AA Manchester
    1 Scott Place
    ScotlandBritish233949950001
    RAMSAY, Archibald Mackenzie
    The Old Rectory
    Chappel
    CO6 2AE Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Chappel
    CO6 2AE Colchester
    Essex
    British14032550001
    SUTHERLAND, Alan George
    c/o Marine Harvest Scotland
    88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Ratho Park
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    c/o Marine Harvest Scotland
    88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Ratho Park
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish121052220002
    THIAN, Robert Peter
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    Geschäftsführer
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    British41949700001
    WARRINGTON, Mark Kenneth
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Phoenix House
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Phoenix House
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish163601720001
    YOUNG, William
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    United KingdomBritish137835400001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LAKELAND SMOLT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Marine Harvest Holdings As
    Sandviksbodene 77a
    5035
    Bergen
    N/A
    Norway
    17. Juni 2020
    Sandviksbodene 77a
    5035
    Bergen
    N/A
    Norway
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandNorway
    RechtsgrundlageNorwegian
    RegistrierungsortThe Register Of Business Enterprises
    Registrierungsnummer976841220
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mowi Asa
    Sandviksboder 77ab
    5835 Bergen
    N/A
    Norway
    06. Apr. 2016
    Sandviksboder 77ab
    5835 Bergen
    N/A
    Norway
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandNorway
    RechtsgrundlageNorwegian
    RegistrierungsortThe Register Of Business Enterprises
    Registrierungsnummer964 118 191
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat LAKELAND SMOLT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A share pledge agreement
    Erstellt am 01. Feb. 2011
    Geliefert am 16. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    On the terms and conditions set out in the charge, pledges and assigns its whole right, title and interest and benefit in and to the security assets for the purpose of constituting security see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of amendment and confirmation to the legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property known as holmwrangle hatchery armathwaite carlisle cumbria t/n CU35248.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Agent)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of amendment and confirmation to the assignment of intercompany loan
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned rights being all rights in the contracts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of amendment and confirmation to the debenture
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 15,000 ordinary a shares of £1.00 each and 10,000 ordinary b shares of £1.00 each in sea products of scotland limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 each in sound of jura salmon limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 50,001 ordinary shares of £1.00 each in migdale smolt limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 1,000 ordinary shares of £1.00 hoganess salmon limited and any other assets to which it is entitled, including dividends,.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 in lakeland cairndow limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 50,000 ordinary shares of £1.00 in lakeland marine farm limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 1 ordinary share of £1.00 in lakeland unst freshwater limited and any assets to which it becomes entitled including dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2008
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the share pledge
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares being 1,500,000 ordinary shares of £1.00 in lakeland unst limited and any other assets to which it is entitled including dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2008
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the standard security
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenants interest in the lease of all and whole loch leacann t/n ARG470, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Agent)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of amendment and confirmation to the standard security
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 07. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenants interest in a lease of the area of ground extending to fifty five decimal or one hundredth parts of a hectare at furnace t/n ARG472, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Agent)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2008
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 2007
    Geliefert am 21. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Holmwrangle hatchery armathwaite carlisle cumbria t/no CU35248. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa (The Agent)
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment of intercompany loan
    Erstellt am 13. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Share pledge
    Erstellt am 13. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares being 50,000 ordinary shares of £1.00 each in lakeland marine farm limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2008 and
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 23. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole loch leacann t/no. ARG470. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa as Agent for Itself, the Finance Parties and the Overdraft Bank from Time Totime (The "Agent")
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2008 and
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 23. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that area of ground extending to fifty five decimal or one-hundredth parts of a hectare at furnace t/no. ARG472. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa as Agent for Itself, the Finance Parties and the Overdraft Bank from Time Totime (The "Agent")
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge
    Erstellt am 11. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares of migdale smolt limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge
    Erstellt am 11. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares of hoganess salmon limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge
    Erstellt am 11. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares of sea products of scotland limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge
    Erstellt am 11. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 each in sound of jura salmon limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge
    Erstellt am 11. Dez. 2007
    Geliefert am 24. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company pledges and assigns to the security agent the existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 each in lakeland unst freshwater limited.
    Berechtigte Personen
    • Dnr Nor Bank Asa (The Security Agent) on Behalf of Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0