LAKELAND SMOLT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LAKELAND SMOLT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02146786 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LAKELAND SMOLT LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LAKELAND SMOLT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o DWF LLP 1 Scott Place 2 Hardman Street M3 3AA Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LAKELAND SMOLT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COOLWAY LIMITED | 13. Juli 1987 | 13. Juli 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAKELAND SMOLT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LAKELAND SMOLT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 16 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mrs Patricia Anne Duzinkewycz als Sekretär am 11. März 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Lorraine Elizabeth Thompson als Sekretär am 11. März 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 14 Seiten | AA | ||
Notification of Marine Harvest Holdings As as a person with significant control on 17. Juni 2020 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Change of details for Mowi Asa as a person with significant control on 17. Juni 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Marine Harvest Asa as a person with significant control on 01. Jan. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 14 Seiten | AA | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Gideon Macdonald Pringle als Geschäftsführer am 26. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 15 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LAKELAND SMOLT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUZINKEWYCZ, Patricia Anne | Sekretär | c/o Dwf Llp 2 Hardman Street M3 3AA Manchester 1 Scott Place | 293515490001 | |||||||
| HADFIELD, Benjamin | Geschäftsführer | c/o Dwf Llp 2 Hardman Street M3 3AA Manchester 1 Scott Place | Norway | British | 204214080001 | |||||
| KAPINOS, Piotr | Geschäftsführer | c/o Dwf Llp 2 Hardman Street M3 3AA Manchester 1 Scott Place | Scotland | Polish | 243484720001 | |||||
| IRVING, Paul Barrie | Sekretär | Little Oak,Lowthian Gill Low Hesket CA4 0DB Carlisle Cumbria | British | 24916240001 | ||||||
| TETLOW, John Richard | Sekretär | Whittaker Court, Gawsworth New Hall Church Lane, Gawsworth SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | 68445840001 | ||||||
| THOMPSON, Lorraine Elizabeth | Sekretär | c/o Marine Harvest Scotland 88 Glasgow Road Ratho Station EH28 8PP Newbridge Ratho Park Midlothian Scotland | 183551610001 | |||||||
| LEDINGHAM CHALMERS LLP | Sekretär | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen | 112938080001 | |||||||
| LEDINGHAM CHALMERS LLP | Sekretär | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1UD Aberdeen | 73896680003 | |||||||
| BLAIR, Colin Ian | Geschäftsführer | Fernoch Crescent PA31 8AE Lochgilphead 9 Argyll United Kingdom | United Kingdom | Scottish | 83104090001 | |||||
| IRVING, Paul Barrie | Geschäftsführer | Little Oak,Lowthian Gill Low Hesket CA4 0DB Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | 24916240001 | |||||
| LISTON, William Munro | Geschäftsführer | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | United Kingdom | British | 58492580002 | |||||
| MCINTOSH, Kenneth James | Geschäftsführer | c/o Marine Harvest Scotland 88 Glasgow Road Ratho Station EH28 8PP Newbridge Ratho Park Midlothian Scotland | Scotland | British | 124854160002 | |||||
| MYRSETH, Bjorn | Geschäftsführer | Riplegarden 40 N 5031 Laksevaag Norway | Norway | Norwegian | 43530500001 | |||||
| PRINGLE, Gideon Macdonald | Geschäftsführer | c/o Dwf Llp 2 Hardman Street M3 3AA Manchester 1 Scott Place | Scotland | British | 233949950001 | |||||
| RAMSAY, Archibald Mackenzie | Geschäftsführer | The Old Rectory Chappel CO6 2AE Colchester Essex | British | 14032550001 | ||||||
| SUTHERLAND, Alan George | Geschäftsführer | c/o Marine Harvest Scotland 88 Glasgow Road Ratho Station EH28 8PP Newbridge Ratho Park Midlothian Scotland | Scotland | British | 121052220002 | |||||
| THIAN, Robert Peter | Geschäftsführer | 15a Princes Gate Mews SW7 2PS London | British | 41949700001 | ||||||
| WARRINGTON, Mark Kenneth | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Phoenix House North Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | 163601720001 | |||||
| YOUNG, William | Geschäftsführer | Argyll Road Kirn PA23 8EJ Dunoon 95 Argyll United Kingdom | United Kingdom | British | 137835400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LAKELAND SMOLT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Harvest Holdings As | 17. Juni 2020 | Sandviksbodene 77a 5035 Bergen N/A Norway | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mowi Asa | 06. Apr. 2016 | Sandviksboder 77ab 5835 Bergen N/A Norway | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LAKELAND SMOLT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A share pledge agreement | Erstellt am 01. Feb. 2011 Geliefert am 16. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben On the terms and conditions set out in the charge, pledges and assigns its whole right, title and interest and benefit in and to the security assets for the purpose of constituting security see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the legal charge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property known as holmwrangle hatchery armathwaite carlisle cumbria t/n CU35248. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the assignment of intercompany loan | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assigned rights being all rights in the contracts see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the debenture | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 15,000 ordinary a shares of £1.00 each and 10,000 ordinary b shares of £1.00 each in sea products of scotland limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 each in sound of jura salmon limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 50,001 ordinary shares of £1.00 each in migdale smolt limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 1,000 ordinary shares of £1.00 hoganess salmon limited and any other assets to which it is entitled, including dividends,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 in lakeland cairndow limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 50,000 ordinary shares of £1.00 in lakeland marine farm limited and any other assets to which it is entitled, including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 1 ordinary share of £1.00 in lakeland unst freshwater limited and any assets to which it becomes entitled including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the share pledge | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares being 1,500,000 ordinary shares of £1.00 in lakeland unst limited and any other assets to which it is entitled including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the standard security | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenants interest in the lease of all and whole loch leacann t/n ARG470, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and confirmation to the standard security | Erstellt am 19. Sept. 2008 Geliefert am 07. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenants interest in a lease of the area of ground extending to fifty five decimal or one hundredth parts of a hectare at furnace t/n ARG472, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Holmwrangle hatchery armathwaite carlisle cumbria t/no CU35248. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of intercompany loan | Erstellt am 13. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assigned rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 13. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company pledges and assigns to the security agent the existing shares being 50,000 ordinary shares of £1.00 each in lakeland marine farm limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2008 and | Erstellt am 12. Dez. 2007 Geliefert am 23. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole loch leacann t/no. ARG470. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2008 and | Erstellt am 12. Dez. 2007 Geliefert am 23. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole that area of ground extending to fifty five decimal or one-hundredth parts of a hectare at furnace t/no. ARG472. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 11. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company pledges and assigns to the security agent the existing shares of migdale smolt limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 11. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company pledges and assigns to the security agent the existing shares of hoganess salmon limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 11. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company pledges and assigns to the security agent the existing shares of sea products of scotland limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 11. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company pledges and assigns to the security agent the existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 each in sound of jura salmon limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 11. Dez. 2007 Geliefert am 24. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company pledges and assigns to the security agent the existing shares being 2 ordinary shares of £1.00 each in lakeland unst freshwater limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0