CASHINO GAMING (E&J) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CASHINO GAMING (E&J) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02147788 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Second Floor Matrix House North Fourth Street MK9 1NJ Milton Keynes England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| E & J HALL INVESTMENTS LIMITED | 02. Nov. 1999 | 02. Nov. 1999 |
| SHIPLEY INVESTMENTS LIMITED | 06. Juli 1995 | 06. Juli 1995 |
| BULL STREET (B'HAM) LIMITED | 22. Okt. 1987 | 22. Okt. 1987 |
| GIANTMYTH LIMITED | 16. Juli 1987 | 16. Juli 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 26. Okt. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 09. Nov. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 26. Okt. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Okt. 2025 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Second Floor Matrix House North Fourth Street Milton Keynes MK9 1NJ verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Seebeck House 1a Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR United Kingdom zum Second Floor, Matrix House North Fourth Street Milton Keynes MK9 1NJ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 8 Seiten | AA | ||
legacy | 51 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Okt. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 49 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Seebeck House 1a Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR zum Second Floor Matrix House North Fourth Street Milton Keynes MK9 1NJ am 29. Nov. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Okt. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of William Clark (Holdings) Limited as a person with significant control on 24. Apr. 2023 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Merkur Casino Holdings Uk Limited as a person with significant control on 24. Apr. 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Ernennung von Mr Egemen Coskun als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Notification of Merkur Casino Holdings Uk Limited as a person with significant control on 30. Nov. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Praesepe Limited as a person with significant control on 30. Nov. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von Stefan Bruns als Geschäftsführer am 03. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Borris Lungen als Geschäftsführer am 31. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Mark Stefan Schertle als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 48 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSKUN, Egemen | Geschäftsführer | Matrix House North Fourth Street MK9 1NJ Milton Keynes Second Floor England | England | British | 308275440001 | |||||||||
| SCHERTLE, Mark Stefan | Geschäftsführer | Matrix House North Fourth Street MK9 1NJ Milton Keynes Second Floor England | England | British | 308274910001 | |||||||||
| HALL, Joy | Sekretär | Cedar House 84 Aldridge Road Aldridge WS9 0PE Walsall West Midlands | British | 21148690003 | ||||||||||
| PROCTOR, Matthew Frederick | Sekretär | 4 Hill Street LE65 2LS Ashby-De-La-Zouch Blaisdon Leicestershre United Kingdom | British | 136671560001 | ||||||||||
| SHIPLEY, Jonathan | Sekretär | Casa Pinada Roman Road Little Aston B74 3AB Sutton Coldfield West Midlands | British | 1983250001 | ||||||||||
| SHIPLEY, Joy | Sekretär | Casa Pinada Roman Road Little Aston B74 3AB Sutton Coldfield West Midlands | British | 21148690001 | ||||||||||
| EMW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom |
| 93910510003 | ||||||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
| BALL, Susan Elisabeth | Geschäftsführer | 25 Silver Birch Drive Houndsfield B47 5RB Wythall Birmingham | British | 12407250001 | ||||||||||
| BRUNS, Stefan | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | Germany | German | 248097030001 | |||||||||
| EVANS, Byron | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | English | 140884750001 | |||||||||
| HALL, Andrew James | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 30306840002 | |||||||||
| HALL, Elliot Lawrence | Geschäftsführer | Cedar House 84 Aldridge Road Aldridge WS9 0PE Walsall | United Kingdom | British | 61434320001 | |||||||||
| HALL, Joy | Geschäftsführer | Cedar House 84 Aldridge Road Aldridge WS9 0PE Walsall West Midlands | British | 70235100001 | ||||||||||
| HARDING, Nicholas Simon | Geschäftsführer | Black Friars Lane EC4V 6HD London 20 United Kingdom | England | British | 150860820001 | |||||||||
| HUGHES, Jonathan Boyd | Geschäftsführer | Carlton Green DL11 7AF Aldbrough St John Carlton Green Hall North Yorkshire | United Kingdom | British | 164495520001 | |||||||||
| LUNGEN, Borris | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | United Kingdom | German | 248097050001 | |||||||||
| MASCORD, David Anthony | Geschäftsführer | Underwood Drive LE9 4TDE Stoney Stanton 11 Leicestershire United Kingdom | British | 106843860001 | ||||||||||
| PROCTOR, Matthew Frederick | Geschäftsführer | 4 Hill Street LE65 2LS Ashby-De-La-Zouch Blaisdon Leicestershre United Kingdom | England | British | 136671560001 | |||||||||
| SHIPLEY, Harry James | Geschäftsführer | Canwell Hall Canwell B75 5SQ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 1983240001 | |||||||||
| SHIPLEY, Jonathan | Geschäftsführer | Casa Pinada Roman Road Little Aston B74 3AB Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 1983250001 | |||||||||
| SHIPLEY, Jonathan | Geschäftsführer | Casa Pinada Roman Road Little Aston B74 3AB Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 1983250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASHINO GAMING (E&J) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Clark (Holdings) Limited | 24. Apr. 2023 | Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House 1a Buckinghamshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Merkur Casino Holdings Uk Limited | 30. Nov. 2021 | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Praesepe Limited | 06. Apr. 2016 | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0