NPS (UK4) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NPS (UK4) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02149536 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NPS (UK4) LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich NPS (UK4) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NPS (UK4) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NORTHGATE LAND AND PROPERTY SOLUTIONS LIMITED | 01. Dez. 2005 | 01. Dez. 2005 |
| M V M CONSULTANTS PLC | 11. Sept. 1987 | 11. Sept. 1987 |
| TRYVISION LIMITED | 22. Juli 1987 | 22. Juli 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NPS (UK4) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NPS (UK4) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW zum 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Mai 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2019 bis 31. März 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen James Callaghan am 06. Aug. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Michael Noble als Geschäftsführer am 06. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Apr. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ian Michael Noble als Direktor am 06. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Coll als Geschäftsführer am 06. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen James Callaghan als Direktor am 10. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Meaden als Geschäftsführer am 10. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed northgate land and property solutions LIMITED\certificate issued on 16/06/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von David John Meaden als Direktor am 22. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NPS (UK4) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| BENNETT, Colston Albert, Company Secretary | Sekretär | 18 Station Road Backwell BS19 3NW Bristol Avon | British | 17444890001 | ||||||||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Sekretär | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Sekretär | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||||||
| GOLLOP, Philip George | Sekretär | 259 Passage Road Brentry BS10 7JA Bristol Avon | British | 944510001 | ||||||||||
| NUNN, Carol Jayne | Sekretär | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Sekretär | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 128558470001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Sekretär | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| TURNER, David Charles | Sekretär | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
| YOUNG, Victor John | Sekretär | Willow Bank Willow View Close SN16 0BZ Malmesbury Wiltshire | British | 23808250002 | ||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| CHESTER, Andrew, Dr | Geschäftsführer | 71 Downs Park East Westbury Park BS6 7QG Bristol Avon | British | 36723830001 | ||||||||||
| CLIFTON, Philip John | Geschäftsführer | The Dovecote Church Street LE15 8JR North Luffenham Rutland | British | 60585520003 | ||||||||||
| COLL, Andrew | Geschäftsführer | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| GLEAVE, David | Geschäftsführer | 4 Cricklade Road BS7 9EN Bristol S Gloucestershire | British | 30628010004 | ||||||||||
| GREENLAND, Martyn Geoffrey | Geschäftsführer | 11 York Road GL20 5HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 45440250001 | ||||||||||
| HARLEY, Donald Wilson George | Geschäftsführer | 22 Saint Marys Park SG8 7XB Royston Hertfordshire | British | 80358920001 | ||||||||||
| MACHIN, Brian Roy | Geschäftsführer | Drylaw Cottage Cote Drive BS9 3UP Bristol | British | 8982230003 | ||||||||||
| MARKHAM, Richard John | Geschäftsführer | Castle Cote 3 Ivywell Road Sneyd Park BS9 1NX Bristol Avon | United Kingdom | British | 35544120002 | |||||||||
| MEADEN, David John | Geschäftsführer | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 199843940001 | |||||||||
| PARRY, Leslie | Geschäftsführer | 2 Millers Cottages Fromebridge Lane GL2 7PD Whitminster Gloucestershire | British | 36362110004 | ||||||||||
| PAVELEY, Norman | Geschäftsführer | 21 Newfield Road Hagley DY9 0JP Stourbridge West Midlands | British | 28026460001 | ||||||||||
| RIX, David | Geschäftsführer | Upper Coach House Saville Road BS6 7TS Bristol | British | 56402040001 | ||||||||||
| STIER, John Robert | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||||||
| VENN, Jon | Geschäftsführer | North Hill Cottage East Dundry Lane Dundry BS41 8NJ Bristol | British | 15778460001 | ||||||||||
| YOUNG, Victor John | Geschäftsführer | Willow Bank Willow View Close SN16 0BZ Malmesbury Wiltshire | British | 23808250002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NPS (UK4) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mvm Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NPS (UK4) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Erstellt am 29. Apr. 2008 Geliefert am 12. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 11. Mai 2007 Geliefert am 23. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. Juli 1992 Geliefert am 15. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. Sept. 1988 Geliefert am 28. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 13 great george street bristol, avon title no. AV103404, AV5629 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 20. Okt. 1987 Geliefert am 20. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums standing to the credit in the deposit account held at dryfield finance limited of 2 st pauls road, clifton bristol opened by the chargees solicitor in accordance with the terms of the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NPS (UK4) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten K önigreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0