NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED

NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02153963
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Langley House Park Road
    East Finchley
    N2 8EY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NEROKIRK LIMITED11. Aug. 198711. Aug. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Mai 2020

    15 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Shelley Stock Hutter Llp 1st Floor, 7-10 Chandos Street London W1G 9DQ zum Langley House Park Road East Finchley London N2 8EY am 17. Juni 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. Mai 2019

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2019 mit Aktualisierungen

    10 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 27 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 26 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2018 mit Aktualisierungen

    11 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 27. Okt. 2017

    • Kapital: GBP 160
    7 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    50 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    10 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CASSON JONES, Annette Michelle
    Park Road
    East Finchley
    N2 8EY London
    Langley House
    Sekretär
    Park Road
    East Finchley
    N2 8EY London
    Langley House
    243854340001
    FRANKEL POLLEN, Raena Rachel
    Park Road
    East Finchley
    N2 8EY London
    Langley House
    Geschäftsführer
    Park Road
    East Finchley
    N2 8EY London
    Langley House
    EnglandBritish3287860001
    FRANKEL-POLLEN, Nicholas Anthony
    c/o Shelley Stock Hutter Llp
    Chandos Street
    W1G 9DQ London
    1st Floor, 7-10
    England
    Geschäftsführer
    c/o Shelley Stock Hutter Llp
    Chandos Street
    W1G 9DQ London
    1st Floor, 7-10
    England
    United KingdomBritish3287840001
    TOWNLEY, Richard Alan Harvey
    c/o Shelley Stock Hutter Llp
    Chandos Street
    W1G 9DQ London
    1st Floor, 7-10
    England
    Geschäftsführer
    c/o Shelley Stock Hutter Llp
    Chandos Street
    W1G 9DQ London
    1st Floor, 7-10
    England
    United KingdomBritish50507670001
    ESSEX, Hettie
    9 Chessington Court
    N3 3DT London
    Sekretär
    9 Chessington Court
    N3 3DT London
    British28440660001
    FRANKEL POLLEN, Raena Rachel
    c/o Shelley Stock Hutter Llp
    Chandos Street
    W1G 9DQ London
    1st Floor, 7-10
    England
    Sekretär
    c/o Shelley Stock Hutter Llp
    Chandos Street
    W1G 9DQ London
    1st Floor, 7-10
    England
    British3287860001
    ESSEX, Hettie
    9 Chessington Court
    N3 3DT London
    Geschäftsführer
    9 Chessington Court
    N3 3DT London
    British28440660001
    ESSEX, Samuel
    9 Chessington Court
    N3 3DT London
    Geschäftsführer
    9 Chessington Court
    N3 3DT London
    British28440670001
    TOWNLEY, Judy Gayle
    2 Nottingham Street
    W1U 5EF London
    Geschäftsführer
    2 Nottingham Street
    W1U 5EF London
    United KingdomAmerican31639710002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Richard Alan Harvey Townley
    Park Road
    East Finchley
    N2 8EY London
    Langley House
    06. Apr. 2016
    Park Road
    East Finchley
    N2 8EY London
    Langley House
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of rental income
    Erstellt am 05. März 2008
    Geliefert am 12. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from 44 pear tree street london.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of rental income
    Erstellt am 05. März 2008
    Geliefert am 12. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from 29/35 st stephens street and 39/45 st nicholas street bristol.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 05. März 2008
    Geliefert am 12. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 44 pear tree street london.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2008
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 05. März 2008
    Geliefert am 12. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 29/35 st stephens street and 39/45 st nicholas street bristol.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title and benefits and interest in and to all rent from 37 nottingham terrace marylebone london.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    • 11. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    37 nottingham terrace marylebone road london.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    • 11. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 06. Apr. 2001
    Geliefert am 14. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £588,000.00 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all that f/h property k/a friary house, 15 colston street bristol t/n BL15495 by way of first floating charge all the assets property and undertaking of the borrower whatsoever and wheresoever both present and future including all the goodwill and uncalled capital for the time being. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 05. Feb. 2001
    Geliefert am 13. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £330,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that freehold property known as 29 to 35 (odd) st stephens street and 39 to 45 (odd) st nicholas street bristol by way of first floating charge all the assets property and undertaking whatsoever and wheresoever both present and future including all the goodwill and uncalled capital for the time being by way of fixed charge all rents in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2000
    Geliefert am 02. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £158,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a 44 peartree street london EC1 t/n NGL737203.
    Berechtigte Personen
    • Harold Frankel-Pollen
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 14. Juli 2000
    Geliefert am 25. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as flat 55 melcombe regis court,weymouth st,london W1,london borough of westminster; ngl 138248. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 24. Mai 2000
    Geliefert am 26. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property - 81 nottingham terrace london W1; ngl 149893, city of westminster. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 29. Okt. 1999
    Geliefert am 04. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £230,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 44 peartree street london EC1 t/no.NGL737203 and by way of floating charge all assets property and undertaking present and future including goodwill uncalled capital. By way of fixed charge all rents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Memorandum of deposit over shares
    Erstellt am 07. März 1997
    Geliefert am 24. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    199 ordinary shares in chapel street developments and all dividends or interest paid or payable on the securities of the shares.
    Berechtigte Personen
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transaktionen
    • 24. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Feb. 1995
    Geliefert am 04. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £50,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    44 peartree street london EC1.
    Berechtigte Personen
    • Mrs Hilda Townley
    Transaktionen
    • 04. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 05. Dez. 1994
    Geliefert am 10. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 18A queens avenue muswell hill london N10 and garage and floating charge over all assets of the company.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 02. Nov. 1994
    Geliefert am 17. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £390,000 and all other monies due or to become due from the company and/or lisburne holdings limited to the chargee under the terms of the legal charge and floating charge deed
    Kurze Angaben
    L/H property situate at and k/a 10 and 12 all saints square bedworth warwickshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Okt. 1994
    Geliefert am 11. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    45 townsend road london NW8 and floating charge over all undertaking property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Okt. 1994
    Geliefert am 11. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 81 nottingham terrace london NW1 and floating charge over the undertaking of the company and all it's other properties present and future.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1993
    Geliefert am 08. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £85,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a plot WB5 cronin road industrial estate weldon south industrial estate corby northampton tog with a floating charge all the assets property and undertaking of the company including all the goodwill and uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £158,000
    Kurze Angaben
    Property shortly k/a 84 high street halesowen.
    Berechtigte Personen
    • Harold Frankel-Pollen
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 1993
    Geliefert am 09. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £330,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 84 high street halesowen part title no WM316177 floating charge all the assets property and undertaking of the company including goodwill and uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 1993
    Geliefert am 16. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £300,000 and all other monies due or to become due from the company and or herons park limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a plot WB5 cronin road industrial estate weldon south industrial estate corby northamptonshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Geliefert am 22. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £875,000 and all other monies due or to become due from the company and/or herons park limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot WB5 cronin road industrial estate weldon south industrial estate corby northamptonshire together with floating charge over all the assets property and undertaking present and future including goodwill uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 1989
    Geliefert am 11. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £265,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    44 peartree street london. Title no ln 242301 floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 29. Okt. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Mai 1989
    Geliefert am 07. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £135,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H property 18 high street market drayton shropshire floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 08. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NORTH SQUARE PROPERTIES (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Mai 2019Beginn der Liquidation
    15. Juni 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Renshaw
    Langley House Park Road
    N2 8EY London
    Praktiker
    Langley House Park Road
    N2 8EY London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0