NTL CAMBRIDGE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NTL CAMBRIDGE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02154841 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NTL CAMBRIDGE LIMITED?
- Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich NTL CAMBRIDGE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NTL CAMBRIDGE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE CABLE LIMITED | 20. Mai 1988 | 20. Mai 1988 |
| JULY LIMITED | 14. Aug. 1987 | 14. Aug. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NTL CAMBRIDGE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NTL CAMBRIDGE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Ernennung von Roderick Gregor Mcneil als Direktor am 09. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Thomas Castell als Geschäftsführer am 09. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Thomas Castell als Direktor am 09. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Dominic Dunn als Geschäftsführer am 09. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum 1 More London Place London SE1 2AF am 31. Juli 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410017 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410022 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410013 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410018 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410020 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410019 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 021548410016 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NTL CAMBRIDGE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | More London Place SE1 2AF London 1 | 151342510001 | |||||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 182167230001 | |||||
| MCNEIL, Roderick Gregor | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 267964620001 | |||||
| ASHBURNER, Ronald Leslie George | Sekretär | 5 The Avenue UB10 8NR Uxbridge Middlesex | British | 102503610001 | ||||||
| CHEW, Mun Chun | Sekretär | 15 Rectory Farm Road Little Wilbraham CB1 5LB Cambridge | Singaporean | 36124880001 | ||||||
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | 148 Selwyn Avenue Highams Park E4 9LS London | British | 72139660001 | ||||||
| LUBASCH, Richard Joel | Sekretär | 4 Beech Tree Lane NEW YORK Brookville 11545 Usa | British | 81075820001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | 47785600002 | ||||||
| MARSHALL, Brian | Bevollmächtigter Sekretär | Owls Hall Chimney Street Hundon CO10 8DX Sudbury Suffolk | British | 900008320001 | ||||||
| PROCTOR, Martina | Sekretär | 37a Madingley Road CB3 0EL Cambridge | British | 43777590001 | ||||||
| TVETER, Eric John | Sekretär | 12 The Mallards CB5 8HJ Cambridge Cambridgeshire | Usa | 53395160001 | ||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| ALDEN, Peter James | Geschäftsführer | 9 Redwood Lodge Grange Road CB3 9AU Cambridge Cambridgeshire | British | 40967330001 | ||||||
| BRODSKY, Julian Alvin | Geschäftsführer | 1004 Swallow Drive Cherryhill New Jersey 08003 Usa | American | 11120770001 | ||||||
| CAMPBELL, Gerald Daniel | Geschäftsführer | 18 Ringwood Avenue N2 9NS London | American | 48066760001 | ||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||
| CASTELL, William Thomas | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 England United Kingdom | England | British | 248424970001 | |||||
| CHEW, Mun Chun | Geschäftsführer | 15 Rectory Farm Road Little Wilbraham CB1 5LB Cambridge | Singaporean | 36124880001 | ||||||
| CHIA, Choon Wei, Doctor | Geschäftsführer | 32 Adis Road 01-41 Sophia Court Singapore 0922 | Singaporean | 35806810001 | ||||||
| CHURCHILL, Daniel Creighton | Geschäftsführer | Helliers Chapel Road Buckleberry Common RG7 6NN Reading Berkshire | American | 34603880001 | ||||||
| CHURCHILL, Daniel Creighton | Geschäftsführer | Helliers Chapel Road Buckleberry Common RG7 6NN Reading Berkshire | American | 34603880001 | ||||||
| CLASEN, Robert Burke | Geschäftsführer | 2021 Avenda Chico CA 92660 Newport Beach California Usa | American | 34348730001 | ||||||
| CLASEN, Robert Burke | Geschäftsführer | 2021 Avenda Chico CA 92660 Newport Beach California Usa | American | 34348730001 | ||||||
| COSGROVE, Charles Henry | Geschäftsführer | 52 Oxley Road Valley Mansion 0923 Singapore | American | 36156420001 | ||||||
| CURRY, Christopher John | Geschäftsführer | 5 River Lane Brampton PE18 8PU Huntingdon Cambridgeshire | British | 64368820001 | ||||||
| DAVENPORT, Hugo Riddell Agard Bramhall | Geschäftsführer | 19 Wingate Way CB2 2HD Cambridge Cambridgeshire | British | 6298250001 | ||||||
| DAVIES, Richard James | Geschäftsführer | The Library Suite The Mansion KT16 0QB Ottershaw Park Surrey | American | 45182540001 | ||||||
| DUNN, Robert Dominic | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 179134020002 | |||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 96956740001 | |||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Station Road KT7 0NS Thames Ditton 42 Surrey | England | British | 96956740001 | |||||
| GOWEN, Wayne Lyle | Geschäftsführer | New House Fairoak Lane Oxshott KT22 0TP Leatherhead Surrey | British | 39694410001 | ||||||
| GOWEN, Wayne Lyle | Geschäftsführer | New House Fairoak Lane Oxshott KT22 0TP Leatherhead Surrey | British | 39694410001 | ||||||
| GRAFIN VON BROCKDORFF AHLFELDT, Claire Louise Elizabeth | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 166267770001 | |||||
| GREGG, John Francis | Geschäftsführer | 411 Silvermoss Drive Vero Beach Florida 32963 America | American | 75381740001 | ||||||
| HO, Lam Phoh | Geschäftsführer | 129 Tanah Kerah Kechill Road 1646 Singapore | Singaporean | 36156430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NTL CAMBRIDGE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Media Limited | 29. Juni 2016 | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NTL CAMBRIDGE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 05. Juli 2019 Geliefert am 10. Juli 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 16. Mai 2019 Geliefert am 24. Mai 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 21. März 2017 Geliefert am 23. März 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 01. Feb. 2017 Geliefert am 07. Feb. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 26. Apr. 2016 Geliefert am 27. Apr. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Apr. 2015 Geliefert am 06. Mai 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. März 2015 Geliefert am 01. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 28. Jan. 2015 Geliefert am 06. Feb. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 04. Apr. 2014 Geliefert am 10. Apr. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 28. März 2014 Geliefert am 02. Apr. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Juni 2013 Geliefert am 14. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmation deed | Erstellt am 03. März 2011 Geliefert am 15. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 29. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An alternative bridge composite debenture | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 29. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 10. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Nov. 1998 Geliefert am 11. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the east side of ainsworth street. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 06. Jan. 1998 Geliefert am 23. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due, owing or incurred to the chargee in its capacity as security trustee by the company and/or all or any of the other companies named therein under or pursuant to the agreement and/or the composite guarantee and debenture and/or the security trust deed and/or any of the other security documents, all obligations and liabilities due owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein to the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements, and to the bond providers, if any (or any of them) in respect of any indemnity from the company and/or all or any of the other companies named therein issued in connection with the bond provision arrangements | |
Kurze Angaben Westbrook centre first floor block d milton road cambridge CB4 1YG; unit 208 science park milton road cambridge CB4 4GZ; unit 304 science park milton road cambridge CB4 4GZ, for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First fixed charge deed | Erstellt am 07. Nov. 1994 Geliefert am 17. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan facility letter of even date and this deed | |
Kurze Angaben All hardware which is subject of a supply agreement dated 28 january 1994 and entered into between the company and nokia telecommunications limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 09. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings at 72A ainsworth street, cambridge, title no. CB27930. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NTL CAMBRIDGE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0