NTL CAMBRIDGE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNTL CAMBRIDGE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02154841
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NTL CAMBRIDGE LIMITED?

    • Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich NTL CAMBRIDGE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NTL CAMBRIDGE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CAMBRIDGE CABLE LIMITED20. Mai 198820. Mai 1988
    JULY LIMITED14. Aug. 198714. Aug. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NTL CAMBRIDGE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für NTL CAMBRIDGE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Ernennung von Roderick Gregor Mcneil als Direktor am 09. März 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von William Thomas Castell als Geschäftsführer am 09. März 2020

    1 SeitenTM01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Ernennung von Mr William Thomas Castell als Direktor am 09. Sept. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Dominic Dunn als Geschäftsführer am 09. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum 1 More London Place London SE1 2AF am 31. Juli 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Juli 2019

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410022 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410013 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410020 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410019 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 021548410016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von NTL CAMBRIDGE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Sekretär
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    151342510001
    HIFZI, Mine Ozkan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish182167230001
    MCNEIL, Roderick Gregor
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish267964620001
    ASHBURNER, Ronald Leslie George
    5 The Avenue
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    Sekretär
    5 The Avenue
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    British102503610001
    CHEW, Mun Chun
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Sekretär
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Singaporean36124880001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    MARSHALL, Brian
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    Bevollmächtigter Sekretär
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    British900008320001
    PROCTOR, Martina
    37a
    Madingley Road
    CB3 0EL Cambridge
    Sekretär
    37a
    Madingley Road
    CB3 0EL Cambridge
    British43777590001
    TVETER, Eric John
    12 The Mallards
    CB5 8HJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Sekretär
    12 The Mallards
    CB5 8HJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Usa53395160001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    ALDEN, Peter James
    9 Redwood Lodge
    Grange Road
    CB3 9AU Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    9 Redwood Lodge
    Grange Road
    CB3 9AU Cambridge
    Cambridgeshire
    British40967330001
    BRODSKY, Julian Alvin
    1004 Swallow Drive
    Cherryhill
    New Jersey
    08003
    Usa
    Geschäftsführer
    1004 Swallow Drive
    Cherryhill
    New Jersey
    08003
    Usa
    American11120770001
    CAMPBELL, Gerald Daniel
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    Geschäftsführer
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    American48066760001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CASTELL, William Thomas
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish248424970001
    CHEW, Mun Chun
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Geschäftsführer
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Singaporean36124880001
    CHIA, Choon Wei, Doctor
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Geschäftsführer
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Singaporean35806810001
    CHURCHILL, Daniel Creighton
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    American34603880001
    CHURCHILL, Daniel Creighton
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    American34603880001
    CLASEN, Robert Burke
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    Geschäftsführer
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    American34348730001
    CLASEN, Robert Burke
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    Geschäftsführer
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    American34348730001
    COSGROVE, Charles Henry
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    Geschäftsführer
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    American36156420001
    CURRY, Christopher John
    5 River Lane
    Brampton
    PE18 8PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    5 River Lane
    Brampton
    PE18 8PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British64368820001
    DAVENPORT, Hugo Riddell Agard Bramhall
    19 Wingate Way
    CB2 2HD Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    19 Wingate Way
    CB2 2HD Cambridge
    Cambridgeshire
    British6298250001
    DAVIES, Richard James
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    American45182540001
    DUNN, Robert Dominic
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish179134020002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GOWEN, Wayne Lyle
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    British39694410001
    GOWEN, Wayne Lyle
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    British39694410001
    GRAFIN VON BROCKDORFF AHLFELDT, Claire Louise Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish166267770001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    HO, Lam Phoh
    129 Tanah Kerah Kechill Road
    1646 Singapore
    Geschäftsführer
    129 Tanah Kerah Kechill Road
    1646 Singapore
    Singaporean36156430001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NTL CAMBRIDGE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    29. Juni 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2591237
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat NTL CAMBRIDGE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. Juli 2019
    Geliefert am 10. Juli 2019
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 10. Juli 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Mai 2019
    Geliefert am 24. Mai 2019
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 24. Mai 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 21. März 2017
    Geliefert am 23. März 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. März 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Feb. 2017
    Geliefert am 07. Feb. 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Apr. 2016
    Geliefert am 27. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Apr. 2015
    Geliefert am 06. Mai 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Mai 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. März 2015
    Geliefert am 01. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Jan. 2015
    Geliefert am 06. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Apr. 2014
    Geliefert am 10. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. März 2014
    Geliefert am 02. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 14. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 14. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 03. März 2011
    Geliefert am 15. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 15. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2004
    Geliefert am 30. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 30. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 1998
    Geliefert am 11. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the east side of ainsworth street. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Jan. 1998
    Geliefert am 23. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due, owing or incurred to the chargee in its capacity as security trustee by the company and/or all or any of the other companies named therein under or pursuant to the agreement and/or the composite guarantee and debenture and/or the security trust deed and/or any of the other security documents, all obligations and liabilities due owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein to the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements, and to the bond providers, if any (or any of them) in respect of any indemnity from the company and/or all or any of the other companies named therein issued in connection with the bond provision arrangements
    Kurze Angaben
    Westbrook centre first floor block d milton road cambridge CB4 1YG; unit 208 science park milton road cambridge CB4 4GZ; unit 304 science park milton road cambridge CB4 4GZ, for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First fixed charge deed
    Erstellt am 07. Nov. 1994
    Geliefert am 17. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan facility letter of even date and this deed
    Kurze Angaben
    All hardware which is subject of a supply agreement dated 28 january 1994 and entered into between the company and nokia telecommunications limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Intenational Nederlanden Bank Nv
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 09. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at 72A ainsworth street, cambridge, title no. CB27930.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 15. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NTL CAMBRIDGE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Juli 2019Beginn der Liquidation
    12. Mai 2020Soll aufgelöst werden am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0