THORNTON HALL HOTEL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | THORNTON HALL HOTEL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02156621 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Thornton Hall Hotel Neston Road Thornton Hough CH63 1JF Wirral |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
C.D. THOMPSON (HOTELS) LIMITED | 31. Okt. 1989 | 31. Okt. 1989 |
CORAVIEW HOTELS LIMITED | 30. Juni 1988 | 30. Juni 1988 |
CORAVIEW LIMITED | 24. Aug. 1987 | 24. Aug. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Mai 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 24. Mai 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Mai 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mr Peter Lee Webster als Direktor am 01. Jan. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2023 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Lee Webster als Geschäftsführer am 11. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 021566210006, erstellt am 22. Jan. 2015 | 26 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMPSON, Andrew Lloyd | Sekretär | Neston Road Thornton Hough CH63 1JF Wirral Thornton Hall Hotel England | British | 18315560007 | ||||||
THOMPSON, Andrew Lloyd | Geschäftsführer | Neston Road Thornton Hough CH63 1JF Wirral Thornton Hall Hotel England | United Kingdom | British | Director | 18315560008 | ||||
THOMPSON, Nancy | Geschäftsführer | Dawpool Drive Bebington CH62 6DQ Wirral 40 Merseyside | United Kingdom | British | Director | 18315580001 | ||||
WEBSTER, Peter Lee | Geschäftsführer | Neston Road Thornton Hough CH63 1JF Wirral Thornton Hall Hotel | United Kingdom | British | Company Director | 330782540001 | ||||
BEAUMONT, Robin | Sekretär | 28 Thirlmere Close Frodsham WA6 7LZ Warrington Cheshire | British | 12457720001 | ||||||
GIBBONS, Linda Janet | Sekretär | The Shack Liverpool Road Neston L64 3RF South Wirral Cheshire | British | 35506410001 | ||||||
JOHNSON, Peter | Geschäftsführer | Breydon 35 Beryl Road Noctorum CH43 9RS Birkenhead Merseyside | England | British | None | 92715120001 | ||||
THOMPSON, Colin David | Geschäftsführer | 93 Duke Street CH41 8BR Birkenhead Wirral Merseyside | British | Company Director | 70240360003 | |||||
THOMPSON, Colin David | Geschäftsführer | 56 Hamilton Street CH41 5HZ Birkenhead Merseyside | British | Hotelier | 70240360001 | |||||
THOMPSON, Nancy | Geschäftsführer | 40 Dawpool Drive Bebington CH62 6DQ Wirral Merseyside | United Kingdom | British | Director | 18315580001 | ||||
WEBSTER, Peter Lee | Geschäftsführer | Neston Road Thornton Hough CH63 1JF Wirral Thornton Hall Hotel England | England | British | Retired Bank Manager | 150147380001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THORNTON HALL HOTEL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thompson (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Neston Road Thornton Hough CH63 1JF Wirral Thornton Hall Hotel England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat THORNTON HALL HOTEL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 22. Jan. 2015 Geliefert am 26. Jan. 2015 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 2005 Geliefert am 21. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a thornton hall hotel neston road thornton hough t/n MS266509. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Juni 1997 Geliefert am 06. Juni 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Feb. 1995 Geliefert am 20. Feb. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 09. Jan. 1991 Geliefert am 11. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Thornton hall hotel neston road, wirral, merreyside together with the fixtures and fittings goodwill of the business benefit of licences floating charge over all the movealbe plant equipment furniture and all other fixtures and fittings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral debenture | Erstellt am 05. Nov. 1987 Geliefert am 09. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from dealaview limited the company to the charge on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0