MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED

MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02157370
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED29. Feb. 198829. Feb. 1988
    BURGINHALL 194 LIMITED26. Aug. 198726. Aug. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW zum 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Mai 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 03. Apr. 2019

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2018

    2 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2019 bis 31. März 2019

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Ian Michael Noble als Geschäftsführer am 06. Aug. 2018

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen James Callaghan am 06. Aug. 2018

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Mai 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2017

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016

    4 SeitenAA

    Ernennung von Ian Michael Noble als Direktor am 06. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Coll als Geschäftsführer am 06. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen James Callaghan als Direktor am 10. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Meaden als Geschäftsführer am 10. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 01. Juni 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Juni 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2014

    4 SeitenAA

    Ernennung von David John Meaden als Direktor am 22. Dez. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Pinsent Masons Secretarial Limited als Sekretär am 22. Dez. 2014

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von John Robert Stier als Geschäftsführer am 22. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Sekretär
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Sekretär
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    Sekretär
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Sekretär
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Sekretär
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    YOUNG, Victor John
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    Sekretär
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    British23808250002
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    CHESTER, Andrew, Dr
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    British36723830001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GREENLAND, Martyn Geoffrey
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British45440250001
    MACHIN, Brian Roy
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    Geschäftsführer
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    British8982230003
    MARKHAM, Richard John
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    United KingdomBritish35544120002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    RUDD, Jeremy George Winterton
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    United KingdomBritish74891640002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    VENN, Jon
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    Geschäftsführer
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    British15778460001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03033447
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. Sept. 1997
    Geliefert am 02. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of variation
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the obligations undertakings and liabilities of the company to the chargee (as defined in a charge dated 21ST october 1988)
    Kurze Angaben
    Pursuant to clause 2 if the charge (as amended by the deed of variation) all right title & interest in the local authority agreement & in the settlement agreement but without limitation the benefit of all powers & remedies but excluding all amounts payable thereunder in respect of vat. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed (amending the charge dated 20TH july 1988 and the supplemental charge dated 18TH november 1991)
    Erstellt am 12. Mai 1994
    Geliefert am 14. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    And amending the charge dated 20TH july 1988 (the "general clc charge") and the supplemental charge dated 18TH november 1991 (the "supplemental charge")
    Kurze Angaben
    (I) first fixed charge all clc's right title and interest in each of the deposits (ii) first fixed charge all clc's right title and interest in the digital agreement (iii) first fixed charge all clc's right title and interest in the csl agreement (iv) floating charge all undertaking property assets and rights....... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 13. Mai 1993
    Geliefert am 21. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the local authority agreement including the benefit of all powers and remedies for enforcing the same but excluding all amounts payable to the company thereunder in respect of V.A.T.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Specific digital security
    Erstellt am 13. Mai 1993
    Geliefert am 21. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and/or this deed
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all the machinery equipment and other chattels as listed on the form 395 inclusive of clc gateway and one VT320 terminal and keyboard. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 23. Dez. 1992
    Geliefert am 05. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and in relation to or in connection with the advance (as defined therein) and other monies due in respect thereof
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge clc's right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395 and schedule attached.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over contract
    Erstellt am 04. Nov. 1992
    Geliefert am 19. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that benefit of an agreement dated 10/4/90 between the company and hartlepool borough council.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Specific digital security
    Erstellt am 13. Okt. 1992
    Geliefert am 26. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity as defined therein
    Kurze Angaben
    First fixed charge all right title and interest of the company in the equipment as detailed on form 395 see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 13. Okt. 1992
    Geliefert am 20. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of thw charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 27. Apr. 1992
    Geliefert am 06. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined) and/or this charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in the local authority agreement (as defined) ....(please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 23. März 1992
    Geliefert am 24. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC in connection with the advance (as defined) and/or this charge.
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge, clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined). (See doc 395 reference M8L for full details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Specific digital security
    Erstellt am 25. Feb. 1992
    Geliefert am 09. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity contained in clause 5 of the clc digital agreement dated 25/7/89
    Kurze Angaben
    1 oracle database licence and various items of equipment see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transaktionen
    • 09. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 17. Feb. 1992
    Geliefert am 22. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 20. Dez. 1991
    Geliefert am 07. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC in relation to the advance applicable to hereford city council under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in the local authority agreement (please see doc M395 reference M247 for full details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 18. Nov. 1991
    Geliefert am 29. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of second fixed charge ,clc's right title and interest in each of the deposits ,the digital agreement,the csl agreement. Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 06. Sept. 1991
    Geliefert am 12. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's interest in and to the local authority agreement (please see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 25. Juli 1991
    Geliefert am 01. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the 'advance' this charge as defined
    Kurze Angaben
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge C.L.c's right title and interest in the local authority agreement. As defined on form 395 M9.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 25. Juli 1991
    Geliefert am 01. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the "advance" this charge as defined.
    Kurze Angaben
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole, absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined on the form 395 M10).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Specific digital security.
    Erstellt am 08. Mai 1991
    Geliefert am 28. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and this charge.
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company in the equipment specified on form M395 (see form M395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transaktionen
    • 28. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 08. Mai 1991
    Geliefert am 10. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance and all other moneys due in respect thereof under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority. Agreement (for full details see form 395 & schedule detailed).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Specific digital security
    Erstellt am 16. Apr. 1991
    Geliefert am 27. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    Kurze Angaben
    (See 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Digital Equipment Co. Limited.
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Specific digital security
    Erstellt am 16. Apr. 1991
    Geliefert am 27. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    Kurze Angaben
    (See 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Digital Equipment Co. Limited.
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 16. Apr. 1991
    Geliefert am 26. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 16. Apr. 1991
    Geliefert am 26. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 09. Jan. 1991
    Geliefert am 23. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Apr. 2019Beginn der Liquidation
    01. Feb. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0