GIBBS NEWSAGENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GIBBS NEWSAGENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02159775 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GOODMAN GIBBS LIMITED | 21. Okt. 1987 | 21. Okt. 1987 |
| SWITCHCLASS LIMITED | 31. Aug. 1987 | 31. Aug. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 25. Feb. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 21. März 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom zum Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 22. Jan. 2018
| 5 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Feb. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Feb. 2018
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Robert John Welch als Direktor am 09. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tesco Services Limited als Geschäftsführer am 09. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tracey Clements als Geschäftsführer am 09. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonny Mcquarrie als Geschäftsführer am 09. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Blair als Geschäftsführer am 09. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Steven Blair als Direktor am 17. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Jonny Mcquarrie als Direktor am 17. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERITT, Mark Edward | Sekretär | More London Place SE1 2AF London 1 | British | 204754740001 | ||||||||||
| EVERITT, Mark Edward | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 107529830027 | |||||||||
| WELCH, Robert John | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 212146700001 | |||||||||
| BURROWS, Patrick James | Sekretär | Gardeners Cottage The Lordship SG10 6HN Much Hadham Hertfordshire | British | 86778310001 | ||||||||||
| COWELL, Martin William | Sekretär | 32 Beverston Road Perton WV6 7UG Wolverhampton West Midlands | British | 1614020001 | ||||||||||
| DOLAN, Malcolm George | Sekretär | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | British | 73207060001 | ||||||||||
| DOLAN, Malcolm George | Sekretär | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | British | 73207060001 | ||||||||||
| SANKAR, Nadine Amanda | Sekretär | 90 Ebury Road WD17 2SB Watford | British | 72917320001 | ||||||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||||||
| AGER, Rowley Stuart | Geschäftsführer | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 72555850002 | |||||||||
| BLAIR, Steven | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 239167430001 | |||||||||
| BODDICE, Stephen | Geschäftsführer | Churchill Old Farm Churchill DY10 3LZ Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | 1673770001 | |||||||||
| BURROWS, Patrick James | Geschäftsführer | Gardeners Cottage The Lordship SG10 6HN Much Hadham Hertfordshire | British | 86778310001 | ||||||||||
| CLEMENTS, Tracey | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 198102550001 | |||||||||
| CRELLIN, David | Geschäftsführer | 191 Worcester Road Hagley DY9 0PR Stourbridge West Midlands | British | 31677030002 | ||||||||||
| GIBBONS, Colin Howard | Geschäftsführer | 33 Abbotsmede Close TW1 4RL Twickenham Middlesex | British | 61993880001 | ||||||||||
| GORDON, Timothy Leigh | Geschäftsführer | 2 Sandown Drive Halebarns WA15 0BA Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 2900860001 | |||||||||
| HIGGINSON, Andrew Thomas | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | England | British | 57637410003 | |||||||||
| HOLMES, Colin Peter | Geschäftsführer | 66 Tolmers Road EN6 4JY Cuffley Hertfordshire | United Kingdom | British | 86778500001 | |||||||||
| KING, Andrew Paul | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | England | British | 200246970001 | |||||||||
| LLOYD, Jonathan Mark | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 160028560001 | |||||||||
| MCCARTHY, James John | Geschäftsführer | Broadview House 34 Avenue Road CV37 6UN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 2426350005 | ||||||||||
| MCQUARRIE, Jonny | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 239167420001 | |||||||||
| MOORE, Dean | Geschäftsführer | Bleak House Oaks Road LE67 5UP Whitwick Leicestershire | British | 94541520001 | ||||||||||
| MURRELLS, Steven Geoffrey | Geschäftsführer | Willow Farm Further Street CO10 5LD Assington Suffolk | British | 98194710001 | ||||||||||
| NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms. | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 148079740001 | |||||||||
| O'NEILL, William Patrick | Geschäftsführer | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 106806380001 | ||||||||||
| PENFOLD, Julia | Geschäftsführer | 33 Gurney Drive N2 0DF London | British | 67318640001 | ||||||||||
| REED, Anthony William | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7TS Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 160544960001 | |||||||||
| SMITH, Bryan Robin Geoffrey Gilbert | Geschäftsführer | Queen Annes TN17 1BN Goudhurst Kent | British | 34819420002 | ||||||||||
| SMITH, Richard John | Geschäftsführer | 101 Dropmore Road Burnham SL1 8AY Slough | British | 38475260001 | ||||||||||
| TURNER, David | Geschäftsführer | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 109813430001 | |||||||||
| TURNER, David Richmond | Geschäftsführer | Woodhouse Farm Wyke TF13 6NZ Much Wenlock Salop | England | British | 13374870003 | |||||||||
| WILLIAMS, Mark Benjamin | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 208244710001 | |||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 175259630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesco Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GIBBS NEWSAGENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A guarantee and debenture | Erstellt am 28. Okt. 1997 Geliefert am 04. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the group companies (as defined in the facilities agreement) to (I) each bank (as defined in the facilities agreement) pursuant to the banks' bilateral facilities and/or (ii) to each beneficiary (as defined) pursuant to the senior finance documents (all as defined) | |
Kurze Angaben F/H unit 1,apex road brownhills,west midlands t/no.WM230532;f/h north west side of pelsall road brownhills,west midlands t/no.WM80733;f/h east side of apex road brownhills,west midlands t/no.WM385696.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 1992 Geliefert am 12. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or gibbs news limited on anyaccount whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 ref M638C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge supplemental to a gurantee and debenture dated 15/5/89 | Erstellt am 02. Mai 1991 Geliefert am 21. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany to the chargee as trustee for the banks (as defined in a banking facility agreement dated 15.5.89) pursuant to the terms of the guarantee and debenture and an overdraught letter of even date therewith | |
Kurze Angaben A) by way of legal mortgage 4 limehurst square duston northants b) by way of assignment the benefit to the COMP0ANY of all rights and claims to which the company is or may hereafterbecome entitled in relation to the property (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Feb. 1991 Geliefert am 27. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £28,063,00 being the total amount payable by the company to the chargee pursuantto the term of the agreement | |
Kurze Angaben All right, title and interest in and for all sums payable under the insurance (see form 395 for full detials). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Gurantee & composite trust debenture | Erstellt am 15. Mai 1989 Geliefert am 22. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or surbridge newsagents limited to the chargee under the terms of terms of the charge and/or the bamling facility agreement and/or the overdraft letter. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Feb. 1989 Geliefert am 21. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 33/33A, browns lane, uckfield, east sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Dez. 1988 Geliefert am 16. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 67/69 lustrells vale saltdean brighton east sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Okt. 1988 Geliefert am 22. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 17 and 17A greenwood road, crowthorne, berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Okt. 1988 Geliefert am 22. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Shop number 3, chestnut house, high street, crowthorne, berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Okt. 1988 Geliefert am 20. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 20 burntwood town centre shopping centre, chase terrace, cannock staffordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 16. Aug. 1988 Geliefert am 19. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises situate and k/a 112 whitehorse lane in the london borough of tower hamlets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Apr. 1988 Geliefert am 27. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold premises situate and k/as 65 caledonian chscote tamworth staffordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. März 1988 Geliefert am 17. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises situate and k/a 188 & 190 ferndale road swindon wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. März 1988 Geliefert am 03. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property k/a or being 3 dunsham lane aylesbury buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. März 1988 Geliefert am 03. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property known as 304 and 306 meadowcroft, aylesbury, buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. März 1988 Geliefert am 03. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property k/a flat 4 33 and 33A brownd lane, uckfield sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1988 Geliefert am 15. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property k/as all that lockup shop and maisonette and other buildings k/as 2 and 10 covingham square covingham swindon, wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Jan. 1988 Geliefert am 27. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property known as or being all that lock store containing about 94 sq. Feet at covingham square swindon in the county of wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1988 Geliefert am 22. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leashold premises k/a 493 bromley road dowaham kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Jan. 1988 Geliefert am 22. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Vee house, park industrial estate, hogmors st albans herts, AL2 2DR. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Dez. 1987 Geliefert am 30. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold premises k/a 3 curtis place and 63A high street, kidlington, oxon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Dez. 1987 Geliefert am 30. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold premises k/a 59 and 61A high street kidlington oxfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1987 Geliefert am 24. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold premises k/a 16 market wrytle lane carshalton, surrey SN5 1AG. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Dez. 1987 Geliefert am 30. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold premises k/a shop number 223 and garage no. 11 and flat 237 st marks road tipton staffordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 1987 Geliefert am 18. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold premises k/a 2 alderwood precinct northway dudley west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GIBBS NEWSAGENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0