EUROPRESSINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EUROPRESSINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02162222 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EUROPRESSINGS LIMITED?
- Herstellung von anderen Metallwaren (25990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich EUROPRESSINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROPRESSINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EUROPRESSINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 06. Sept. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sharone Vanessa Gidwani als Geschäftsführer am 31. Juli 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hill House 1 Little New Street London London EC4A 3TR zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 28. Juni 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2021 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Change of details for Precoat Limited as a person with significant control on 08. Apr. 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für British Steel Directors (Nominees) Limited am 01. Apr. 2021 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2020 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2019 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 Millbank London SW1P 4WY zum Hill House 1 Little New Street London London EC4A 3TR am 09. März 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Feb. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EUROPRESSINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH STEEL DIRECTORS (NOMINEES) LIMITED | Geschäftsführer | Grosvenor Place SW1X 7HS London 18 England |
| 57383920004 | ||||||||||
| FORSTER, John Henry Knight | Sekretär | Bumblebee Cottage Grange Lane Hartley Wintney RG27 8HH Hook Hampshire | British | 4772290013 | ||||||||||
| HANNAH, Paul George | Sekretär | 2 Falfield Close Lisvane CF14 0GB Cardiff | British | 6063690001 | ||||||||||
| OSMUNDSEN LITTLE, Claire | Sekretär | 152 Pentre Nicklaus Village Machynys SA15 2DE Llanelli Camarthenshire | British | 87664540002 | ||||||||||
| ROBINSON, Theresa Valerie | Sekretär | 30 Millbank London SW1P 4WY | British | 97191200001 | ||||||||||
| BRENNAN, Lyndon | Geschäftsführer | 19 Grange Crescent CF35 5HP Coychurch Mid Glamorgan | British | 81399650001 | ||||||||||
| FORSTER, John Henry Knight | Geschäftsführer | Bumblebee Cottage Grange Lane Hartley Wintney RG27 8HH Hook Hampshire | British | 4772290013 | ||||||||||
| GIDWANI, Sharone Vanessa | Geschäftsführer | Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham 156 West Midlands | England | British | 174416740001 | |||||||||
| GURNEY, Dilwyn | Geschäftsführer | 4 Laburnum Close Afon Hir Coed Afon Village NP10 9JQ Rogerston Gwent | Wales | British | 32767960004 | |||||||||
| HORROCKS, David John | Geschäftsführer | 119 Manor Way Whitchurch CF4 1RN Cardiff South Glamorgan | British | 7570420001 | ||||||||||
| PHILLIPS, Anthony John | Geschäftsführer | 91 Parc Bryn Derwen CF7 9TW Llanharan Mid Glamorgan | British | 36128950003 | ||||||||||
| PHILLIPS, Stephen John | Geschäftsführer | 24 Kelston Road Whitchurch CF14 2AJ Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 94693390001 | |||||||||
| RIDER, Ronald John | Geschäftsführer | The Old Rectory West Stoke PR19 9BP Chichester West Sussex | England | Canadian | 148666730001 | |||||||||
| SCANDRETT, Allison Leigh | Geschäftsführer | Warren Road Colliers Wood SW19 2HY London 67 | England | British | 1037770001 | |||||||||
| TAYLOR, Ian David | Geschäftsführer | The Cottage 62 Park Street TF11 9BL Shifnal Shropshire | England | British | 87664660001 | |||||||||
| TAYLOR, Ian David | Geschäftsführer | The Cottage 62 Park Street TF11 9BL Shifnal Shropshire | England | British | 87664660001 | |||||||||
| WILLIAMS, David Nicholas Owen | Geschäftsführer | 71 Seabank The Esplanade CF64 3AR Penarth | British | 32721440002 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian Paul | Geschäftsführer | Ridgeway Farm Sailors Lane Thursley GU8 6QP Godalming Surrey | British | 5332700003 | ||||||||||
| WILLIAMS, John Lyndon | Geschäftsführer | 8 Pen Y Pound Court NP7 7RJ Abergavenny Gwent | Wales | British | 33112780001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EUROPRESSINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precoat Limited | 06. Apr. 2016 | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EUROPRESSINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 12. Apr. 2002 Geliefert am 19. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a land at unit c wentloog corporate park wentloog road cardiff. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. März 2001 Geliefert am 17. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. März 2001 Geliefert am 14. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property at unit c wentloog corporation park, wentloog road, cardiff, title number(s) WA631540, WA631543, WA631547 and WA631540. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 27. März 2001 Geliefert am 14. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Pegasus life assurance policy numbered 1024977101. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 2000 Geliefert am 10. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h land k/a unit c wentloog corporate park, wentloog road, cardiff,t/n WA631540, WA631543 and WA631547. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Mai 1997 Geliefert am 30. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a unit c wentloog corporate park wentloog and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 1993 Geliefert am 24. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £154,992.35 and all other monies due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben See schedule to form 395 for full list. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 21. Dez. 1993 Geliefert am 22. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Frame power press, sheet feed, robot and unload equipment and orii robot. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/as land and buildings at wentloog corporate park,wentloog, cardiff,south glamorgan. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 31. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Various components of production line eqipment listed in schedule. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 31. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Various components of production line equipment listed in schedule. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 31. Jan. 1992 Geliefert am 03. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 08. März 1990 Geliefert am 16. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Various machinery, container tilting trucks, stacking pallets, jib crane and pallett racking all as per schedule of goods. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage and charge | Erstellt am 07. Sept. 1989 Geliefert am 07. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Air conditioning system rapid roll door series 660 model 416 mig/8A020 turnover tublc model ytr-70 2 hydrvane compressor serial nos:- 88125HV824002-2 & 88125HV824004-2 2 compair broomwade dryers serial nos G031/0389 G031/0390 and infrared flat bed conveyor oven as Q1710 free-standing powered conveyor 1 used hashford die flipper 1 PP14 part a packer serial no:- pp/1/557/1/m. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage & charge | Erstellt am 14. Apr. 1988 Geliefert am 14. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 4 x aida hy-flex press model NC2-160 (2) including die cushion & 4 x main motor reversing serial nos. 10516-1231, 10516-1232, 10516-1233 & 10516-1236. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 01. Dez. 1987 Geliefert am 09. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EUROPRESSINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0