RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED

RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02164530
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED?

    • (7011) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Po Box 730
    20 Farringdon Street
    EC4A 4PP London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DELIGHTED (1994) ONE LIMITED28. Okt. 199428. Okt. 1994
    POWER TROCADERO LIMITED24. Juni 199224. Juni 1992
    WALKER POWER CORPORATION LIMITED20. Jan. 198820. Jan. 1988
    BRENT WALKER PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED12. Nov. 198712. Nov. 1987
    CATERFRONT LIMITED15. Sept. 198715. Sept. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 1990

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    1 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    1 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    1 SeitenRM02

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    4 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    4 Seiten3.6

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed delighted (1994) one LIMITED\certificate issued on 16/03/95
    4 SeitenCERTNM

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    4 Seiten3.6

    Eine Auswahl von Hypothekenurkunden, die vor dem 1. Januar 1995 registriert wurden

    186 SeitenPRE95M

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed power trocadero LIMITED\certificate issued on 28/10/94
    SeitenCERTNM

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed\certificate issued on 27/10/94
    2 SeitenCERTNM

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    4 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    Seiten3.6

    legacy

    4 Seiten405(1)

    legacy

    Seiten405(1)

    Wer sind die Geschäftsführer von RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Sekretär
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    RUSKIN, John Brian
    14 St Georges Road
    N13 4AS London
    Sekretär
    14 St Georges Road
    N13 4AS London
    British47549770001
    LEONARD, John Anthony
    105 The Rise
    IRISH Mount Merrion
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    105 The Rise
    IRISH Mount Merrion
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish15503910001
    POWER, Robert Raphael
    8 Sorrento Terrace
    Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    8 Sorrento Terrace
    Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Irish10060850001
    RUSKIN, John Brian
    14 St Georges Road
    N13 4AS London
    Geschäftsführer
    14 St Georges Road
    N13 4AS London
    British47549770001
    QUINLAN, Timothy Edward
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    EnglandBritish49553030001
    WALKER, George Alfred
    68 Pallmall
    SW1Y 5NG London
    Geschäftsführer
    68 Pallmall
    SW1Y 5NG London
    British349000001

    Hat RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over credit balances
    Erstellt am 29. Sept. 1993
    Geliefert am 11. Okt. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from power trocadero holdings limited to the chargee under the terms of the facility letter of even date
    Kurze Angaben
    £1,790,000 together with interest accrued to be held by the bank on treasury reserve account no. 7803826 and earmarked or designated by reference to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 17. März 1992
    Geliefert am 25. März 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The site of the premises k/a the trocadero centre and vernon house which is bounded by shaftesbury avenue great windmill street coventry street and rupert street london W1 comprised in the following title numbers: NGL83767; 143699; 347972; and LN120447 (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment
    Erstellt am 17. März 1992
    Geliefert am 25. März 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The right to receive and the full benefit of the aggregate of the gross rents licence fees and other moneys reserved or arising out of all leases etc.. (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Aug. 1994Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    Deposit agreement
    Erstellt am 17. März 1992
    Geliefert am 25. März 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights to the repayment of the debt or debts owing to the company in the account(s) with the bank at its treasury division in the name of the bank designated lloyds bank PLC re: island receipts (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 17. März 1992
    Geliefert am 25. März 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the premises k/a the trocadero centre and vernon house which is bounded by shaftesbury avenue great windmill street coventry street and rupert street london W1 comprised in the following title numbers: NGL83767; 143699; 347972; and LN120447 (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Aug. 1994Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 311. Juli 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 3
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. März 1991
    Geliefert am 22. März 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all other companies named therein to the chargee. Under the terms of the mortgage and any other security document (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Part of the basement area beneath great windmill street, london W1 (see form 395 full details).
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank, Limitedas Security Agent
    Transaktionen
    • 22. März 1991Registrierung einer Belastung
    Sub-mortgage
    Erstellt am 07. Dez. 1990
    Geliefert am 11. Dez. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The mortgage dated 4/12/90 securing a mortgage debt upon f/h 41/43 wardar street london W1 title no. Ngl 83768 the benefit of a deed of priorities dated 4 december 1990 (see form 395 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 18. Apr. 1990
    Geliefert am 19. Apr. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. Aug. 1994Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 111. Juli 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Mortgage
    Erstellt am 18. Apr. 1990
    Geliefert am 19. Apr. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property k/a or being the island site at shaffesbury avenue, rupert street, coventry street and wardour street, london W1. By way of assignment the goodwill of the business. (See form 395 for full details of property charged).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. Aug. 1994Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 18. März 1998Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
    • 211. Juli 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 2
    Debenture
    Erstellt am 09. Apr. 1990
    Geliefert am 26. Apr. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and walker power corporation (cinema) limited, walker power corporation (offices) limited and walker power corporation holdings limited as defined in the deficiency guarantee of even date or any of the security documents and under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    (See form 395 for further details of property charged). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Pils Trocadero Limited
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    Cash collateral security
    Erstellt am 09. Apr. 1990
    Geliefert am 25. Apr. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the deficiency guarantee dated 9TH april 1990 and other documents (as defined)
    Kurze Angaben
    First fixed charge all monies now or at any time hereafter standing to the credit of a deposit account with the bank.(savings account no. 105997). (see form 395. rec M261 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank(To Whom All Rights of the Beneficiary Have Been Assigned).
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Jan. 1993Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 03. Apr. 1995Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
      • Aktenzeichen 5
    Performance bond charge.
    Erstellt am 09. Apr. 1990
    Geliefert am 25. Apr. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the deficiency guarantee dated 9TH april 1990 and other documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All the right title of the company in and to three performance bonds. (See form 395. rec M264 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank(To Whom All Rights of the Beneficiary Have Been Assigned).
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 16. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the banks (as defined) under the terms of a facility letter dated 27TH july 1988.
    Kurze Angaben
    By way of first specific charge the debt constituted by the balance standing to the credit of the deposit account by way of first floating charge, all the specifically charged assets (as defined in the charge). (See form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    Cap agreement security
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 12. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and as trustee for the beneficiaries (as defined) under the terms of the loan facility agreement dated 29/12/89 and under the terms of the charge or any other finance documents
    Kurze Angaben
    All monies received by the borrower pursuant to a cap agreement which provides for certain payments to be paid in respect of an amount equal to sterling pounds 170,000,000 being the term loan advance under the facility agreement so that the interest payable on that advance is capped (see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank, Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    Cash collateral security
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 12. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and as trustee for the beneficiaries (as defined) under the terms of the loan facility agreement dated 29/12/89 and under the terms of the charge or any other finance documents
    Kurze Angaben
    First fixed charge all monies now or at any time standing to the credit of a deposit account being the account in the name of the company no: 85694 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank, Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    Performance bond assignment
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 12. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and walker power corporation holdings limited to the chargee. As security agent and as trustee for the beneficiaries (as defined) under the terms of the loan facility agreement dated 29/12/89 and under the terms of the charge or any other finance documents
    Kurze Angaben
    All the right title of the borower in and to three performance bonds each dated 30/11/89 issued by norwich union fire insurance society limited, g & t crampton (holdings) PLC and g & t crampton (N.i) limited in fauour of the borrower in the sums of sterling pounds 958,350.00, sterling pounds 107,942.50 and sterling pounds 1,083,895.00.
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank, Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 11. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and walker power corporation holdings limited to the chargee. Under the terms of the loan facility agreement dated 29.12.89 and under the terms of the charge or any other finance documents
    Kurze Angaben
    By way of charge (which so far as it relates to land vested in the borrower at the date of the debenture shall be a charge by way of legal mortgage) (see form 395 for full details of the property) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank Limitedas Security Agent and as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    Assignment of contract
    Erstellt am 05. Dez. 1989
    Geliefert am 21. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 27TH july 1988.
    Kurze Angaben
    The benefit of a jct standard form of contract private with approximate quantities (1980 edition as amended) dated 17TH august 1989 in the contract sum of sterling pounds 9,583,500.00.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank(Acting as Agent for a Syndicate of Banks).
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    Assignment of contract
    Erstellt am 05. Dez. 1989
    Geliefert am 21. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 27TH july 1988.
    Kurze Angaben
    The benefit of a jct standard form of contract private with approximate quantities. (1980 edition as amended) dated 17TH august 1989 in the contract sum of sterling pounds 10,838,950.00.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank(Acting as Agent for a Syndicate of Banks)
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    Assignment of contract
    Erstellt am 05. Dez. 1989
    Geliefert am 21. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 27TH july 1988.
    Kurze Angaben
    The benefit of a jct standard form of contract private with approximate quantities (1980 edition as amended) dated 17TH august 1989 in the contract sum of sterling pounds 1,079,425.00.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank(Acting as Agent for a Syndicate of Banks)
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 05. Dez. 1989
    Geliefert am 20. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks under the terms of a facility agrement
    Kurze Angaben
    The benefit of a bond in the sum of sterling pounds 1,083,895 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standrad Chartered Bank
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 05. Dez. 1989
    Geliefert am 20. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks under the terms of a facility agreement
    Kurze Angaben
    The benefit of a bond in the sum of sterling pounds 107,942.50 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 05. Dez. 1989
    Geliefert am 20. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee agent for the banks under the terms of a facility agreement
    Kurze Angaben
    The benefit of a bond in the sum of sterling pounds 958,350 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    Undertaking assignment
    Erstellt am 27. Juli 1988
    Geliefert am 09. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and/or any of the banks under the terms of the facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    Sterling pounds 2,5000,000 loaned to the company by power corporation PLC (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 09. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 1988
    Geliefert am 09. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and/or any of the banks under the terms of the facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    F/H property at shaftesbury avenue, wardour street coventry street and great windmill street title no's ngl 83767, 143699 347972, ln 120447, ln 207133, ngl 83768 226192 (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 09. Aug. 1988Registrierung einer Belastung

    Hat RUPERT STREET INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. März 1992Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Francis Jeffery
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Praktiker
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Christopher Timothy Esmond Hayward
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    Praktiker
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    2
    DatumTyp
    17. März 1992Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Francis Jeffery
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Praktiker
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Christopher Timothy Esmond Hayward
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    Praktiker
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    3
    DatumTyp
    18. Apr. 1990Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Francis Jeffery
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Praktiker
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Christopher Timothy Esmond Hayward
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    Praktiker
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    4
    DatumTyp
    18. Apr. 1990Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Francis Jeffery
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Praktiker
    Kpmg
    Po Box 730
    EC4A 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Christopher Timothy Esmond Hayward
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    Praktiker
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    5
    DatumTyp
    09. Apr. 1990Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Timothy Esmond Hayward
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    Praktiker
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    Philip Wedgwood Wallace
    P.O.Box 730
    20 Farringdon Street
    EC4A 4PP London
    Praktiker
    P.O.Box 730
    20 Farringdon Street
    EC4A 4PP London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0