CARE ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCARE ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02164665
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CARE ESTATES LIMITED?

    • (5510) /

    Wo befindet sich CARE ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Rivergate Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARE ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für CARE ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Sept. 2016

    55 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 26. Sept. 2016

    55 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2016

    55 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Feb. 2016

    42 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2015

    51 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    7 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2015

    51 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    55 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2014

    55 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2014

    56 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2013

    66 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2012

    63 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2013

    64 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. März 2012

    69 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Sept. 2011

    65 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Mai 2011

    67 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Derek Purvis als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Gate House Avonpark Village Winsley Hill Limpley Stoke Bath BA2 7NU* am 24. Jan. 2011

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Wer sind die Geschäftsführer von CARE ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURGESS, Anthony John
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant43144030004
    BURGESS, Anthony John
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant43144030004
    COOPER, Hudson Findlay
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    United KingdomSouth AfricanDirector33695190004
    HALL, Sally Janet
    Lakeside
    Chapel Road Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Sekretär
    Lakeside
    Chapel Road Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    BritishAccounts Administrator36750830002
    PURVIS, Derek
    18 Tavinor Drive
    Pewsham
    SN15 3FU Chippenham
    Wiltshire
    Sekretär
    18 Tavinor Drive
    Pewsham
    SN15 3FU Chippenham
    Wiltshire
    British74444890001
    M & N SECRETARIES LIMITED
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    Sekretär
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    74919560014
    M & N SECRETARIES LIMITED
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    Bevollmächtigter Sekretär
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    900001060001
    COOPER, James Findlay
    5 Lower Street
    Rode
    BA11 6PU Frome
    Brooklea
    Somerset
    Geschäftsführer
    5 Lower Street
    Rode
    BA11 6PU Frome
    Brooklea
    Somerset
    United KingdomBritishCare Homes129881120001
    HARPER, Catherine Denise
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    BritishNursing Home Director44904500006
    MARCHANT, Keith George
    39 Higham Lane
    TN10 4JE Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    39 Higham Lane
    TN10 4JE Tonbridge
    Kent
    BritishDirector1637780001

    Hat CARE ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as land forming part of winsley sanitorium winsley title number WT79461. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Shares mortgage
    Erstellt am 04. Apr. 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) the original securities (ii) the additional securities, and (iii) all related rights in respect of the original securities and the additional securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 1996
    Geliefert am 18. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party deed of charge over securities
    Erstellt am 30. Juni 1994
    Geliefert am 12. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from beam hazel limited,avonpark care centre limited,avonpark retirement centre limited the company or any other person who is a party to any related security document to the chargee under or pursuant to the terms of the facility agreements the charge or any related security document or on any account whatsoever.(all definitions as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge over all the company`s present and future rights title and interest in and to: all the ordinary shares of £1.00 each in avonpark estates management limited together with all other shares issued by aeml that constitute the issued share capital of aeml now or from time to time held by the company and being at the date hereof 2 ordinary shares of £1.00 each legally and beneficially owned by the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juli 1990
    Geliefert am 26. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Winsley sanatorium winsley in the county of wilts, title no wt 79461 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 17. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1990
    Geliefert am 26. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First floating charge over the undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 17. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Sept. 1988
    Geliefert am 06. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all that f/h property k/a winsley sanatorium winsley, wiltshire & all buildings trade fixtures fixed plant & machinery floating charge over the undertaking and all property and assets present and future (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Kleinwort Benson Limited
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1988Registrierung einer Belastung

    Hat CARE ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Nov. 2010Beginn der Verwaltung
    26. Sept. 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Praktiker
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Robin David Allen
    3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Praktiker
    3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0