FRESHERS FOODS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FRESHERS FOODS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02168745 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FRESHERS FOODS LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g. (10890) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich FRESHERS FOODS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 38 Barnard Road Bowthorpe Employment Area NR5 9JP Norwich Norfolk England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FRESHERS FOODS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
FRESHER FOODS LIMITED | 30. Okt. 1987 | 30. Okt. 1987 |
FOXVINE LIMITED | 24. Sept. 1987 | 24. Sept. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRESHERS FOODS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FRESHERS FOODS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Kevin Raymond George Moore als Direktor am 15. Juni 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Christopher Ainsworth als Geschäftsführer am 05. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Apr. 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Lee Anthony Nicholls als Direktor am 01. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Lindsey Moses-Roberts als Direktor am 01. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ashley James Hicks als Geschäftsführer am 01. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew David Driscoll als Geschäftsführer am 31. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 25. Juli 2022
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 18 Seiten | MA | ||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2021 bis 31. März 2022 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Katherine Susan Atkinson als Sekretär am 04. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Ashley Hicks als Direktor am 04. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FRESHERS FOODS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKINSON, Katherine Susan | Sekretär | Barnard Road Bowthorpe NR5 9JP Norwich 38 England | 288050550001 | |||||||
MOORE, Kevin Raymond George | Geschäftsführer | Barnard Road Bowthorpe Employment Area NR5 9JP Norwich 38 Norfolk England | England | British | Chief Executive | 198183020001 | ||||
MOSES-ROBERTS, Lindsey | Geschäftsführer | Barnard Road Bowthorpe Employment Area NR5 9JP Norwich 38 Norfolk England | England | British | Finance Director | 307753300001 | ||||
NICHOLLS, Lee Anthony | Geschäftsführer | Barnard Road Bowthorpe Employment Area NR5 9JP Norwich 38 Norfolk England | England | British | Director | 290701300001 | ||||
HAVES, Anthony Jonathon | Sekretär | 34 Belmont Road Adlington PR6 9PU Chorley Lancashire | British | Sales & Marketing Director | 68457270002 | |||||
OPENSHAW, David William | Sekretär | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | British | 41964180001 | ||||||
OPENSHAW, Elizabeth Claire | Sekretär | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | 285294200001 | |||||||
OPENSHAW, Elizabeth Claire | Sekretär | 27 Oakley Park BL1 5XL Bolton Lancashire | British | 20575940001 | ||||||
AINSWORTH, Ian Christopher | Geschäftsführer | Barnard Road Bowthorpe NR5 9JP Norwich 38 England | England | British | Director | 89999680001 | ||||
BARNES, Alan | Geschäftsführer | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | United Kingdom | British | Sales Director | 126807310001 | ||||
CAMPION, David Bardsley | Geschäftsführer | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 9623060001 | ||||
DRISCOLL, Andrew David | Geschäftsführer | Barnard Road Bowthorpe NR5 9JP Norwich 38 United Kingdom | England | British | Director | 108719780003 | ||||
DRIVER, Adam Steven | Geschäftsführer | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | England | British | Engineer | 236385600001 | ||||
HICKS, Ashley James | Geschäftsführer | Barnard Road Bowthorpe NR5 9JP Norwich 38 United Kingdom | England | British | Director | 205792380001 | ||||
KEARNS, Jonathan Charles Anthony | Geschäftsführer | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | United Kingdom | British | Production Director | 126807230001 | ||||
OPENSHAW, David William | Geschäftsführer | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | England | British | Director | 41964180001 | ||||
OPENSHAW, Elizabeth Claire | Geschäftsführer | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | England | British | Company Director | 20575940001 | ||||
OPENSHAW, Elizabeth Claire | Geschäftsführer | 27 Oakley Park BL1 5XL Bolton Lancashire | England | British | Director | 20575940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FRESHERS FOODS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowse Honey Limited | 04. Okt. 2021 | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mrs Elizabeth Claire Openshaw | 06. Apr. 2016 | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr David William Openshaw | 06. Apr. 2016 | Leigh Street Wigan WN1 3BE Lancashire | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat FRESHERS FOODS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 17. Mai 2013 Geliefert am 22. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings at richard street wigan t/n GM810745 GM536484 GM129204 GM233381 amd MAN58164. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Mai 2013 Geliefert am 20. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of fixed charge the following property of the company owned now or in the future:-. (I) all fixed charge debts; and. (Ii) the related rights of all fixed charge debts.. Note: the charge contains covenants by the company that the company will not without the rbsif's consent:-. (A) permit or create any mortgage, charge or lien on the property; and. (B) dispose of the property charged by clause 1 of the charge.. Definitions:. "Company's obligations" - all the company's liabilities to rbsif of any kind and in any currency (whether present or future actual or contingent and whether incurred alone or jointly with another) together with rbsif's charges and commission interest and expenses. "Debt purchase agreement" - any debt purchase facility between rbsif and the company. "Debts" - has the meaning given to that expression in any debt purchase agreement. "Expenses" - all expenses (on a full indemnity basis) incurred by rbsif or any receiver at any time in connection with the property or the company's obligations or in taking or perfecting this deed or in preserving defending or enforcing the security created by this deed or in exercising any power under this deed or otherwise with interest from the date they are incurred. "Fixed charge debts" - all debts which fail to vest in rbsif under any debt purchase agreement. "Interest" - interest at the same rate as the discounting charge charged to the company by rbsif from time to time. "Property" - the whole and any part of the undertaking property and assets of the company charged by clause 1 of the charge. "Related rights" - has the meaning given to that expression in any debt purchase agreement. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Mai 2013 Geliefert am 15. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 24. Apr. 2007 Geliefert am 01. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The equipment k/a nenos 2000 stainless steel hopper feed additive dispenser, serial no: 1775276 with vibrating feeder and electronic unit, stainless steel rotary tumbler, full PLC control for further equipment charged please refer to the form 395 and assigns all policies of insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 15. Aug. 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Nenos 2000 stainless steel hopper feed additive dispenser s/no: 1775276 with vibrating feeder and electronic unit stainless steel rotary tumbler full PLC control prewa vertical form fill & seal machine fitted with registration and date coder cintex compact product x-ray inspection system s/no: 0160 (2002) for details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Nov. 2003 Geliefert am 05. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 06. Okt. 2003 Geliefert am 08. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold and leasehold property known as land and buildings on the east side of leigh street wigan t/n GM727942 and t/n GM171424. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 21. Aug. 2003 Geliefert am 22. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant and machinery and things being one GV2K2 vert form fill seal machine s/no. GVO31227, one yamato multihead computer weigher alpha series s/no O3O279 or any part thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 19. Apr. 1996 Geliefert am 07. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 1996 Geliefert am 07. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h & l/h property abutting leigh street wigan t/no GM171424 GM171423 GM670039 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 1996 Geliefert am 24. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at leigh street, wigan t/nos: GM171424, GM171423 (part) and GM670039 (part). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 13. März 1995 Geliefert am 17. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over book debts | Erstellt am 30. Nov. 1994 Geliefert am 09. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a financing agreement and all other monies due on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due owing or incurred to the company other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such fixed charge.floating charge all the book debts and other debts of the company which are not charged by way of fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 15. Sept. 1994 Geliefert am 22. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ishida 10 head electronic weighing unit complete model ccw 201 lc (1985) continuous stainless steel fryer comprising: 1 bond. 1 mcinnes wise. 1 support frame and others listed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Nov. 1989 Geliefert am 05. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 29. Jan. 1988 Geliefert am 09. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0