APPER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAPPER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02169460
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von APPER LIMITED?

    • (5142) /
    • (5243) /

    Wo befindet sich APPER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Amstrong Watson Central Houise 47
    St. Pauls Street
    LS1 2TE Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von APPER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SHELLY'S SHOES LIMITED25. Sept. 198725. Sept. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von APPER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Feb. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für APPER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Jan. 2010

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Stylo House Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 0NW am 19. Jan. 2010

    2 SeitenAD01

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Feb. 2008

    17 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed shelly's shoes LIMITED\certificate issued on 25/03/08
    2 SeitenCERTNM

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 03. Feb. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Jan. 2006

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Jan. 2005

    18 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von APPER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ZIFF, Michael Anthony
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish9804810001
    STYLO PLC
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Stylo House
    Geschäftsführer
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Stylo House
    134666020001
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    Boothstown Drive
    Worsley
    M28 1UF Manchester
    18
    Sekretär
    Boothstown Drive
    Worsley
    M28 1UF Manchester
    18
    British139073520001
    ROBBINS, Sheldon Brian
    Cowcroft Farm
    Tylers Hill Road Leyhill
    HP5 3QS Chesham
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Cowcroft Farm
    Tylers Hill Road Leyhill
    HP5 3QS Chesham
    Buckinghamshire
    British15087400002
    YATES, John Martyn
    558 Newchurch Road
    Higher Cloughfold
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    Sekretär
    558 Newchurch Road
    Higher Cloughfold
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    British67469560001
    BOTT, Richard Phillip
    24 Ridgeway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JA Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Ridgeway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JA Leeds
    Yorkshire
    UkBritish43649330001
    CARR, Victoria Mary
    4 Huntingd Street
    Islington
    N1 1PU London
    Geschäftsführer
    4 Huntingd Street
    Islington
    N1 1PU London
    British43960180001
    CHAUDHRY, Mohammad Suleman
    12 Carters Ride
    Stoke Mandeville
    HP22 5YJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    12 Carters Ride
    Stoke Mandeville
    HP22 5YJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British67163270002
    FELTHAM, Heather Mary
    2 Allmains Close
    Nazeing
    EN9 2LX Waltham Abbey
    Essex
    Geschäftsführer
    2 Allmains Close
    Nazeing
    EN9 2LX Waltham Abbey
    Essex
    British71079130001
    JAVAID, Ali
    17 Valley Drive
    Kingsbury
    NW9 9NJ London
    Geschäftsführer
    17 Valley Drive
    Kingsbury
    NW9 9NJ London
    British15087410001
    LILLEY, Averil
    Leslie Lodge
    Billetlane
    SLO 0LT Iverheath
    Bucks
    Geschäftsführer
    Leslie Lodge
    Billetlane
    SLO 0LT Iverheath
    Bucks
    British15087370002
    MILLING, Judith Sarah Ruth
    22 Gainsborough Road
    North Finchley
    N12 8AG London
    Geschäftsführer
    22 Gainsborough Road
    North Finchley
    N12 8AG London
    United KingdomBritish94367740001
    PATRICK, David Stephen
    10 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    EnglandBritish94274510001
    REED, Peter Edward
    62 Tanfield Lane
    NN1 5RN Northampton
    Geschäftsführer
    62 Tanfield Lane
    NN1 5RN Northampton
    British50319830002
    ROBBINS, Margery
    Willow Hill The Clump
    Chorley Wood
    WD3 4BQ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Willow Hill The Clump
    Chorley Wood
    WD3 4BQ Rickmansworth
    Hertfordshire
    British15087380001
    ROBBINS, Ralph
    Willow Hill The Clump
    Chorley Wood
    WD3 4BQ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Willow Hill The Clump
    Chorley Wood
    WD3 4BQ Rickmansworth
    Hertfordshire
    British15087390001
    ROBBINS, Sheldon Brian
    Cowcroft Farm
    Tylers Hill Road Leyhill
    HP5 3QS Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Cowcroft Farm
    Tylers Hill Road Leyhill
    HP5 3QS Chesham
    Buckinghamshire
    British15087400002
    STARK, Ron Arthur
    Near Woodside Farm
    Skipton Road
    BD20 9AB Kildwick
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Near Woodside Farm
    Skipton Road
    BD20 9AB Kildwick
    North Yorkshire
    EnglandBritish167929430001
    WEAVING, John Martin
    Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    15
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    15
    West Yorkshire
    EnglandBritish137729810001
    WHYMAN, Jeremy James
    211 Albert Road
    N22 7AQ London
    Geschäftsführer
    211 Albert Road
    N22 7AQ London
    British71079240001

    Hat APPER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5TH april 1993
    Erstellt am 08. Aug. 2005
    Geliefert am 11. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Mai 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 2002
    Geliefert am 06. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as or being the basement ground mezzanine first and second floors at spirella house 266-270 regent street and 249 oxford street london with title number NGL701391. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2002
    Geliefert am 06. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. März 2001
    Geliefert am 07. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £52,875 (including £7,875 provision for vat not yet due) due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The account being an interest earning deposit account opened or to be opened by the mortgagee in the joint names of the mortgagee and the chargor at the royal bank of scotland PLC in the initial amount £52,875.
    Berechtigte Personen
    • Scottish Mutual Assurance PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deposit deed for the execution of works
    Erstellt am 30. März 2001
    Geliefert am 07. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £49,350 (including £7,350 vat not yet due) due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The account being an interest earning deposit account opened or to be opened by the mortgagee in the joint names of the mortgagee and the chargor at the royal bank of scotland PLC in the initial amount £49,350.
    Berechtigte Personen
    • Scottish Mutual Assurance PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat APPER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Jan. 2010Beginn der Liquidation
    24. Apr. 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Christian Kienlen
    Armstrong Watson
    Central House
    LS1 2TE 47 St Paul'S Street
    Leeds
    Praktiker
    Armstrong Watson
    Central House
    LS1 2TE 47 St Paul'S Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0