APPER LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | APPER LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02169460 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von APPER LIMITED?
- (5142) /
- (5243) /
Wo befindet sich APPER LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Amstrong Watson Central Houise 47 St. Pauls Street LS1 2TE Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von APPER LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHELLY'S SHOES LIMITED | 25. Sept. 1987 | 25. Sept. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von APPER LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Feb. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für APPER LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 3 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Stylo House Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 0NW am 19. Jan. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Feb. 2008 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed shelly's shoes LIMITED\certificate issued on 25/03/08 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 03. Feb. 2007 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Jan. 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Jan. 2005 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von APPER LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangeh örigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIFF, Michael Anthony | Geschäftsführer | Lake House 12 Lakeland Drive LS17 7PH Leeds West Yorkshire | England | British | 9804810001 | |||||
| STYLO PLC | Geschäftsführer | Harrogate Road Apperley Bridge BD10 0NW Bradford Stylo House | 134666020001 | |||||||
| MCGOOKIN, Ann Elizabeth | Sekretär | Boothstown Drive Worsley M28 1UF Manchester 18 | British | 139073520001 | ||||||
| ROBBINS, Sheldon Brian | Sekretär | Cowcroft Farm Tylers Hill Road Leyhill HP5 3QS Chesham Buckinghamshire | British | 15087400002 | ||||||
| YATES, John Martyn | Sekretär | 558 Newchurch Road Higher Cloughfold BB4 7TN Rossendale Lancashire | British | 67469560001 | ||||||
| BOTT, Richard Phillip | Geschäftsführer | 24 Ridgeway Tranmere Park Guiseley LS20 8JA Leeds Yorkshire | Uk | British | 43649330001 | |||||
| CARR, Victoria Mary | Geschäftsführer | 4 Huntingd Street Islington N1 1PU London | British | 43960180001 | ||||||
| CHAUDHRY, Mohammad Suleman | Geschäftsführer | 12 Carters Ride Stoke Mandeville HP22 5YJ Aylesbury Buckinghamshire | British | 67163270002 | ||||||
| FELTHAM, Heather Mary | Geschäftsführer | 2 Allmains Close Nazeing EN9 2LX Waltham Abbey Essex | British | 71079130001 | ||||||
| JAVAID, Ali | Geschäftsführer | 17 Valley Drive Kingsbury NW9 9NJ London | British | 15087410001 | ||||||
| LILLEY, Averil | Geschäftsführer | Leslie Lodge Billetlane SLO 0LT Iverheath Bucks | British | 15087370002 | ||||||
| MILLING, Judith Sarah Ruth | Geschäftsführer | 22 Gainsborough Road North Finchley N12 8AG London | United Kingdom | British | 94367740001 | |||||
| PATRICK, David Stephen | Geschäftsführer | 10 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | England | British | 94274510001 | |||||
| REED, Peter Edward | Geschäftsführer | 62 Tanfield Lane NN1 5RN Northampton | British | 50319830002 | ||||||
| ROBBINS, Margery | Geschäftsführer | Willow Hill The Clump Chorley Wood WD3 4BQ Rickmansworth Hertfordshire | British | 15087380001 | ||||||
| ROBBINS, Ralph | Geschäftsführer | Willow Hill The Clump Chorley Wood WD3 4BQ Rickmansworth Hertfordshire | British | 15087390001 | ||||||
| ROBBINS, Sheldon Brian | Geschäftsführer | Cowcroft Farm Tylers Hill Road Leyhill HP5 3QS Chesham Buckinghamshire | British | 15087400002 | ||||||
| STARK, Ron Arthur | Geschäftsführer | Near Woodside Farm Skipton Road BD20 9AB Kildwick North Yorkshire | England | British | 167929430001 | |||||
| WEAVING, John Martin | Geschäftsführer | Breary Lane East Bramhope LS16 9BH Leeds 15 West Yorkshire | England | British | 137729810001 | |||||
| WHYMAN, Jeremy James | Geschäftsführer | 211 Albert Road N22 7AQ London | British | 71079240001 |
Hat APPER LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5TH april 1993 | Erstellt am 08. Aug. 2005 Geliefert am 11. Aug. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Mai 2003 Geliefert am 06. Juni 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Okt. 2002 Geliefert am 06. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property known as or being the basement ground mezzanine first and second floors at spirella house 266-270 regent street and 249 oxford street london with title number NGL701391. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 2002 Geliefert am 06. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 30. März 2001 Geliefert am 07. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £52,875 (including £7,875 provision for vat not yet due) due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The account being an interest earning deposit account opened or to be opened by the mortgagee in the joint names of the mortgagee and the chargor at the royal bank of scotland PLC in the initial amount £52,875. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed for the execution of works | Erstellt am 30. März 2001 Geliefert am 07. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £49,350 (including £7,350 vat not yet due) due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The account being an interest earning deposit account opened or to be opened by the mortgagee in the joint names of the mortgagee and the chargor at the royal bank of scotland PLC in the initial amount £49,350. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat APPER LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0