EUROCUT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EUROCUT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02172710 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EUROCUT LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich EUROCUT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | HAWSONS Pegasus House 463a Glossop Road S10 2QD Sheffield South Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROCUT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EUROCUT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Mason als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(287) | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 155(6)a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EUROCUT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Felicity Ann | Sekretär | 212 Derbyshire Lane S8 8SE Sheffield South Yorkshire | British | 126805180001 | ||||||
| EARL, Stanley Rylatt | Sekretär | 2 Stockwell Road HG5 0JN Knaresborough North Yorkshire | British | 2212840001 | ||||||
| MANNING, Michael Atkinson | Sekretär | 67 Postern Close YO23 1JF York North Yorkshire | British | 20393860001 | ||||||
| MASON, Mike | Sekretär | 3 Malting Close Robin Hood WF3 3AN Wakefield West Yorkshire | British | 102494410001 | ||||||
| RYLETT, Colin Lee | Sekretär | 8 Copper Beech Close Beighton S20 1HD Sheffield South Yorkshire | British | 70442720002 | ||||||
| WESTWOOD, Stephen | Sekretär | 2 Devonshire Close Dore S17 3NX Sheffield | British | 7264410001 | ||||||
| BENNETT, Raymond Allen | Geschäftsführer | 8 Baldersdale Avenue HG5 0HH Knaresborough North Yorkshire | England | British | 116142920001 | |||||
| KEMP, Gerard Alan | Geschäftsführer | Mill Farm Alne YO6 2JE York Yorkshire | England | British | 2212860001 | |||||
| MASON, Michael | Geschäftsführer | 3 Malting Close Robin Hood WF3 3AN Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 111015690001 | |||||
| MCGRATH, Elaine | Geschäftsführer | 3 Cannon Hall Drive Clifton HD6 4JR Brighouse West Yorkshire | British | 22037770001 | ||||||
| MCGRATH, Sean Francis | Geschäftsführer | 3 Cannon Hall Drive Clifton HD6 4JR Brighouse West Yorkshire | British | 18633970001 | ||||||
| MILLER, Christopher Hugh | Geschäftsführer | 2 Rushcliffe Avenue Radcliffe On Trent NG12 2AF Nottingham | England | British | 8071340001 | |||||
| OGDEN, Gary Miles | Geschäftsführer | 2 Fountain Court Rossington DN11 0FS Doncaster South Yorkshire | England | English | 48377660003 | |||||
| RYLETT, Colin Lee | Geschäftsführer | 8 Copper Beech Close Beighton S20 1HD Sheffield South Yorkshire | British | 70442720002 | ||||||
| SHAW, Stephen Martin | Geschäftsführer | 13 Wollaton Road S17 4LD Sheffield South Yorkshire | England | British | 78291310001 | |||||
| STAMP, Kevin | Geschäftsführer | 57 Greenhead Gardens Chapeltown S35 1AR Sheffield South Yorkshire | British | 69912990001 | ||||||
| TOWNSEND, Ian | Geschäftsführer | Homelands Upper Dunsforth YO26 9RU Great Ouseburn York | United Kingdom | British | 26617400002 |
Hat EUROCUT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge document | Erstellt am 12. Feb. 2008 Geliefert am 29. Feb. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £17,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The plant and machinery detailed in schedule one of the loan agreement and attached to the charge documentation between the medical houes PLC and eurocut limited dated 12TH feb 2008. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Loan agreement | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 07. Feb. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £50,000 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben All rights over the plant machinery and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2007 Geliefert am 09. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £2,901,188.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben The factory and warehouse premises at 201 newhall road, sheffield and the whitehouse building, liverpool street, sheffi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 13. Sept. 2006 Geliefert am 22. Sept. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The equipment jones and shipman cylindrical grinder with digital readouts s/no 22000BO73989 model 1076E14 dtm rapid prototyping machine s/no 139181.33GO1011530 model sinerstation 2500 plus - with laser upgrade bridgeport vertical centre cnc s/no 601532531122 model VMC6009 (for details of further chattels charged please refer to the form 395 to) together with all replacements and all right title interest and benefit in and to any warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Aug. 2004 Geliefert am 28. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 03. Apr. 2003 Geliefert am 05. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £400,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Schutte N50 cnc 3 y grinder series 51 NO23 (1993), schutte wu 400 cnc 4 axis tool grinder series 07 NO04 (1993), schutte cnc 5 axis machine series 08 NO06 (1994) (please refer to form 395 for further details). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Jan. 1995 Geliefert am 03. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 12. Jan. 1988 Geliefert am 20. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0