EUROCUT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEUROCUT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02172710
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EUROCUT LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich EUROCUT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    HAWSONS
    Pegasus House 463a Glossop Road
    S10 2QD Sheffield
    South Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROCUT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für EUROCUT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Beendigung der Bestellung von Michael Mason als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Feb. 2010

    Kapitalaufstellung am 02. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 70,500
    SH01

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    17 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(287)

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    9 Seiten155(6)a

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    Wer sind die Geschäftsführer von EUROCUT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRADLEY, Felicity Ann
    212 Derbyshire Lane
    S8 8SE Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    212 Derbyshire Lane
    S8 8SE Sheffield
    South Yorkshire
    British126805180001
    EARL, Stanley Rylatt
    2 Stockwell Road
    HG5 0JN Knaresborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    2 Stockwell Road
    HG5 0JN Knaresborough
    North Yorkshire
    British2212840001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Sekretär
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MASON, Mike
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    Sekretär
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    British102494410001
    RYLETT, Colin Lee
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    British70442720002
    WESTWOOD, Stephen
    2 Devonshire Close
    Dore
    S17 3NX Sheffield
    Sekretär
    2 Devonshire Close
    Dore
    S17 3NX Sheffield
    British7264410001
    BENNETT, Raymond Allen
    8 Baldersdale Avenue
    HG5 0HH Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Baldersdale Avenue
    HG5 0HH Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish116142920001
    KEMP, Gerard Alan
    Mill Farm
    Alne
    YO6 2JE York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Mill Farm
    Alne
    YO6 2JE York
    Yorkshire
    EnglandBritish2212860001
    MASON, Michael
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish111015690001
    MCGRATH, Elaine
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    British22037770001
    MCGRATH, Sean Francis
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    British18633970001
    MILLER, Christopher Hugh
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    Geschäftsführer
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    EnglandBritish8071340001
    OGDEN, Gary Miles
    2 Fountain Court
    Rossington
    DN11 0FS Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Fountain Court
    Rossington
    DN11 0FS Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandEnglish48377660003
    RYLETT, Colin Lee
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    British70442720002
    SHAW, Stephen Martin
    13 Wollaton Road
    S17 4LD Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    13 Wollaton Road
    S17 4LD Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish78291310001
    STAMP, Kevin
    57 Greenhead Gardens
    Chapeltown
    S35 1AR Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    57 Greenhead Gardens
    Chapeltown
    S35 1AR Sheffield
    South Yorkshire
    British69912990001
    TOWNSEND, Ian
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    Geschäftsführer
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    United KingdomBritish26617400002

    Hat EUROCUT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge document
    Erstellt am 12. Feb. 2008
    Geliefert am 29. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £17,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The plant and machinery detailed in schedule one of the loan agreement and attached to the charge documentation between the medical houes PLC and eurocut limited dated 12TH feb 2008.
    Berechtigte Personen
    • The Medical House PLC
    Transaktionen
    • 29. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Loan agreement
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 07. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £50,000 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    All rights over the plant machinery and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Medical House PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 09. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £2,901,188.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    The factory and warehouse premises at 201 newhall road, sheffield and the whitehouse building, liverpool street, sheffi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Medical House PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 13. Sept. 2006
    Geliefert am 22. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment jones and shipman cylindrical grinder with digital readouts s/no 22000BO73989 model 1076E14 dtm rapid prototyping machine s/no 139181.33GO1011530 model sinerstation 2500 plus - with laser upgrade bridgeport vertical centre cnc s/no 601532531122 model VMC6009 (for details of further chattels charged please refer to the form 395 to) together with all replacements and all right title interest and benefit in and to any warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. Aug. 2004
    Geliefert am 28. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 03. Apr. 2003
    Geliefert am 05. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £400,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Schutte N50 cnc 3 y grinder series 51 NO23 (1993), schutte wu 400 cnc 4 axis tool grinder series 07 NO04 (1993), schutte cnc 5 axis machine series 08 NO06 (1994) (please refer to form 395 for further details). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 1995
    Geliefert am 03. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 12. Jan. 1988
    Geliefert am 20. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0