MOORE GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOORE GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02172761
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOORE GROUP LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MOORE GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MOORE GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GLOBEBLEND LIMITED30. Sept. 198730. Sept. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOORE GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOORE GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Dez. 2019

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    7 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Darius Padler am 06. Dez. 2018

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Stephen John Parkin als Geschäftsführer am 27. März 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ken Ellis als Direktor am 27. März 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Karl Gorton als Geschäftsführer am 27. März 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    17 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Darius Padler am 20. Juni 2013

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    21 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 48,000,001
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    17 SeitenAA

    Ernennung von Stephen John Parkin als Direktor am 02. Juni 2015

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Karl Gorton als Direktor am 21. Mai 2015

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Johannes Sebastian Gilcher als Geschäftsführer am 26. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Tom Martti Waltasaari als Geschäftsführer am 22. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von MOORE GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Sekretär
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer2318923
    76579530001
    ELLIS, Ken
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish179700660001
    PADLER, Darius
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    GermanyGerman177536100002
    BIGNALL, John
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    Sekretär
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    British907580004
    RADCLIFFE, Andrew Edward
    24 Whinney Lane
    HG2 9LT Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    24 Whinney Lane
    HG2 9LT Harrogate
    North Yorkshire
    British90829680002
    THORNDYKE, Peter Eric
    Hill House Moor Lane
    Arkendale
    HG5 0QU Knaresborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    Hill House Moor Lane
    Arkendale
    HG5 0QU Knaresborough
    North Yorkshire
    British1826090001
    WALLEY, Clive
    17 Stonegate
    Whixley
    YO26 8AS York
    North Yorkshire
    Sekretär
    17 Stonegate
    Whixley
    YO26 8AS York
    North Yorkshire
    British67457790001
    BALLS, Graham Francis
    Alfred-Ulrich-Strasse
    71711 Steinheim
    69
    Germany
    Geschäftsführer
    Alfred-Ulrich-Strasse
    71711 Steinheim
    69
    Germany
    GermanyBritish157636300001
    BILLIG, Nicholas Simon
    Southview
    Beckwithshaw
    HG3 1QR Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Southview
    Beckwithshaw
    HG3 1QR Harrogate
    North Yorkshire
    British75824350001
    BOWN, Richard Gerrard
    Rydal 11a Kent Road
    HG1 2LE Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Rydal 11a Kent Road
    HG1 2LE Harrogate
    North Yorkshire
    British61404610001
    DAVIES, Fred
    Ingmanthorpe House
    Ingmanthorpe
    LS22 5HL Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Ingmanthorpe House
    Ingmanthorpe
    LS22 5HL Wetherby
    West Yorkshire
    British1775740008
    GEARY, Michael John
    2 Velsheda Court
    Hythe Marina Village, Hythe
    SO45 6DW Southampton
    Geschäftsführer
    2 Velsheda Court
    Hythe Marina Village, Hythe
    SO45 6DW Southampton
    British96259840001
    GILCHER, Johannes Sebastian, Dr
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    GermanyGerman179844260001
    GORTON, Karl
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masco Corporation Limited
    Staffordshire
    United KingdomBritish157635990001
    KRAUSS, Alan Justin
    31600 Nottingham Drive
    Franklin
    48025 Michigan
    Usa
    Geschäftsführer
    31600 Nottingham Drive
    Franklin
    48025 Michigan
    Usa
    Us Citizen41749850002
    OLSEN, Lawrence Nigel Guy
    Hesden Lee
    Windmill Hill
    CB10 1RR Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Hesden Lee
    Windmill Hill
    CB10 1RR Saffron Walden
    Essex
    British2966300001
    PARKIN, Stephen John
    Thorp Arch Estate
    LS23 7DD Wetherby
    Moores Furniture Group Limited
    Geschäftsführer
    Thorp Arch Estate
    LS23 7DD Wetherby
    Moores Furniture Group Limited
    United KingdomBritish198847080001
    RADCLIFFE, Andrew Edward
    24 Whinney Lane
    HG2 9LT Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Whinney Lane
    HG2 9LT Harrogate
    North Yorkshire
    British90829680002
    ROBERTS, John Alexander, Doctor
    Whiteoak 16 Fairbourne
    KT11 2BT Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Whiteoak 16 Fairbourne
    KT11 2BT Cobham
    Surrey
    British2158330001
    THORNDYKE, Peter Eric
    Hill House Moor Lane
    Arkendale
    HG5 0QU Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hill House Moor Lane
    Arkendale
    HG5 0QU Knaresborough
    North Yorkshire
    British1826090001
    VOSS, Thomas
    Rue De Luxembourg
    5772 Weiler La Tour
    29
    Luxembourg
    Geschäftsführer
    Rue De Luxembourg
    5772 Weiler La Tour
    29
    Luxembourg
    Danish83405520002
    WALLEY, Clive
    17 Stonegate
    Whixley
    YO26 8AS York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    17 Stonegate
    Whixley
    YO26 8AS York
    North Yorkshire
    British67457790001
    WALTASAARI, Tom Martti
    Elisabethkirchstr
    Berlin
    2
    10115
    Germany
    Geschäftsführer
    Elisabethkirchstr
    Berlin
    2
    10115
    Germany
    GermanyFinnish157694430001
    WILSON, Peter John
    3 Wentworth Gate
    LS22 6XD Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Wentworth Gate
    LS22 6XD Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish49990440002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MOORE GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer01878678
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MOORE GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Senior security deed
    Erstellt am 27. März 1992
    Geliefert am 16. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the various documents as defined therein
    Kurze Angaben
    All the property charged pursuant to the guarantee and debenture.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior security deed
    Erstellt am 27. März 1992
    Geliefert am 16. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the various documents as defined therein
    Kurze Angaben
    All property charged pursuant to the guarantee and debenture dated 12/11/87 see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mezzanine security deed
    Erstellt am 27. März 1992
    Geliefert am 14. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations expressed to be assumed by it under any of the security documents as defined in order to secure the mezzanine liabilities (as defined ) whether as guarantor or otherwise and the security thereby constituted remain in full force and effect notwithstanding all or any amendments, variations or novations from time to time effected in relation to any of the mezzanine financing documents (as defined in the mezzanine security deed) and notwithstanding the introduction of new lenders (as defined in the mezzanine loan agreement)
    Kurze Angaben
    The property charged by the security documents as defined (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1990
    Geliefert am 18. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for each of the lenders as defined under the terms of the financing documents.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC.
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1990Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1990
    Geliefert am 18. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for the banks under the terms of the senior loan agreement, the hedging instruments and the guarantee and for securing all moneys due from moores furniture group limited or geo A. moore & co. Limited to the agent and/or the banks under the hedging instruments.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1990Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1990
    Geliefert am 18. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the bank), save in respect of any moneys due from the company to any of the agent and the banks under the hedging instruments and the senior loan agreement and for securing all moneys due from the company to any of moores furniture group limited, moores international limited and geo A. moore & co. Limited to the bank, save in respect of any monies due from these companies to the agent and the banks under the hedging instruments and the senior loan agreement.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1990Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Nov. 1987
    Geliefert am 27. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the senior loan agreement dated 11TH november 1987 and this deed
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all plant, machinery, vehicles, computers, office and other equipment together with all the other particulars as detailed on form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1987Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Nov. 1987
    Geliefert am 27. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustees for itself and the banks under the terms of the senior loan agreements dated 11TH november 1987 and this deed
    Kurze Angaben
    (Please see 395 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • International Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1987Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Jan. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Nov. 1987
    Geliefert am 17. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and other lenders (as defined) under the terms of the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1987Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MOORE GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Dez. 2019Beginn der Liquidation
    06. Apr. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0