MOORE GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MOORE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02172761 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MOORE GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MOORE GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MOORE GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GLOBEBLEND LIMITED | 30. Sept. 1987 | 30. Sept. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOORE GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MOORE GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Darius Padler am 06. Dez. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John Parkin als Geschäftsführer am 27. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ken Ellis als Direktor am 27. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karl Gorton als Geschäftsführer am 27. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Darius Padler am 20. Juni 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Stephen John Parkin als Direktor am 02. Juni 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Karl Gorton als Direktor am 21. Mai 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Johannes Sebastian Gilcher als Geschäftsführer am 26. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tom Martti Waltasaari als Geschäftsführer am 22. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MOORE GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Park Row LS1 5AB Leeds 1 West Yorkshire |
| 76579530001 | ||||||||||
| ELLIS, Ken | Geschäftsführer | Pooley Hall Drive Birch Coppice Business Park B78 1SG Tamworth Masco Corporation Limited Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 179700660001 | |||||||||
| PADLER, Darius | Geschäftsführer | Pooley Hall Drive Birch Coppice Business Park B78 1SG Tamworth Masco Corporation Limited Staffordshire | Germany | German | 177536100002 | |||||||||
| BIGNALL, John | Sekretär | Coombe Lane HP14 4QR Naphill Coombe Farm Bucks | British | 907580004 | ||||||||||
| RADCLIFFE, Andrew Edward | Sekretär | 24 Whinney Lane HG2 9LT Harrogate North Yorkshire | British | 90829680002 | ||||||||||
| THORNDYKE, Peter Eric | Sekretär | Hill House Moor Lane Arkendale HG5 0QU Knaresborough North Yorkshire | British | 1826090001 | ||||||||||
| WALLEY, Clive | Sekretär | 17 Stonegate Whixley YO26 8AS York North Yorkshire | British | 67457790001 | ||||||||||
| BALLS, Graham Francis | Geschäftsführer | Alfred-Ulrich-Strasse 71711 Steinheim 69 Germany | Germany | British | 157636300001 | |||||||||
| BILLIG, Nicholas Simon | Geschäftsführer | Southview Beckwithshaw HG3 1QR Harrogate North Yorkshire | British | 75824350001 | ||||||||||
| BOWN, Richard Gerrard | Geschäftsführer | Rydal 11a Kent Road HG1 2LE Harrogate North Yorkshire | British | 61404610001 | ||||||||||
| DAVIES, Fred | Geschäftsführer | Ingmanthorpe House Ingmanthorpe LS22 5HL Wetherby West Yorkshire | British | 1775740008 | ||||||||||
| GEARY, Michael John | Geschäftsführer | 2 Velsheda Court Hythe Marina Village, Hythe SO45 6DW Southampton | British | 96259840001 | ||||||||||
| GILCHER, Johannes Sebastian, Dr | Geschäftsführer | Pooley Hall Drive Birch Coppice Business Park B78 1SG Tamworth Masco Corporation Limited Staffordshire | Germany | German | 179844260001 | |||||||||
| GORTON, Karl | Geschäftsführer | Pooley Hall Drive Birch Coppice Business Park B78 1SG Tamworth Masco Corporation Limited Staffordshire | United Kingdom | British | 157635990001 | |||||||||
| KRAUSS, Alan Justin | Geschäftsführer | 31600 Nottingham Drive Franklin 48025 Michigan Usa | Us Citizen | 41749850002 | ||||||||||
| OLSEN, Lawrence Nigel Guy | Geschäftsführer | Hesden Lee Windmill Hill CB10 1RR Saffron Walden Essex | British | 2966300001 | ||||||||||
| PARKIN, Stephen John | Geschäftsführer | Thorp Arch Estate LS23 7DD Wetherby Moores Furniture Group Limited | United Kingdom | British | 198847080001 | |||||||||
| RADCLIFFE, Andrew Edward | Geschäftsführer | 24 Whinney Lane HG2 9LT Harrogate North Yorkshire | British | 90829680002 | ||||||||||
| ROBERTS, John Alexander, Doctor | Geschäftsführer | Whiteoak 16 Fairbourne KT11 2BT Cobham Surrey | British | 2158330001 | ||||||||||
| THORNDYKE, Peter Eric | Geschäftsführer | Hill House Moor Lane Arkendale HG5 0QU Knaresborough North Yorkshire | British | 1826090001 | ||||||||||
| VOSS, Thomas | Geschäftsführer | Rue De Luxembourg 5772 Weiler La Tour 29 Luxembourg | Danish | 83405520002 | ||||||||||
| WALLEY, Clive | Geschäftsführer | 17 Stonegate Whixley YO26 8AS York North Yorkshire | British | 67457790001 | ||||||||||
| WALTASAARI, Tom Martti | Geschäftsführer | Elisabethkirchstr Berlin 2 10115 Germany | Germany | Finnish | 157694430001 | |||||||||
| WILSON, Peter John | Geschäftsführer | 3 Wentworth Gate LS22 6XD Wetherby West Yorkshire | England | British | 49990440002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MOORE GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masco Corporation Limited | 06. Apr. 2016 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MOORE GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Senior security deed | Erstellt am 27. März 1992 Geliefert am 16. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the various documents as defined therein | |
Kurze Angaben All the property charged pursuant to the guarantee and debenture. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Senior security deed | Erstellt am 27. März 1992 Geliefert am 16. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the various documents as defined therein | |
Kurze Angaben All property charged pursuant to the guarantee and debenture dated 12/11/87 see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzanine security deed | Erstellt am 27. März 1992 Geliefert am 14. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities and obligations expressed to be assumed by it under any of the security documents as defined in order to secure the mezzanine liabilities (as defined ) whether as guarantor or otherwise and the security thereby constituted remain in full force and effect notwithstanding all or any amendments, variations or novations from time to time effected in relation to any of the mezzanine financing documents (as defined in the mezzanine security deed) and notwithstanding the introduction of new lenders (as defined in the mezzanine loan agreement) | |
Kurze Angaben The property charged by the security documents as defined (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Aug. 1990 Geliefert am 18. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for each of the lenders as defined under the terms of the financing documents. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 14. Aug. 1990 Geliefert am 18. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for the banks under the terms of the senior loan agreement, the hedging instruments and the guarantee and for securing all moneys due from moores furniture group limited or geo A. moore & co. Limited to the agent and/or the banks under the hedging instruments. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 14. Aug. 1990 Geliefert am 18. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the bank), save in respect of any moneys due from the company to any of the agent and the banks under the hedging instruments and the senior loan agreement and for securing all moneys due from the company to any of moores furniture group limited, moores international limited and geo A. moore & co. Limited to the bank, save in respect of any monies due from these companies to the agent and the banks under the hedging instruments and the senior loan agreement. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 12. Nov. 1987 Geliefert am 27. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the senior loan agreement dated 11TH november 1987 and this deed | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all plant, machinery, vehicles, computers, office and other equipment together with all the other particulars as detailed on form M395. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Nov. 1987 Geliefert am 27. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustees for itself and the banks under the terms of the senior loan agreements dated 11TH november 1987 and this deed | |
Kurze Angaben (Please see 395 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Nov. 1987 Geliefert am 17. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and other lenders (as defined) under the terms of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MOORE GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0