LLPPS (GEMS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLLPPS (GEMS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02176610
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LLPPS (GEMS) LIMITED?

    • Grundschule (85200) / Erziehung

    Wo befindet sich LLPPS (GEMS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    100 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LLPPS (GEMS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LADY LANE PARK PREPARATORY SCHOOL LIMITED12. Okt. 198712. Okt. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LLPPS (GEMS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LLPPS (GEMS) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für LLPPS (GEMS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Dino Sunny Varkey am 19. März 2013

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Global Education Management Systems Limited am 19. März 2013

    2 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für M&R Secretarial Services Limited am 19. Feb. 2013

    2 SeitenCH04

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed lady lane park preparatory school LIMITED\certificate issued on 02/07/13
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 24. Juni 2013

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 112 Hills Road Cambridge CB2 1PH am 18. März 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Global Education Management System Limited am 01. Okt. 2010

    2 SeitenCH02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Dino Sunny Varkey am 19. Nov. 2009

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Global Education Management System Limited am 23. Okt. 2009

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für M&R Secretarial Services Limited am 23. Okt. 2009

    1 SeitenCH04

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von LLPPS (GEMS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    M&R SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    100 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Botanic House
    England
    Sekretär
    100 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Botanic House
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer05065514
    99412960001
    VARKEY, Dino Sunny
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    Geschäftsführer
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    United Arab EmiratesIndian99007620001
    GLOBAL EDUCATION MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    Geschäftsführer
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04742550
    98789860012
    JOHNSON, David William
    22 Sunnyside Close
    Reedsholme
    BB4 8PE Rossendale
    Lancashire
    Sekretär
    22 Sunnyside Close
    Reedsholme
    BB4 8PE Rossendale
    Lancashire
    British2299140001
    MITCHELL, James Patrick
    54 Kent Road
    HG1 2EU Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    54 Kent Road
    HG1 2EU Harrogate
    North Yorkshire
    British46193460002
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    British51283590002
    THORNTON, Stuart Graham
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    British6130630001
    CUMMINS, Simon Paul Jeremiah
    9 Harland Way
    TN4 0TQ Tunbridge Wells
    Geschäftsführer
    9 Harland Way
    TN4 0TQ Tunbridge Wells
    British98960160001
    FITZMAURICE, Andrew
    96 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8RA Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    96 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8RA Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish70922490001
    JOHNSON, David William
    Jolly Hall Farm
    Oakenhead Wood Old Road
    BB4 8TX Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Jolly Hall Farm
    Oakenhead Wood Old Road
    BB4 8TX Rossendale
    Lancashire
    British2299140002
    MCNEANY, Kevin Joseph
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    EnglandIrish2299150001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    British51283590002
    THORNTON, Kathleen Lesley
    Thorncroft Morton Lane
    East Morton
    BD20 5AP Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Thorncroft Morton Lane
    East Morton
    BD20 5AP Keighley
    West Yorkshire
    British63862960001
    THORNTON, Stuart Graham
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    British6130630001

    Hat LLPPS (GEMS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2004
    Geliefert am 02. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Feb. 1997
    Geliefert am 19. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land and premises being land to the east of lady lane bingley bradford west yorkshire and the present and future goodwill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Feb. 1997
    Geliefert am 19. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land to the east of lady lane bingley bradford west yorkshire t/n WYK479165 and the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 21. Mai 1992
    Geliefert am 01. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h land and premises k/a lady cottage, lady lane, bingley, bradford title no. Wyk 499798 together with l/h land and buildings at lady lane, bingley bradford title no. WYK436839 and WYK450098 together with l/h playing fields at ladypark avenue, bingley, bradford title no. WYK506126 and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks, P.L.C.
    Transaktionen
    • 01. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Mai 1992
    Geliefert am 28. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Juli 1989
    Geliefert am 27. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shop unit 1, the green lady lane, bingley, west yorkshire assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 1989Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Juli 1989
    Geliefert am 27. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lane park preparatory school, the green, lady lane, bingley, west yorkshireassigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Apr. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Jan. 1989
    Geliefert am 06. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Lady lane park preparatory school, lady lane, bingley west yorkshire, title no wyk 385462 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Apr. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0