RYSBRIDGE ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RYSBRIDGE ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02178607 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PORTRENT LIMITED | 14. Okt. 1987 | 14. Okt. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 39 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2017 | 28 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2016 | 31 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2015 | 33 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2014 | 33 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 179 Great Portland Street London W1W 5LS am 22. Apr. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicolae Christopher Ratiu als Geschäftsführer am 14. Feb. 2013 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Robert Starn als Direktor am 14. März 2013 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jagtar Singh als Geschäftsführer am 08. Mai 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Gary Balfour-Lynn als Geschäftsführer am 31. März 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Blurton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 21 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Francis Blurton am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY GROUP PLC | Sekretär | 30 City Road EC1Y 2AG London | 35794270004 | |||||||
| FILEX SERVICES LIMITED | Sekretär | 179 Great Portland Street W1W 5LS London | 3620420001 | |||||||
| BIBRING, Michael Albert | Geschäftsführer | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||
| KARMEL, Simon Harry | Geschäftsführer | Elm Tree Road NW8 9JP London 20 | England | British | 2014130001 | |||||
| STARN, William Robert | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | American | 154007330001 | |||||
| LIPSCOMB, Helen | Sekretär | 11 Herbert Road N11 2QN London | British | 5036040002 | ||||||
| PALMER, Martin Trevor Digby | Sekretär | Hill House Crook Road Brenchley TN12 7BS Tonbridge Kent | British | 79436600001 | ||||||
| WOOLLEY, Roderic Harry | Sekretär | Clamara 62 Kingsclere Road RG25 3JB Overton Hampshire | British | 1017530003 | ||||||
| ARTUS, Alan Norman | Geschäftsführer | 10 Cambridge Road SW11 4RS London | British | 72061440002 | ||||||
| AUSTEN, Jonathan Martin | Geschäftsführer | 68 Braxted Park SW16 3AU London | British | 36694850001 | ||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Geschäftsführer | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||
| BLURTON, Andrew Francis | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | England | British | 53724380001 | |||||
| BOWES, Graham | Geschäftsführer | Wavertree 20 St Peters Road TW1 1QX St. Margarets, Twickenham Middlesex | British | 37707190003 | ||||||
| HARRISON, John William | Geschäftsführer | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | 69263980002 | |||||
| INGMAN, Philip Michael | Geschäftsführer | Flat 6 Bridge House 298 Wandsworth Bridge Road SW6 2TT London | British | 54153030001 | ||||||
| MCDONALD, Peter Stuart | Geschäftsführer | 4 St Stephens Terrace SW8 1DH London | British | 77781180001 | ||||||
| PLUMMER, Jeremy James | Geschäftsführer | Springwell House The Street North Warnborough RG29 1BD Hook Hampshire | England | British | 3994380002 | |||||
| POPE, Nigel Howard | Geschäftsführer | 3 Rolleston Close Petts Wood BR5 1AN Orpington Kent | British | 29583660001 | ||||||
| RATIU, Nicolae Christopher | Geschäftsführer | 47 Clifton Hill NW8 0QE London | United Kingdom | British | 67475010001 | |||||
| SHASHOU, Joseph Saleem | Geschäftsführer | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | 51723030002 | |||||
| SHEEHAN, Nicholas John Philip | Geschäftsführer | Upperfold Hewshott Lane GU30 7SU Liphook Hampshire | British | 39476870001 | ||||||
| SINGH, Jagtar | Geschäftsführer | West Garden Place Kendal Street W2 2AQ London 1 England | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||
| SLOAN, Roderick David Gray | Geschäftsführer | 3 The Redwoods Bolton Avenue SL4 3TA Windsor Berkshire | British | 9739700002 | ||||||
| STEVENS, Michael | Geschäftsführer | 21 Chestnut Close HP6 6EQ Amersham Buckinghamshire | British | 60348780001 | ||||||
| TIPPING, Geoffrey Nigel | Geschäftsführer | The Nursery Manningford Abbots SN9 5PB Pewsey Wiltshire | United Kingdom | British | 80925340001 | |||||
| WALSH, David George Patrick | Geschäftsführer | Manor Farm Little Cheverell SN10 4JP Devizes Wiltshire | British | 11107290001 |
Hat RYSBRIDGE ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 04. Juli 2000 Geliefert am 10. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and any other company named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed charge all right title and interest in each of the assets: real property, bank accounts, insurances, benefit of licenses consents and authorisations. Floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Apr. 2000 Geliefert am 21. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All liabilities of the obligors owed or expressed to be owed to the charge (the agent) and to the beneficiaries under or in connection with the finance documents inclcuding principal interest fees costs and expenses and whether owed jointly or severally as principal or surety or in any othr capacity | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. März 1998 Geliefert am 27. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for iself and the banks as defined) under the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben All real property,any investment,goodwill and uncalled capital,money standing to the credit of any designated account for full details of all charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 03. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company. | |
Kurze Angaben Naval row blackwall way, tower markets, l/b of tower hamlets title no egl 200588 and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 03. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company. | |
Kurze Angaben Kensington village avon trading estate aranmore road, l/b of hammersmith & fulham title no ngl 621514 and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Sept. 1988 Geliefert am 27. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Dez. 1987 Geliefert am 17. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a land & buildings on the south side of navalrow and on the east side of blackwall way, london E14, title no. Egl 200588. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Dez. 1987 Geliefert am 17. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a avon trading estate situate at avonmore road fulham, title no. Ngl 125133. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat RYSBRIDGE ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0