LONDON FIELDS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LONDON FIELDS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02180400 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LONDON FIELDS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich LONDON FIELDS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 25 Harley Street London W1G 9BR |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LONDON FIELDS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SELECTEARLY LIMITED | 19. Okt. 1987 | 19. Okt. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LONDON FIELDS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LONDON FIELDS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Dez. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 28. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 27. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 of companies act 2006 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Collins als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Jennifer Grace Draper als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 18. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Patrick Colin O'driscoll am 18. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John Collins am 03. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Lane Tuckey am 03. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LONDON FIELDS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E L SERVICES LIMITED | Sekretär | 25 Harley Street W1G 9BR London | 78638580003 | |||||||
| DRAPER, Jennifer Grace | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1JB London 23 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 152638020001 | |||||
| O'DRISCOLL, Patrick Colin | Geschäftsführer | Floor Millbank Tower 21-24 Millbank SW1P 4QP London 4th United Kingdom | England | Irish | 75571770001 | |||||
| TUCKEY, James Lane | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1JB London 23 United Kingdom | United Kingdom | British | 35019240001 | |||||
| TURNER, Malcolm Robin | Geschäftsführer | Floor Millbank Tower 21-24 Millbank SW1P 4QP London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | 60293070008 | |||||
| COOK, Kenneth Alan | Sekretär | 27 Glendower Road East Sheen SW14 8NY London | British | 100000003 | ||||||
| HARRISON, Linda Christine | Sekretär | 87 Kimberley Road CR0 2PZ Croydon Surrey | British | 85883750001 | ||||||
| OSBORNE, Ian | Sekretär | 42 Brancaster Drive Mill Hill NW7 2SJ London | British | 44830690006 | ||||||
| BARROTT, Ronald Stephen | Geschäftsführer | Foxborough Drovers Hill GL55 6UW Chipping Campden Gloucestershire | England | British | 9892700002 | |||||
| BERNERD, Elliott | Geschäftsführer | 58 Old Church Street SW3 5DB London | British | 44790970001 | ||||||
| BROKE, Michael Haviland Adlington | Geschäftsführer | 7 Westmead Roehampton SW15 5BH London | British | 2996750001 | ||||||
| BUTLER, Robin Elliott | Geschäftsführer | Gatehouse Farm Rogate GU31 5DB Petersfield Hampshire | England | British | 2996760007 | |||||
| CODLING, John Piers | Geschäftsführer | Smithy Cottage High Street HP7 0DY Little Missenden Bucks | British | 26235710001 | ||||||
| COLLINS, David John | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1JB London 23 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 119898430001 | |||||
| HUGILL, William Nigel | Geschäftsführer | 15 Briar Walk Putney SW15 6UD London | England | British | 3015960006 | |||||
| MCDIVEN, Ross Arnold | Geschäftsführer | U 9 38 Bay Street NSW 2028 Double Bay New South Wales Australia | Australian | 108719480001 | ||||||
| MCGIVERN, Jayne Eleanor | Geschäftsführer | 9 Northumberland Place W2 5BS London | British | 106563070002 | ||||||
| MINSHULL-BEECH, John Patrick | Geschäftsführer | 33 Gerard Road SW13 9QH London | England | British | 85462230001 | |||||
| NAHUM, Stephane Abraham Joseph | Geschäftsführer | 21a Kensington High Street W8 5NP London | England | French | 99292580003 | |||||
| NATHAN, Timothy Paul | Geschäftsführer | 19 Elms Avenue N10 2JN London | England | British | 104162560001 | |||||
| PEDERSEN, Karen Maree | Geschäftsführer | 22a Kentville Avenue Annandale Nsw 2038 | Australian | 109087760001 | ||||||
| PHILLIPS, David | Geschäftsführer | 5 Glebe Place SW3 5LB London | United Kingdom | British | 65062400001 | |||||
| SHAW, John Campbell | Geschäftsführer | Park House 2 John Woolf Court Northwick Park GL56 9RS Blackley Gloucestershire | British | 104735000001 |
Hat LONDON FIELDS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Permanent finance security deed | Erstellt am 15. Sept. 2004 Geliefert am 04. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental guarantee and debenture (supplemental to a guarantee and debenture dated 31 october 1994) | Erstellt am 23. Dez. 1996 Geliefert am 02. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben The f/h land and buildings k/a broadfield house cowley oxfordshire t/n ON88895 and land and buildings at plot 99 (k/a dunhams court) dunhams lane letchworth t/n HP239006 together with all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale thereof and the benefit of any covenants and insurances and a floating charge all the undertaking and assets whatsoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 1994 Geliefert am 08. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined in the charge) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings k/a broadfield house cowley oxfordshire t/no ON88895 and land & buildings at plot 99 (otherwise k/a dunhams court) dunhams lane letchworth t/no H0239006. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fourth supplemental guarantee and debenture | Erstellt am 14. Mai 1993 Geliefert am 03. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and adviseclaim limited (or either of them) to the finance parties (or any of them) (as defined) on any account whatsoever under the terms of each of the finance documents to which the company and adviseclaim (or either of them) is a party | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination deed | Erstellt am 07. Mai 1992 Geliefert am 26. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the senior finance documents or any other documents defined therein | |
Kurze Angaben Particulars as defined on form 395 see 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Mai 1992 Geliefert am 26. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and adviseclaim limited to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for each of the finance parties (as defined in the credit agreement dated 10/3/92 under each of the finance documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben See from 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Mai 1992 Geliefert am 26. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0