COBRA LONDON MARKETS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COBRA LONDON MARKETS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02181039 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
- Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rossington's Business Park West Carr Road DN22 7SW Retford England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COBRA GAL LIMITED | 22. Feb. 2006 | 22. Feb. 2006 |
| G.A.L LIMITED | 31. Aug. 2004 | 31. Aug. 2004 |
| GRIFFITHS & ARMOUR (LONDON) LIMITED | 11. Feb. 1988 | 11. Feb. 1988 |
| NOTIONSURE LIMITED | 19. Okt. 1987 | 19. Okt. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Okt. 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Colosso als Geschäftsführer am 25. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Mark Walsh als Geschäftsführer am 25. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy John Chadwick als Geschäftsführer am 25. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy John Chadwick am 27. März 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Mark Walsh am 28. Nov. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fiona Andrews als Geschäftsführer am 31. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Okt. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brendan James Mcmanus als Geschäftsführer am 30. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ryan Christopher Brown als Geschäftsführer am 30. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard John Scott als Geschäftsführer am 05. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Okt. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Cobra Gal (Holdings) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Okt. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2020 bis 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, Paul Mark | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 213094470001 | |||||
| REASON, William Raymond | Sekretär | 274 Hunts Cross Avenue Woolton L25 8QT Liverpool Merseyside | British | 18554810001 | ||||||
| SPARLING, Ian William | Sekretär | 12 Clavering Gardens West Horndon CM13 3ND Brentwood Essex | British | 32242170001 | ||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Thames House Portsmouth Road KT10 9AD Esher Surrey | 34893920004 | |||||||
| WILLOW TAXATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 1st Floor Curzon House 24 High Street SM7 2LJ Banstead Surrey | 111052920001 | |||||||
| ANDREWS, Fiona | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 264342050001 | |||||
| BADER, Steven John | Geschäftsführer | Queenswood Road SE23 2QS London 54 England | United Kingdom | British | 218122040001 | |||||
| BAMFORTH, Stephen Howard | Geschäftsführer | 8 Broadacre Close L18 2JW Liverpool Merseyside | England | British | 41484410002 | |||||
| BELL, Malcolm Rennison | Geschäftsführer | Wren Cottage 313a Petersham Road Ham TW10 7DB Richmond Surrey | British | 38020090001 | ||||||
| BROWN, Ewen Cameron | Geschäftsführer | 110 Fenchurch Street London EC3M 5JT | Uk | British | 146910850001 | |||||
| BROWN, Ryan Christopher | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | United Kingdom | British | 287066760001 | |||||
| BURROWS, Stephen Mark | Geschäftsführer | Firdale East Parkside Great Park CR6 9PZ Warlingham Surrey | United Kingdom | British | 13539590001 | |||||
| CHADWICK, Timothy John | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 192340400002 | |||||
| COLOSSO, Adrian | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 4555310002 | |||||
| CRISP, Mark Frederick | Geschäftsführer | Fenchurch Street EC3M 5JT London 110 | United Kingdom | British | 172349850001 | |||||
| DRISCOLL, Kevin Francis | Geschäftsführer | 22 Brimstage Road Heswall CH60 1XG Wirral Merseyside | British | 15848270001 | ||||||
| FULLER, Brian Arthur | Geschäftsführer | Hornigals Farm Feering CO5 9RS Essex | United Kingdom | United Kingdom | 24297400004 | |||||
| GOODWIN, Andrew Stephen | Geschäftsführer | Conifer Close RH2 9NN Reigate 6 England | United Kingdom | British | 218149930001 | |||||
| GRAHAM, Andrew Richard | Geschäftsführer | 14 The Firle SS16 6NB Basildon Essex | England | British | 38020230002 | |||||
| GRIFFITHS, Robin Mark Hill | Geschäftsführer | Glan-Y-Wern Llandrynog LL16 4ET Denbigh Clwyd | Wales | British | 4171930001 | |||||
| HOLLAMBY, Robert Alan | Geschäftsführer | 56 Roxwell Road CM1 2ND Chelmsford Essex | Great Britain | British | 67584890002 | |||||
| JENKINS, Ian Trevor | Geschäftsführer | Eleuthera 56 Lynwood Grove BR6 0BH Orpington Kent | British | 41580860001 | ||||||
| JOHNSTONE, Andrew Neil | Geschäftsführer | Pendower 36 Gayton Lane Heswall CH60 8PY Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 15848310001 | |||||
| LINCOLN, John Edward | Geschäftsführer | St Martins Lane BR3 3XS Beckenham 6 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 178228000001 | |||||
| LITTLE, Carol | Geschäftsführer | Hornigals Farm CO5 9RS Feering Colchester | British | 32242180002 | ||||||
| LOVELADY, Andrew Robert | Geschäftsführer | 50 Tollemache Road CH43 8SZ Prenton Merseyside | United Kingdom | British | 41693730006 | |||||
| LOVELADY, Andrew Robert | Geschäftsführer | 24 Esplen Avenue Crosby L23 2SS Liverpool | British | 41693730001 | ||||||
| MCMANUS, Brendan James | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | United Kingdom | British | 128122260001 | |||||
| MONNICKENDAM, Peter Frederick John | Geschäftsführer | Oaklands Colemans Lane Danbury CM3 4DN Chelmsford Essex | British | 24582750002 | ||||||
| MONTGOMERY, Paul David Rae | Geschäftsführer | Fenchurch Street EC3M 5JT London 110 | England | British | 172349760001 | |||||
| PARKER, Peter Terence | Geschäftsführer | 150 Foxon Lane CR3 5SF Caterham Surrey | United Kingdom | British | 21299410001 | |||||
| PICKERING, Graham Charles | Geschäftsführer | Mascalls Court Barn Mascalls Court Road, Paddock Wood TN12 6NB Tonbridge Kent | British | 67584830002 | ||||||
| POULTON, Hannah | Geschäftsführer | 6 Daines Way SS1 3PF Southend On Sea Essex | British | 99706350001 | ||||||
| REASON, William Raymond | Geschäftsführer | 274 Hunts Cross Avenue Woolton L25 8QT Liverpool Merseyside | British | 18554810001 | ||||||
| REDING, Jason Robert John | Geschäftsführer | c/o Cobra 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 11th Floor England | England | British | 74451100001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra Gal (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat COBRA LONDON MARKETS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. März 2015 Geliefert am 26. März 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Sept. 2012 Geliefert am 22. Sept. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 31. März 2008 Geliefert am 10. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 2005 Geliefert am 06. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Sept. 2004 Geliefert am 21. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 22ND august 1990 (the "principal deed") as modified by a deed of variation dated 14TH december 1993 (the "first deed of variation"), issued by the company | Erstellt am 14. Okt. 1999 Geliefert am 08. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment of all costs, charges, expenses and other liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed (as modified); and the payments of all debts and obligations due or to become due from the company to the chargee in respect of insurance transactions | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation | Erstellt am 14. Dez. 1993 Geliefert am 21. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The charge created by the deed of variation is a continuing security and shall be a second floating charge and subject to all provisions mutatis mutandis of the security and trust deed (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security and trust deed | Erstellt am 22. Aug. 1990 Geliefert am 24. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (see 395 ref m 73 and cont'd sheets for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0