WRG PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWRG PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02181617
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WRG PROPERTIES LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich WRG PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WRG PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CAIRD PROPERTIES LIMITED21. Okt. 198721. Okt. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WRG PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für WRG PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7RG am 07. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    4 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Nov. 2012

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juli 2012

    Kapitalaufstellung am 23. Juli 2012

    • Kapital: GBP 908,166
    SH01

    Ernennung von Mrs Victoria Bunton als Sekretär am 26. Okt. 2011

    1 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Caterina De Feo als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 24. Aug. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    8 SeitenAA

    Ernennung von Mr Paul Taylor als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von James Meredith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Leslie Cassells als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    8 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    7 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von WRG PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUNTON, Victoria
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Sekretär
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    164528800001
    FAVIER TILSTON, Claire
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British117647490002
    ORTS-LLOPIS, Vicente Federico
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Geschäftsführer
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    United KingdomSpanish147551840001
    TAYLOR, Paul
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Geschäftsführer
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    United KingdomBritish147757950001
    BOLTON, Jonathan Mark
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British15931960007
    CALDER, Samantha Jane
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    British75830790003
    DE FEO, Caterina
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Sekretär
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Italian140556050001
    FLYNN, David Robert
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    British34208920001
    HARDMAN, Steven Neville
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    Sekretär
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    British93743250001
    KAYE, Paul
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British3245340002
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Sekretär
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    British18116420006
    WATERHOUSE, Alan
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    Sekretär
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    British24588340001
    AVERILL, Michael Charles Edward
    Fir Tree House 61 Chiltern Road
    Long Crendon
    HP18 9BZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Fir Tree House 61 Chiltern Road
    Long Crendon
    HP18 9BZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British24913560001
    BURNS, Phillip Wesley
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    Geschäftsführer
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    United KingdomBritish160550800001
    CAMM, Paul Beverley
    18 St Martins Road
    Thorngumbald
    HU12 9PS Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    18 St Martins Road
    Thorngumbald
    HU12 9PS Hull
    North Humberside
    EnglandBritish14961540001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British95347040005
    COBURN, Paul Michael
    Old Pines, 103, Oldfield Drive
    CH60 9LQ Heswall
    Wirral
    Geschäftsführer
    Old Pines, 103, Oldfield Drive
    CH60 9LQ Heswall
    Wirral
    EnglandBritish113589330001
    DOWNES, David John
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    United KingdomBritish37289200002
    FLYNN, David Robert
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish34208920001
    HARDMAN, Steven Neville
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British93743250006
    LINACRE, Peter John
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish34646130002
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    EnglandBritish18116420006
    STEWART, David John
    7 Lower Brook Lane
    Worsley
    M28 2LL Manchester
    Geschäftsführer
    7 Lower Brook Lane
    Worsley
    M28 2LL Manchester
    British62266560001
    STEWART, Quentin Richard
    The Lodge
    106 Aberdeen Park Islington
    N5 2BA London
    Geschäftsführer
    The Lodge
    106 Aberdeen Park Islington
    N5 2BA London
    British94880800001
    WEIR, David Thomas
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    UkBritish33621820001

    Hat WRG PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Shanks third stage debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 09. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 05. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of second legal mortgage and second fixed charged the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all the rights and interest present and future in respect of the relevant documents by way of second floating charge its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York as Second Secured Note Trustee (The Second Secured Note Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of second legal mortgage and second fixed charge the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all its present and future rights and interests in respect of the relevant documents by way of second floating charge, its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York as Second Secured Note Trustee (The "Second Secured Note Trustee")
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shanks third stage debenture
    Erstellt am 15. Dez. 2004
    Geliefert am 21. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Aug. 2004
    Geliefert am 09. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC ("the Security Agent")
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juli 2004
    Geliefert am 20. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the security agent and/or the finance parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1997
    Geliefert am 24. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property's k/a port clarence refinery river tees north bank t/no CE84909 land and buildings lying to the north east of manchester road accrington t/no la 679601 plots 1,2 and 3 waterson industrial estate milford haven t/no wa 486380 and land and buildings lying to the south east of forge lane minworth sutton coldfield t/no wm 427845. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Okt. 1988
    Geliefert am 01. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Aug. 1988
    Geliefert am 30. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land & buildings lying to the south east side of B1273 middleton st. George darlington title no:- du 133312 including all fixtures & fittings (as above). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Aug. 1988
    Geliefert am 30. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    33 sekforde street, london EC1R 0HH title no:- ln 226036 including all fixtures & fittings (other than trade fixtures and fittings) plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit of deeds without written instrument.
    Erstellt am 02. Aug. 1988
    Geliefert am 05. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land & buildings lying to the south east of the B1273 middleton st george title no:- du 133312 including all fixtures & fittings (other than trade fixtures & fittings) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    98 cheetham hill road manchester title no gm 194892 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Warwick house birmingham road stratford upon avon title no wk 311599 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Units 1/3 100 layton road brentford title no's ngl 562352 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    King charles ii house headlands road pontefract title no. Wyk 240441 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Imperial house 21-25 north street bromley kent title no. Sgl 288719 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    8 a/b & 9 carlton crescent southampton title nos. Hp 167612 & hp 251564 including all fixtures and fittings (ohter than trade fixtures) fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Woodside park somerford booths hall congleton cheshire title no ch 165273 including fixtures and fittings (other than trade fixtures) fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Winterton house high street westerham title nos k 20122 & k 504006 including fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Unit 1/1D swan lane industrial estate title no. Sf 83350 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Unit f consort way burgess hill title no. Wsx 55376 including all fixtures & fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 1988
    Geliefert am 15. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    98, cheetham hill road, cheetham manchester, title no:- gm 194892.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 1988
    Geliefert am 15. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Teeside training & technology centre, teeside airport, darlington, county durham, title no:- du 133312.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 1988
    Geliefert am 15. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    33, sekforde street, london EC1, title no:- ln 226036.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 1988
    Geliefert am 11. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due to the bank from a caird & sons polc on any account whatsoever and from caird properties limited under the charge
    Kurze Angaben
    21/25 north street bromley title no sgl 288719.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1988Registrierung einer Belastung

    Hat WRG PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Juli 2013Aufgelöst am
    20. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0