STROBE 5

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTROBE 5
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 02182712
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STROBE 5?

    • (7487) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich STROBE 5?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von STROBE 5?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STROBE 5 LIMITED29. Feb. 200829. Feb. 2008
    NORTHERN LEISURE LIMITED16. Juli 200116. Juli 2001
    LUMINAR LEISURE LIMITED06. Apr. 198806. Apr. 1988
    LEADWISE LEISURE LIMITED26. Jan. 198826. Jan. 1988
    LEADWISE LIMITED23. Okt. 198723. Okt. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STROBE 5?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für STROBE 5?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. März 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 14. Sept. 2009

    LRESEX

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    3 Seiten288a

    Verschiedenes

    Auditor's resignation letter - sec 519
    1 SeitenMISC

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return15. Sept. 2008

    legacy

    363(353)
    annual-return15. Sept. 2008

    legacy

    363(190)

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share prem acct 28/02/2008
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Re share premium account 03/03/2008
    RES13

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten122

    Wer sind die Geschäftsführer von STROBE 5?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARDEN, Christian
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish62937340001
    BARRETT, David William
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    EnglandBritish2264460001
    AUST, Jonathan Neale
    6 Arundel Close
    Sandiacre
    NG10 5PG Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    6 Arundel Close
    Sandiacre
    NG10 5PG Nottingham
    Nottinghamshire
    British28871450001
    KINROSS, John
    6 Handel Mead
    Old Farm Park
    MK7 8QA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    6 Handel Mead
    Old Farm Park
    MK7 8QA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British37384650003
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Sekretär
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Sekretär
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Sekretär
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British38563740001
    ARNOLD, Michael John
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    British48184650002
    AUST, Jonathan Neale
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    Geschäftsführer
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    EnglandBritish160178570001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish68970050002
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Geschäftsführer
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Geschäftsführer
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    EDGE, William
    Triboges House
    Berries Road
    SL6 9SD Cookham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Triboges House
    Berries Road
    SL6 9SD Cookham
    Berkshire
    British35575760002
    GLYN, Ian Robert Howard
    The Innocents
    OX10 6JR Berrick Salome
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Innocents
    OX10 6JR Berrick Salome
    Oxfordshire
    EnglandBritish4399820001
    HALL, Norman Ronald
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    United KingdomBritish98926570001
    LOADES, Stephen
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish77619750001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Geschäftsführer
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MARKS, Peter Jack
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritish77895710001
    MARSHALL, Anthony
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish155979460001
    MCIVOR, Andrew
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    Geschäftsführer
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    British61144120003
    MCLOUGHLIN, Brendan Michael
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    Geschäftsführer
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    United KingdomBritish40530320004
    PRESTON, Clive Henry
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    EnglandBritish1973870004
    ROBERTS, Peter William Denby
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    Geschäftsführer
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    EnglandBritish106538510001
    ROBERTS, Timothy Julian
    Coopers
    Chapel Street
    CV35 9QU Wellesbourne
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Coopers
    Chapel Street
    CV35 9QU Wellesbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritish105669310003
    THOMAS, Stephen Charles
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    United KingdomBritish66198390006
    TURVEY, Neil William
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritish51899270003
    WILDING, Linda
    Tangley Way
    Blackheath
    GU4 8QS Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tangley Way
    Blackheath
    GU4 8QS Guildford
    Surrey
    EnglandBritish41193380003
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    WILLITS, Henry Andrew
    Laburnum Cottage
    49 High Street
    LE65 1WJ Packington
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Laburnum Cottage
    49 High Street
    LE65 1WJ Packington
    Leicestershire
    British90132600001

    Hat STROBE 5 Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Licence to assign
    Erstellt am 12. März 2009
    Geliefert am 19. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £37,011.86 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit and all money from time to time withdrawn from it see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • John Trevor Bargh and Alison Jane Bargh
    Transaktionen
    • 19. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 30. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditor
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 22. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 28. März 2001
    Geliefert am 09. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future monies debts and liabilities due or to become due from any chargor to the chargee as security trustee (the "security trustee") as security trustee for the benefit of the secured creditors (as defined) in relation to any of the creditor finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 1998
    Geliefert am 26. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    62/63 high street maidstone kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 1995
    Geliefert am 24. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The properties at 64 and 66 humberstone gate and 10 st james' street leicester t/nos. Lt 57174 and lt 54770.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Nov. 1994
    Geliefert am 08. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a l'aristos, newark road boon gate peterborough t/n cb 104210 and an assignment of all trade and tenant's fixtures fittings and chattels and the goodwill and benefit of all licences held in connection with the business.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 1994
    Geliefert am 14. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The old police station queen street colchester essex.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter or the deed both dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.gr 51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mercury Asset Management PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.gr 51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Grosvenor Development Capital PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee a limited partnership acting by its general partner third grosvenor limited under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.gr 51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Third Grosvenor Fund
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as nominee of the second lazard leisure fund acting by its general partner lazard leisure (general partner) limited under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.GR51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Funds (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 1993
    Geliefert am 06. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/as 22 and 22 half silver street, leicester.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 01. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time) and/or a deed dated 20TH january 1993 and other associated charges.
    Kurze Angaben
    For full details of properties please see doc M4L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Mercury Asset Management PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 01. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time)
    Kurze Angaben
    For full details of property please see doc M3. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Third Grosvenor Fund
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 01. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time)
    Kurze Angaben
    For full details of property charged please see doc M2. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Grosvenor Development Capital PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 01. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time)
    Kurze Angaben
    For full details of all the property charged please see doc M1. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Funds (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Erstellt am 04. Dez. 1992
    Geliefert am 11. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £48,504.20 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Kurze Angaben
    All its right,title and interest in and to all sums payable under the insurance.please see doc M387C for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Aug. 1992
    Geliefert am 10. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,500,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH august 1992.
    Kurze Angaben
    A)the basement premises with ground floor entrances situate and k/a 20/22 sidney street,cambridge-chicago rock cafe,cambridge.t/no. Cb 577588 for full details of property charged please see doc M7L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Mercury Asset Management PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 1991
    Geliefert am 19. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property k/as 20/22 sidney street cambridge title no. Cb 57738.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 1991
    Geliefert am 19. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property situate and k/as part ground floor and basement the royal hotel,norwich.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Aug. 1991
    Geliefert am 30. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its succennors and assings in accordance with the provisions of a mezzanine loan agreement dated 22/8/91 and other annociated charges.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Mercury Asset Management PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 1991
    Geliefert am 12. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property k/as vienna, 63 high street maidstone.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Jan. 1991
    Geliefert am 23. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Chicago rock 46 park street luton bedfordshire.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 1990
    Geliefert am 02. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. Fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Essential Leisure Limited
    Transaktionen
    • 02. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat STROBE 5 Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Sept. 2009Beginn der Liquidation
    07. Nov. 2012Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul John Clark
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0