TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED

TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02182956
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    65 Kingsway
    London
    WC2B 6TD
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRAVELEX INSURANCE SERVICES LIMITED13. Nov. 198713. Nov. 1987
    DELTALOAN LIMITED23. Okt. 198723. Okt. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 11. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reappoint auditors 04/10/2010
    RES13

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sylvain Marc Pignet am 31. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Martyn Lewis Emmerson am 31. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für James Edward Sullivan Birch am 31. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    4 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PIGNET, Sylvain Marc
    65 Kingsway
    London
    WC2B 6TD
    Sekretär
    65 Kingsway
    London
    WC2B 6TD
    French74493960002
    BIRCH, James Edward Sullivan
    65 Kingsway
    London
    WC2B 6TD
    Geschäftsführer
    65 Kingsway
    London
    WC2B 6TD
    United KingdomBritish88871990001
    EMMERSON, Martyn Lewis
    65 Kingsway
    London
    WC2B 6TD
    Geschäftsführer
    65 Kingsway
    London
    WC2B 6TD
    EnglandBritish119841680001
    CLAYTON, Darren Frank
    43 Annett Road
    KT12 2JS Walton On Thames
    Surrey
    Sekretär
    43 Annett Road
    KT12 2JS Walton On Thames
    Surrey
    British37357020002
    KAHN, Clive Ian
    10 Totnes Walk
    N2 0AD London
    Sekretär
    10 Totnes Walk
    N2 0AD London
    British54658110001
    KAHN, Clive Ian
    10 Totnes Walk
    N2 0AD London
    Sekretär
    10 Totnes Walk
    N2 0AD London
    British54658110001
    CONROY, John Gerald
    620 Platinum House
    Lyon Road
    HA1 2EX Harrow
    Geschäftsführer
    620 Platinum House
    Lyon Road
    HA1 2EX Harrow
    Irish63394000002
    DORFMAN, Lloyd Marshall
    Travelex
    65 Kingsway
    WC2B 6TD London
    Geschäftsführer
    Travelex
    65 Kingsway
    WC2B 6TD London
    EnglandBritish89428640001
    KAHN, Clive Ian
    10 Totnes Walk
    N2 0AD London
    Geschäftsführer
    10 Totnes Walk
    N2 0AD London
    British54658110001

    Hat TRAVELEX MARITIME SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Nov. 2002
    Geliefert am 27. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture relating to a working capital and overdraft facility agreement and acquisition facility agreement between the company,the group companies and barclays bank PLC
    Erstellt am 01. Sept. 2000
    Geliefert am 04. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability and obligation which the company may at any time have to the chargee (whether for it's own account or as trustee for the secured parties) or any of the secured parties (as defined) whether without limitation under or pursuant to the finance documents (as defined) or otherwise and any liability in respect of any further advances whether without limitation made under the finance documents or otherwise whether present or future actual or contingent and whether incurred solely or jointly and whether as principal or surety or in some other capacity) and the company shall pay to the chargee every sum due or owing to the chargee or any of the secured parties
    Kurze Angaben
    The real property the tangible moveable property the intellectual property, any goodwill and rights any goodwill in relation to the uncalled capital,the investments, the shares all dividends interest and rights relating to the shares, all monetary clams and stocks of cash by way of assignment any proceeds under the insurance policies by way of floating charge all property and assets |(see form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 1998
    Geliefert am 08. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the deed of guarantee dated 30 december 1998
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC(Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Lenders Under the Mezzanine Loan Agreement) or Any of the Lenders
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 17. Juli 1998
    Geliefert am 18. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Generale Bank N.V.-Generale De Banque S.A.
    Transaktionen
    • 18. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Juli 1996
    Geliefert am 10. Juli 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Jan. 1995
    Geliefert am 18. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 18. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Nov. 1994
    Geliefert am 08. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge debenture
    Erstellt am 22. Dez. 1989
    Geliefert am 08. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other company named therein to the chargee under or in connection with the counter indemnity, the supplemental shareholder agreement or the loan notes as defined in this deed
    Kurze Angaben
    (See doc m 276 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambro Group Investments Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0