SYNDICATE NINE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSYNDICATE NINE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02183619
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SYNDICATE NINE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich SYNDICATE NINE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Howick Place
    SW1P 1WG London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SYNDICATE NINE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HACKREMCO (NO. 356) LIMITED26. Okt. 198726. Okt. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SYNDICATE NINE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für SYNDICATE NINE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    SeitenGAZ2(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Florise Ah Fong Wan als Geschäftsführer am 29. Apr. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Carl Sheldon Adrian als Direktor am 29. Apr. 2019

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Florise Ah Fong Wan am 07. Dez. 2018

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF zum 5 Howick Place London SW1P 1WG am 06. Dez. 2018

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Crosswall Nominees Limited am 04. Dez. 2018

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Crosswall Nominees Limited am 04. Dez. 2018

    1 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Unm Investments Limited am 04. Dez. 2018

    1 SeitenCH02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 13. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 9
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 12. Mai 2015

    • Kapital: GBP 9
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Crosswall Nominees Limited am 16. Feb. 2015

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Direktors für Unm Investments Limited am 16. Feb. 2015

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Crosswall Nominees Limited am 16. Feb. 2015

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ludgate House. 245,Blackfriars Road. London. SE1 9UY. zum 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF am 17. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von SYNDICATE NINE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    992770004
    ADRIAN, Carl Sheldon
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish134006860001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    992770004
    UNM INVESTMENTS LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    48157320003
    BURNS, John Macgregor
    58 Wickham Hill
    BN6 9NP Hurstpierpoint
    Sussex
    Sekretär
    58 Wickham Hill
    BN6 9NP Hurstpierpoint
    Sussex
    British550170001
    BROADLEY, Robert
    Abbeydale
    48 Chiselhurst Road
    BR7 5LD Chiselhurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Abbeydale
    48 Chiselhurst Road
    BR7 5LD Chiselhurst
    Kent
    British13726050001
    BURNS, John Macgregor
    58 Wickham Hill
    BN6 9NP Hurstpierpoint
    Sussex
    Geschäftsführer
    58 Wickham Hill
    BN6 9NP Hurstpierpoint
    Sussex
    United KingdomBritish550170001
    STERN, Charles Roger
    Hunters Lodge
    5 Belsize Lane
    NW3 5AD London
    Geschäftsführer
    Hunters Lodge
    5 Belsize Lane
    NW3 5AD London
    British4072000001
    WAN, Florise Ah Fong
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish137152590001
    WILSON, Graham John Stewart
    Mardon
    TQ13 8LX Moretonhampstead
    Devon
    Geschäftsführer
    Mardon
    TQ13 8LX Moretonhampstead
    Devon
    British52969380001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SYNDICATE NINE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    England
    30. Juni 2016
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    England
    Nein
    RechtsformUnlimited With Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer152298
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SYNDICATE NINE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 02. Nov. 1989
    Geliefert am 14. Nov. 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £12,000,000 and all other moneys due or to become due from the company to united newspapers PLC under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    Ludgate house, 245 blackfriars road, london SE1 freehold title no sgl 486404 and land leasehold title no tgl 4186.
    Berechtigte Personen
    • United Newspapers PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    Agreement
    Erstellt am 08. Aug. 1988
    Geliefert am 10. Aug. 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 17/3/88
    Kurze Angaben
    All syndicate nine limited's percentage interest under the said agreement in & to all that parcel of land situate at invicta playa, 245 blackfriars road, london SE1 title no:- sgl 486404 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Workyard Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    Assignment of rentals and other earnings
    Erstellt am 17. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or workyard limited to the chargee under the terms of a facility agreement of even date.
    Kurze Angaben
    All the right title & interest of the company as trustee in & to all monies due & to become due to the company under 1) an agreement for lease dated 17/03/1998) 2) the occupational lease to be entered into pursuant to the agreement for lease above mentioned 3) any & all instruments securing in favour of the company the obligations of any of the parties (other than the company & workyard LTD) under the instruments mentioned in sub-paragraphs 1 & 2 above to the company & in & to any & all claims & causes for action or money, loss or damages or compensation that may accrue or belong to the company arising part of or in any way connected with the presentor future lettings (see form M395 ref: M283/31-3/ln for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia.
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    Assignment of building contract.
    Erstellt am 17. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or workyard limited to the chargee under the terms of a facility agreement of even date.
    Kurze Angaben
    All the respective rights title & interest of the company, as trustee, in or to: I) a building contract dated 29-7-1987, an amended on 23-12-1987, relative to the development of the property at 245, blackfriars road, london SE1. Ii) the benefit of any & all rights of whatsoever nature that may at any time be assigned to, or otherwise accrue for the benefit of, the company, in respect of the matters more particularly mentioned in clause 13.2 and 13.3 of an agreement dated 22-6-1987 between kings reach development company limited a workyard limited. (Please refer to form M395 for full details ref- M301/31-3/ln).
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia.
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 17. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or workyard limited to the chargee under the terms of a facility agreement of even date.
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/a 245 blackfriars road, london SE1 t/no- sgl 486404 all buildings & erections now or hereafter to be erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia.
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0