SYNDICATE NINE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SYNDICATE NINE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02183619 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SYNDICATE NINE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SYNDICATE NINE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Howick Place SW1P 1WG London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SYNDICATE NINE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HACKREMCO (NO. 356) LIMITED | 26. Okt. 1987 | 26. Okt. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SYNDICATE NINE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SYNDICATE NINE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Florise Ah Fong Wan als Geschäftsführer am 29. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Carl Sheldon Adrian als Direktor am 29. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Florise Ah Fong Wan am 07. Dez. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF zum 5 Howick Place London SW1P 1WG am 06. Dez. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Crosswall Nominees Limited am 04. Dez. 2018 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Crosswall Nominees Limited am 04. Dez. 2018 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Unm Investments Limited am 04. Dez. 2018 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Crosswall Nominees Limited am 16. Feb. 2015 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Unm Investments Limited am 16. Feb. 2015 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Crosswall Nominees Limited am 16. Feb. 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ludgate House. 245,Blackfriars Road. London. SE1 9UY. zum 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF am 17. Apr. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SYNDICATE NINE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Sekretär | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | 992770004 | |||||||
| ADRIAN, Carl Sheldon | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 134006860001 | |||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | 992770004 | |||||||
| UNM INVESTMENTS LIMITED | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | 48157320003 | |||||||
| BURNS, John Macgregor | Sekretär | 58 Wickham Hill BN6 9NP Hurstpierpoint Sussex | British | 550170001 | ||||||
| BROADLEY, Robert | Geschäftsführer | Abbeydale 48 Chiselhurst Road BR7 5LD Chiselhurst Kent | British | 13726050001 | ||||||
| BURNS, John Macgregor | Geschäftsführer | 58 Wickham Hill BN6 9NP Hurstpierpoint Sussex | United Kingdom | British | 550170001 | |||||
| STERN, Charles Roger | Geschäftsführer | Hunters Lodge 5 Belsize Lane NW3 5AD London | British | 4072000001 | ||||||
| WAN, Florise Ah Fong | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 137152590001 | |||||
| WILSON, Graham John Stewart | Geschäftsführer | Mardon TQ13 8LX Moretonhampstead Devon | British | 52969380001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SYNDICATE NINE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubmg Holdings | 30. Juni 2016 | Blackfriars Road SE1 8BF London 240 England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SYNDICATE NINE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 02. Nov. 1989 Geliefert am 14. Nov. 1989 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £12,000,000 and all other moneys due or to become due from the company to united newspapers PLC under the terms of this charge | |
Kurze Angaben Ludgate house, 245 blackfriars road, london SE1 freehold title no sgl 486404 and land leasehold title no tgl 4186. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement | Erstellt am 08. Aug. 1988 Geliefert am 10. Aug. 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 17/3/88 | |
Kurze Angaben All syndicate nine limited's percentage interest under the said agreement in & to all that parcel of land situate at invicta playa, 245 blackfriars road, london SE1 title no:- sgl 486404 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of rentals and other earnings | Erstellt am 17. März 1988 Geliefert am 31. März 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or workyard limited to the chargee under the terms of a facility agreement of even date. | |
Kurze Angaben All the right title & interest of the company as trustee in & to all monies due & to become due to the company under 1) an agreement for lease dated 17/03/1998) 2) the occupational lease to be entered into pursuant to the agreement for lease above mentioned 3) any & all instruments securing in favour of the company the obligations of any of the parties (other than the company & workyard LTD) under the instruments mentioned in sub-paragraphs 1 & 2 above to the company & in & to any & all claims & causes for action or money, loss or damages or compensation that may accrue or belong to the company arising part of or in any way connected with the presentor future lettings (see form M395 ref: M283/31-3/ln for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of building contract. | Erstellt am 17. März 1988 Geliefert am 31. März 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or workyard limited to the chargee under the terms of a facility agreement of even date. | |
Kurze Angaben All the respective rights title & interest of the company, as trustee, in or to: I) a building contract dated 29-7-1987, an amended on 23-12-1987, relative to the development of the property at 245, blackfriars road, london SE1. Ii) the benefit of any & all rights of whatsoever nature that may at any time be assigned to, or otherwise accrue for the benefit of, the company, in respect of the matters more particularly mentioned in clause 13.2 and 13.3 of an agreement dated 22-6-1987 between kings reach development company limited a workyard limited. (Please refer to form M395 for full details ref- M301/31-3/ln). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. März 1988 Geliefert am 31. März 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or workyard limited to the chargee under the terms of a facility agreement of even date. | |
Kurze Angaben F/Hold property k/a 245 blackfriars road, london SE1 t/no- sgl 486404 all buildings & erections now or hereafter to be erected thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0