COTT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | COTT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02186825 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COTT LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich COTT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COTT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CRYSTAL DRINKS LIMITED | 29. Feb. 1988 | 29. Feb. 1988 |
TOTALITEM LIMITED | 02. Nov. 1987 | 02. Nov. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COTT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COTT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. März 2022 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JA verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR United Kingdom zum Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JA geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Aimia Foods Limited Penny Lane Haydock Merseyside WA11 0QZ United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 29. März 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2019 bis 30. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Nov. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jason Robert Ausher als Geschäftsführer am 18. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 021868250011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 021868250010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Matthew James Vernon als Direktor am 30. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Cott Retail Brands Limited as a person with significant control on 26. Juni 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COTT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUIRE PATTON BOGGS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham Rutland House West Midlands United Kingdom |
| 73037780028 | ||||||||||
DUFFY, Claire | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | Solicitor | 223323570002 | ||||||||
KITCHING, Steven | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | Director | 223323760001 | ||||||||
VERNON, Matthew James | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | Director | 203388960001 | ||||||||
MAIN, David Robert | Sekretär | 1 The Courtyard Farm Lane CV22 6NL Easenhall Warwickshire | British | Director Secretary | 76779080003 | |||||||||
SMITH, Michael Andrew | Sekretär | 91 Hilltop Lane Chaldon CR3 5BL Caterham Surrey | British | Chartered Accountant | 54939000001 | |||||||||
YOUNG, Brian | Sekretär | Orchard Lodge 59 Station Road Hemsworth WF9 5LN Pontefract West Yorkshire | English | 13790460001 | ||||||||||
HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
AUSHER, Jason Robert | Geschäftsführer | Corporate Center Iii At Intgernational Plaza Suite 400, 4221 W. Boyu Scout Blvd Tampa Cott Corporation Florida United States | United States | American | Director | 188769770001 | ||||||||
BIRRELL, Christopher Thomas Frederick | Geschäftsführer | 9 Bedford Avenue Silsoe MK45 4ER Bedford Bedfordshire | British | Director | 64191360002 | |||||||||
BRENNAN, Catherine Marie Helen | Geschäftsführer | Sunnylea Avenue East Toronto Ontario M87 2k5 63 Canada | Canadian | Corporate Treasurer | 133301470001 | |||||||||
CORBY, Stephen | Geschäftsführer | Citrus Grove Sideley Kegworth DE74 2FJ Derby | England | British | Managing Director | 176624850001 | ||||||||
DICKINSON, Michael John | Geschäftsführer | Chiddingfold Cottage Northfield Lane Highburton HD8 0QT Huddersfield West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 8083230001 | |||||||||
FOWDEN, Jeremy Stephen Gary | Geschäftsführer | The Paddocks 33 Twyford Road Barrow On Trent DE73 7HA Derby Derbyshire | British | Director | 125265950001 | |||||||||
HALLALA, Mark John | Geschäftsführer | 7 Beauchamp Road KT8 0PA East Molesey Surrey | British | Chartered Accountant | 37953240002 | |||||||||
HOYLE, Jeremy Stephen | Geschäftsführer | Citrus Grove Sideley Kegworth DE74 2FJ Derby | England | British | Director | 153317170002 | ||||||||
JOYNSON, Andrew Douglas Stuart | Geschäftsführer | Farm Southam Road Napton On The Hill CV47 8NG Southam Red House Warwickshire United Kingdom | British | Operations Director | 133301820001 | |||||||||
KETTELL, David Robert | Geschäftsführer | 5 Tong Lane Tong BD4 0RR Bradford West Yorkshire | England | British | Investment Manager | 5765250001 | ||||||||
KITCHING, Steven | Geschäftsführer | Citrus Grove Sideley Kegworth DE74 2FJ Derby | United Kingdom | British | Managing Director | 133273740001 | ||||||||
LEITER, Gregory | Geschäftsführer | Citrus Grove Sideley Kegworth DE74 2FJ Derby | Usa | United States | Corporate Controller | 140195590001 | ||||||||
LESTER, Simon Edmund George | Geschäftsführer | 160 Rochester Avenue Toronto Ontario M4n Ip3 Canada | British | Company Director | 37781660002 | |||||||||
LLOYD-DAVIES, Joanne | Geschäftsführer | Citrus Grove Sideley Kegworth DE74 2FJ Derby | England | British | Solicitor | 176624840002 | ||||||||
MACKIE, Brian | Geschäftsführer | 36 Fairlawn Park Kettlewell Hill GU21 4HT Woking Surrey | British | Finance Director | 41472140002 | |||||||||
MAIN, David Robert | Geschäftsführer | 1 The Courtyard Farm Lane CV22 6NL Easenhall Warwickshire | British | Director Secretary | 76779080003 | |||||||||
MASON, Robert Andrew | Geschäftsführer | 22 Howe Drive HP9 2BG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Director | 40909900001 | ||||||||
MURFIN, Andrew James | Geschäftsführer | 48 Hawthorne Way Shelley HD8 8JX Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 68921430001 | ||||||||
POUND, Peter Leslie | Geschäftsführer | 18 Chedworth Close Darton S75 5PR Barnsley South Yorkshire | British | Company Director | 13790480002 | |||||||||
PRESLAR, B Clyde | Geschäftsführer | 11913 Marblehead Drive FOREIGN Tampa Florida 33626 | American | Chief Financial Officer | 114826450001 | |||||||||
SAUNDERS, Gary Edward | Geschäftsführer | 16 Lansdowne Road TN1 2NJ Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Finance & Operations Director | 64191540001 | ||||||||
SCOTT, Anthony Gavin | Geschäftsführer | 3 Beechwood Dale Ackworth WF7 7NP Pontefract West Yorkshire | British | Company Director | 13790490001 | |||||||||
SILCOCK, Raymond Peter | Geschäftsführer | 1101 Mews Lane West Chester Pennsylvania 19382 Usa | British | Chief Financial Officer | 64205790002 | |||||||||
THOMPSON, Neil | Geschäftsführer | Oaklea House Roman Grange Little Aston Park B74 3GA Sutton Coldfield | British | Managing Director | 93042170001 | |||||||||
TURNER, Michael John | Geschäftsführer | Citrus Grove Sideley Kegworth DE74 2FJ Derby | United Kingdom | British | Technical Director | 121920530001 | ||||||||
VERNON, Matthew James | Geschäftsführer | Citrus Grove Sideley Kegworth DE74 2FJ Derby | England | British | Director | 203388960001 | ||||||||
WALKER, Colin | Geschäftsführer | 175 Meridene Crescent London Ontario N5x 1g3 Canada | Canadian | Senior Vice President | 115337890001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COTT LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cott Retail Brands Limited | 06. Apr. 2016 | Penny Lane Haydock WA11 0QZ St. Helens C/O Aimia Foods England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat COTT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 30. Jan. 2018 Geliefert am 02. Feb. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 03. Aug. 2016 Geliefert am 12. Aug. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Trademark "sunvill" with registration number 580919. trademark "sunquen" with registration number 735064. see instrument for further details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Aug. 2010 Geliefert am 23. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 2008 Geliefert am 03. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the loan parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 2005 Geliefert am 11. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Jan. 1997 Geliefert am 06. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 26. Nov. 1992 Geliefert am 03. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of a fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 2ND may 1989. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Juli 1991 Geliefert am 18. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See for 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 11. Apr. 1990 Geliefert am 27. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold land fronting wakefield road featherstone with all buildings and fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Feb. 1988 Geliefert am 15. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A. premises at 14 wakefield road featherstone west yorkshire incorporating the strip of land fronting directly onto wakefield road featherstone B. land at priory road featherstone west yorkshire C. premises at 1 fenton street tingley, west yorkshire (please see doc for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Feb. 1988 Geliefert am 04. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben 1) f/h land and buildings k/a 1 fenton street tingley t/n wyk 337396 (please see form m 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat COTT LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0