STROBE 3

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTROBE 3
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 02188184
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STROBE 3?

    • (7487) /

    Wo befindet sich STROBE 3?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von STROBE 3?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LUMINAR LEISURE LIMITED16. Juli 200116. Juli 2001
    NORTHERN LEISURE LIMITED30. Nov. 199330. Nov. 1993
    WHITEGATE LEISURE PLC15. Dez. 198715. Dez. 1987
    HARVESTING PUBLIC LIMITED COMPANY03. Nov. 198703. Nov. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STROBE 3?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2008

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für STROBE 3?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für STROBE 3?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juni 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Dez. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juni 2013

    15 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 43-45 Portman Square London W1H 6LY am 22. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juni 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Dez. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juni 2012

    5 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    19 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2011

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2010

    16 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    28 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Euro House 1394 High Road London N20 9YZ am 12. März 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2008

    25 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von STROBE 3?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARDEN, Christian
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish62937340001
    BARRETT, David William
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    EnglandBritish2264460001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Sekretär
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    British6945830001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Sekretär
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Sekretär
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    SMITH, Peter Anthony
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    Sekretär
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    British71842080001
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Sekretär
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Sekretär
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    ARNOLD, Michael John
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    British48184650002
    AUST, Jonathan Neale
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    Geschäftsführer
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    EnglandBritish160178570001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish68970050002
    BEIGHTON, Nicholas Timothy
    Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    8
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    8
    Hertfordshire
    UkBritish107221780003
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Geschäftsführer
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    CASSELS, Alexander
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British566790001
    GILLY, Edward Pierre
    Suite 15 Edgecliff Mews
    201 New South Head Road Edgecliff
    Sydney 2027
    Australia
    Geschäftsführer
    Suite 15 Edgecliff Mews
    201 New South Head Road Edgecliff
    Sydney 2027
    Australia
    Australian68452000001
    HANSON, James Donald
    18 Thurloe Place
    SW7 2SP London
    Geschäftsführer
    18 Thurloe Place
    SW7 2SP London
    British45201690007
    LOADES, Stephen
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish77619750001
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    British6945830001
    MANSER, Ronald Douglas
    34 Warren Road
    Double Bay
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2028
    Australia
    Geschäftsführer
    34 Warren Road
    Double Bay
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2028
    Australia
    Australian68452010001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Geschäftsführer
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MARKS, Peter Jack
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritish77895710001
    MARSHALL, Anthony
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish155979460001
    MASSEY, Graham
    134 Newton Drive
    FY3 8JB Blackpool
    Geschäftsführer
    134 Newton Drive
    FY3 8JB Blackpool
    British34414530001
    MCDONALD, Robert James
    Darnford Lane
    WS14 9JQ Lichfield
    Whittington Hill House
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Darnford Lane
    WS14 9JQ Lichfield
    Whittington Hill House
    Staffordshire
    EnglandBritish157701860001
    MCENHILL, Peter Raymond
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    British65346840001
    MCIVOR, Andrew
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    Geschäftsführer
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    British61144120003
    MCLOUGHLIN, Brendan Michael
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    Geschäftsführer
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    United KingdomBritish40530320004
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    British4058810004
    OPPENHEIM, James Nicholas
    33 King Street
    SW1Y 6RJ London
    Geschäftsführer
    33 King Street
    SW1Y 6RJ London
    United KingdomBritish26933450003
    PATTISSON, John Harmer
    1c Elm Place
    SW7 3QH London
    Geschäftsführer
    1c Elm Place
    SW7 3QH London
    British23743570001
    PRESTON, Clive Henry
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    EnglandBritish1973870004

    Hat STROBE 3 Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed dated 20 february 2009 creating a floating charge
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge its undertaking and all its assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed creating a floating charge
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge its undertaking and all its assets both present and future see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 30. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditor
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 22. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 28. März 2001
    Geliefert am 09. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future monies debts and liabilities due or to become due from any chargor to the chargee as security trustee (the "security trustee") as security trustee for the benefit of the secured creditors (as defined) in relation to any of the creditor finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 16. Nov. 1999
    Geliefert am 22. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the beneficiaries) under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge the undertaking and assets present & future.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Aug. 1998
    Geliefert am 18. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (as defined therein) to the chargee under or in respect of (a) a loan agreement dated 9 september 1996 (as amended by supplemental agreements dated 29 august 1997 and 12 august 1998 and as amended from time to time); (b) the debenture; (c) any other monies incurred by the chargee under this security or any other security; (d) any other monies owing to the chargee on any other account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Aug. 1998
    Geliefert am 18. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (as defined therein) to the chargee under or in respect of (a) a loan agreement dated 9 september 1996 (as amended by supplemental agreements dated 29 august 1997 and 12 august 1998 and as amended from time to time); (b) the debenture; (c) any other monies incurred by the chargee under this security or any other security; (d) any other monies owing to the chargee on any other account whatsoever
    Kurze Angaben
    First legal mortgage over all the interest in land and fixtures;first fixed charge over plant and machinery uncalled capital debts & goodwill; first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Aug. 1998
    Geliefert am 18. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (as defined therein) to the chargee under or in respect of (a) a loan agreement dated 9 september 1996 (as amended by supplemental agreements dated 29 august 1997 and 12 august 1998 and as amended from time to time); (b) the debenture; (c) any other monies incurred by the chargee under this security or any other security; (d) any other monies owing to the chargee on any other account whatsoever
    Kurze Angaben
    First legal mortgage over all the interest in land and fixtures; first fixed charge over plant and machinery uncalled capital debts & goodwill; first floating charge over all other present and future assets of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A supplemental deed
    Erstellt am 29. Aug. 1997
    Geliefert am 15. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement, the debenture and the guarantee (all as defined)
    Kurze Angaben
    Are charged to the bank in accordance with clause 2 of the debenture as amended by the supplemental deed. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A supplemental deed
    Erstellt am 29. Aug. 1997
    Geliefert am 19. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement, the debenture and the guarantee (all as defined)
    Kurze Angaben
    Are charged to the bank in accordance with clause 2 of the debenture as amended by the supplemental deed. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A supplemental deed
    Erstellt am 29. Aug. 1997
    Geliefert am 15. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the loan agreement (as defined), the debenture (as defined) and the guarantee (as defined)
    Kurze Angaben
    All of the property assets and undertaking of the company are charged to the bank in accordance with clause 2 of the debenture as amended by the supplemental deed.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Sept. 1996
    Geliefert am 18. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any liability of either the chargor or northern leisure inc. PLC to the chargee under or in respect of a facility agreement dated 9TH september 1996 the debenture and a guarantee dated 9TH september 1996
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Sept. 1996
    Geliefert am 18. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any liability of either the chargor or northern leisure inc. PLC to the chargee under or in respect of a facility agreement dated 9TH september 1996 the debenture and a guarantee dated 9TH september 1996
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Sept. 1996
    Geliefert am 18. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any liability of either the chargor or northern leisure inc. PLC to the chargee under or in respect of a facility agreement dated 9TH september 1996 the debenture and a guarantee dated 9TH september 1996
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture`
    Erstellt am 19. Apr. 1995
    Geliefert am 27. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the royal bank of soctland PLC- as agent and trustee for itself and for each of the banks, as defined ) under or pursuant to the terms of the revolving credit facility agreement dated 13TH march 1995 and /or this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,,National Westminster Bank PLC. the Governor and Company of Thebank of Scotland ,Collectively " the Banks"
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 08. Juli 1994
    Geliefert am 21. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as trustee for the stockholders (in this capacity the "trustee") under the terms of or in respect of the trust deed, the original stock, any further stock, this composite debenture and the composite guarantee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 21. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 06. Nov. 1992
    Geliefert am 18. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or in respect of a revolving credit facility agreement,a composite debenture and a composite guarantee all dated 24TH december 1991 or any other security as defined in this assignment
    Kurze Angaben
    All the right,title,benefit and interest in the guarantee dated 6TH november 1992,a share purchase agreement dated 6TH october 1992 and an inter company loan (see doc ref M522C for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 24. Dez. 1991
    Geliefert am 07. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the security documents as defined
    Kurze Angaben
    See doc ref M566C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat STROBE 3 Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. März 2010Beginn der Verwaltung
    01. Juli 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul John Clark
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    DatumTyp
    01. Juli 2011Beginn der Liquidation
    26. Feb. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul John Clark
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0