COMMERCIAL FINISHES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOMMERCIAL FINISHES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02189055
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COMMERCIAL FINISHES LIMITED?

    • (2875) /

    Wo befindet sich COMMERCIAL FINISHES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COMMERCIAL FINISHES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DAVIS ENGINEERING (REDDITCH) LIMITED05. Aug. 198805. Aug. 1988
    BUREX LIMITED05. Nov. 198705. Nov. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COMMERCIAL FINISHES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für COMMERCIAL FINISHES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 Seiten4.72

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:miscellaneous copy of form 2.34B
    1 SeitenLIQ MISC

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Feb. 2012

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    5 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    31 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    30 Seiten2.17B

    Beendigung der Bestellung von Richard Kenneth Mattey als Geschäftsführer am 30. Aug. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Kenneth Mattey als Sekretär am 30. Aug. 2011

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Trentham House Red Lion Street Alvechurch Birmingham B48 7LF am 30. Aug. 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    5 SeitenMG01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 28. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 30. Juni 2010

    • Kapital: GBP 1,000,000
    4 SeitenSH01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Paul Robert James Burman am 06. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Timothy James Smith am 06. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Kenneth Mattey am 06. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Richard Kenneth Mattey am 06. Nov. 2009

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von COMMERCIAL FINISHES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURMAN, Paul Robert James
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    United KingdomBritish5664750002
    SMITH, Timothy James
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    EnglandBritish106911160002
    HUDSON, Colin John
    59 Hither Green Lane
    B98 9BN Redditch
    Worcestershire
    Sekretär
    59 Hither Green Lane
    B98 9BN Redditch
    Worcestershire
    British5664760001
    MATTEY, Richard Kenneth
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    Sekretär
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    British80594170001
    CHADWICK, Malcolm John
    29 Green Farm End
    Kineton
    CV35 0LD Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    29 Green Farm End
    Kineton
    CV35 0LD Warwick
    Warwickshire
    British27596190001
    DAVIS, Antony John
    Hollymeade
    Brandheath Lane New End Astwood Bank
    B96 6NG Redditch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Hollymeade
    Brandheath Lane New End Astwood Bank
    B96 6NG Redditch
    Worcestershire
    British40192890001
    HUDSON, Colin John
    59 Hither Green Lane
    B98 9BN Redditch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    59 Hither Green Lane
    B98 9BN Redditch
    Worcestershire
    British5664760001
    KELSEY, Nathan
    41 Lansdowne Road
    WR1 1SP Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    41 Lansdowne Road
    WR1 1SP Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish77549060001
    MATTEY, Richard Kenneth
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    West Midlands
    United KingdomBritish80594170001
    OWEN, Steven David
    35 Kingfisher Close
    WR5 3RY Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    35 Kingfisher Close
    WR5 3RY Worcester
    Worcestershire
    British39495590001
    SPACIE, David Ian
    70 Hertford Road
    B49 6AR Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    70 Hertford Road
    B49 6AR Alcester
    Warwickshire
    British27596180001
    STEWART, Robert William
    Underbank Old Road
    HD9 1AS Holmfirth
    114
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Underbank Old Road
    HD9 1AS Holmfirth
    114
    West Yorkshire
    British131622860001
    WILSON, Christopher John
    New Inn Farm
    OX3 9TY Beckley
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    New Inn Farm
    OX3 9TY Beckley
    Oxfordshire
    United KingdomBritish28089530003

    Hat COMMERCIAL FINISHES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 21. Juni 2011
    Geliefert am 02. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 30. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2009
    Geliefert am 25. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Centric Spv 1 Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2009
    Geliefert am 18. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 05TH september 1994
    Erstellt am 05. Juni 2006
    Geliefert am 09. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 05. Dez. 2005
    Geliefert am 07. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Heller Limited
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Erstellt am 16. Mai 2005
    Geliefert am 18. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5TH september 1994 and
    Erstellt am 22. Juni 2004
    Geliefert am 29. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum of sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge over book debts
    Erstellt am 19. Sept. 1991
    Geliefert am 20. Sept. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a factoring agreement leasing agreement.
    Kurze Angaben
    All other book and other debts and claims both present & future (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Trade Indemnity-Meller Commercial Finance LTD
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    Single debenture
    Erstellt am 09. Feb. 1988
    Geliefert am 11. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 05. Dez. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat COMMERCIAL FINISHES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Feb. 2012Ende der Verwaltung
    19. Aug. 2011Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Harry Gilbert
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    2
    DatumTyp
    29. Juli 2013Aufgelöst am
    17. Feb. 2012Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Harry Gilbert
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0