HERMES LEASE FINANCE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HERMES LEASE FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02191403 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HERMES LEASE FINANCE LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich HERMES LEASE FINANCE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | ERNST & YOUNG LLP 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HERMES LEASE FINANCE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HERMES LEASE FINANCE PLC | 19. März 1998 | 19. März 1998 |
| COMBINED LEASE FINANCE PLC | 01. Jan. 1988 | 01. Jan. 1988 |
| BUDGETVALUE PUBLIC LIMITED COMPANY | 11. Nov. 1987 | 11. Nov. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HERMES LEASE FINANCE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HERMES LEASE FINANCE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2012 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Singers House Dorking Business Park Station Road Dorking Surrey RH4 1HJ England am 24. Apr. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Juli 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | CERT10 | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 26 Seiten | MAR | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2 Seiten | RR02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Catriona Macinnes Smith am 30. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr James Gerrard Cannon als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Catriona Macinnes Smith als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kaupthing House the Dorking Business Park, Station Road Dorking Surrey RH4 1HJ am 22. Jan. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HERMES LEASE FINANCE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Catriona Macinnes | Sekretär | Dorking Business Park Station Road RH4 1HJ Dorking Singers House Surrey England | 148429890001 | |||||||
| CANNON, James Gerrard | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 62479310001 | |||||
| PYMAN, Richard Anthony | Geschäftsführer | Atwood Road W6 0HX London 17 | England | British | 45019790003 | |||||
| AUJARD, Christopher Charles | Sekretär | Seymore Oast Back Street ME17 1TF Leeds Kent | Australian | 103389330001 | ||||||
| DOHERTY, Stephen Paul | Sekretär | 4 Woodgrange Close Thorpe Bay SS1 3EA Southend On Sea Essex | British | 41519220002 | ||||||
| FORMBY, Paul | Sekretär | 77 Higher Lane WA13 0BZ Lymm Cheshire | British | 20814730003 | ||||||
| HAY, Helen Frances | Sekretär | The Old Stable Yard Castle Yard Place MK43 7BB Odell Bedfordshire | British | 120089650001 | ||||||
| HEAVEY, Declan | Sekretär | 4 Greenpark Orwell Road IRISH Dublin 14 Ireland | Irish | 6690690002 | ||||||
| HILL, Trina Jeanne | Sekretär | 28 Hasse Road Soham CB7 5UW Ely Cambridgeshire | British | 110384430001 | ||||||
| HINTON-SMITH, Susan Marion | Sekretär | Ashrood Hightae DG11 1JL Lockerbie Dumfriesshire | British | 97621310001 | ||||||
| YOUNGS, James John | Sekretär | 29 Longlands Road DA15 7LU Sidcup Kent | British | 69552750001 | ||||||
| BARNES, Anthony Reginald | Geschäftsführer | Hollymount High Hurstwood TN22 4AE Uckfield East Sussex | English | 15423160001 | ||||||
| BARNES, Timothy Paul | Geschäftsführer | One Hanover Street W1S 1AX London | British | 10250630008 | ||||||
| BELL, Ronald Michael | Geschäftsführer | 11 Westdene Summerhouse Road GU7 1QL Godalming Surrey | United Kingdom | British | 34488960002 | |||||
| COULSON, Paul Richard | Geschäftsführer | Lisnacreive Stillorgan Park Blackrock Co Dublin Ireland | Irish | 63591120001 | ||||||
| FORMBY, Paul | Geschäftsführer | 77 Higher Lane WA13 0BZ Lymm Cheshire | British | 20814730003 | ||||||
| HADDON, David Paul | Geschäftsführer | Lanherne Heights Tredragon Close Trenance TR8 4DP Newquay Cornwall | British | 10040730002 | ||||||
| HARROP, John Edward | Geschäftsführer | 11 Barley Road Thelwali WA4 2EZ Warrington Cheshire | British | 34072350001 | ||||||
| HEAVEY, Declan | Geschäftsführer | 4 Greenpark Orwell Road IRISH Dublin 14 Ireland | Irish | 6690690002 | ||||||
| HINTON-SMITH, Susan Marion | Geschäftsführer | Ashrood Hightae DG11 1JL Lockerbie Dumfriesshire | British | 97621310001 | ||||||
| LE FEVRE, Kenneth Charles | Geschäftsführer | 14 Lansdown Avenue SS7 2UL Benfleet Essex | British | 20814740003 | ||||||
| OVENDEN, Brian George | Geschäftsführer | Closes House Grove Road Wickhambreaux CT3 1SJ Canterbury Kent | British | 37515660003 | ||||||
| PHELPS, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | Canabae 111 Brookfield Road Churchdown GL3 2PN Gloucester | British | 81926520001 | ||||||
| PRICE, Charles Beaufort | Geschäftsführer | Church House Manor Road RM4 1NA Lambourne End Essex | England | British | 51242320002 | |||||
| SMITH, Stephen Errol | Geschäftsführer | One Hanover Street W1S 1AX London | Great Britain | British | 61919370004 | |||||
| SPENCE, Jonathan Murgatroyd | Geschäftsführer | 14 Ormonde Road East Sheen SW14 7BG London | British | 42053080002 |
Hat HERMES LEASE FINANCE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Block discounting agreement | Erstellt am 04. März 2003 Geliefert am 22. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben With full title guarantee charges by way of first floating charge all its rightand interest in and to a) the contract rights and b) by way of first fixed charge all its right title and interest in and to the goods which are subject matterof any hire purchase agreement, conditional sale agreement or credit sale agreement or any hire agreement entered into at any time between the company and any C. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 18. Jan. 2000 Geliefert am 04. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific charge over the benefit of all leasing rental hire purchase or credit sale agreements as are now or may from time to time be entered into by the bt the company with its customers. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Block discounting agreement | Erstellt am 16. Juli 1999 Geliefert am 21. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this block discounting agreement | |
Kurze Angaben First floating charge of all right, title and interest in and to the debts and the assets as defined in the block discounting agreement dated 16 july 1999 relating to receivables purchased by the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Block discounting agreement | Erstellt am 03. Dez. 1998 Geliefert am 22. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben First floating charge over all indebtedness whatsoever with all guarantees and securities therefore and indemnities thereof and all liens,rights,title. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Master block discounting agreement | Erstellt am 16. Nov. 1998 Geliefert am 25. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Kurze Angaben First fixed charge all right titke and interest in and to the unassigned debts relating to the equipment the subject of any agreement in existance now or hereafter. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 04. Juni 1998 Geliefert am 15. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge all credit agreements leasing agreements and hire purchase agreements, all book debts and other debts, all securities and all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Master block discounting agreement | Erstellt am 20. Nov. 1997 Geliefert am 11. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the block discounting agreement | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all its right, title and interest in and to the unsold receivables relating to and the goods the subject of any customer agreement in existence now or hereafter.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 05. Juni 1997 Geliefert am 20. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All hiring, leasing and hire purchase agreements and all agreements under which the purchase price of goods sold is payable by instalments "the deposited agreements", all securities and the chattels comprised in the deposited agreements. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 28. Nov. 1996 Geliefert am 07. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from hermes group limited and/or hermes leasing limited and/or hermes leasing (london) limited and/or hermes leasing 9WESTERN) limited and/or h l holdings limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of any accounts of the company in the books of the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Okt. 1991 Geliefert am 06. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to n m rothschild & sons limited (as trustee for the agent and the beneficiaries) and the beneficiaries or any of them (as defined therein) under the terms of a facility agreement dated 29TH october 1991 and this charge the above entry was this day amended P.jones authorised officer 19TH february 1992 | |
Kurze Angaben See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HERMES LEASE FINANCE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0