GUESTPLAN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGUESTPLAN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02193310
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GUESTPLAN LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich GUESTPLAN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Pinsent Masons Llp
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GUESTPLAN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für GUESTPLAN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Aufschub der Auflösung (freiwillig)

    2 SeitenCOLIQ

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Part Ground Floor & First Floor Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal Birmingham B45 9PZ zum C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB am 20. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Juli 2017

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Patricia Lesley Lee als Geschäftsführer am 31. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 29. Juni 2017

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 28/06/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 20. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 289
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 289
    SH01

    Ernennung von Ms Patricia Lesley Lee als Direktor am 22. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Albert Edward Smith als Geschäftsführer am 22. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 289
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Katharine Kandelaki als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Verschiedenes

    Auditors resignation sec 519
    2 SeitenMISC

    Wer sind die Geschäftsführer von GUESTPLAN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANSON, David Lindsay
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    Geschäftsführer
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    United KingdomBritishDirector167628190001
    AMLANI, Pritesh
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    British125206220002
    BRODERICK, Dympna Patricia
    Postern Hill Barn
    Over Lane, Hazelwood
    DE56 4AG Belper
    Derbyshire
    Sekretär
    Postern Hill Barn
    Over Lane, Hazelwood
    DE56 4AG Belper
    Derbyshire
    British3725300002
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    160373680001
    BRODERICK, Anthony Philip
    Postern Hill Barn
    Over Lane, Hazelwood
    DE56 4AG Belper
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Postern Hill Barn
    Over Lane, Hazelwood
    DE56 4AG Belper
    Derbyshire
    United KingdomBritishCompany Director3725310002
    BRODERICK, Dympna Patricia
    Postern Hill Barn
    Over Lane, Hazelwood
    DE56 4AG Belper
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Postern Hill Barn
    Over Lane, Hazelwood
    DE56 4AG Belper
    Derbyshire
    EnglandBritishHealth Visitor3725300002
    BRODERICK, Patrick Joseph
    No 3 Holly Cottage Ridgeway On The Hill
    Crich Lane
    DE5 2LA Ambergate
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    No 3 Holly Cottage Ridgeway On The Hill
    Crich Lane
    DE5 2LA Ambergate
    Derbyshire
    BritishCompany Director63241990001
    LEE, Patricia Lesley
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    Geschäftsführer
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    PERRY, David William
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    Geschäftsführer
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    EnglandBritishDirector33988060002
    SMITH, Albert Edward
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77631340001
    TREON, Anoup
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    Geschäftsführer
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    United KingdomBritishDirector152212470001
    TREON, Jaynee Sunita
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    Geschäftsführer
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    United KingdomBritishDirector42532090004

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GUESTPLAN LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    06. Apr. 2016
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05872120
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat GUESTPLAN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 2012
    Geliefert am 03. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 25. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 11. Mai 2007
    Geliefert am 17. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rp&C International Investments Llc
    Transaktionen
    • 17. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    • 12. Juli 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Nov. 2006
    Geliefert am 13. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rp&C International Investments Llc
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    • 12. Juli 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Nov. 2006
    Geliefert am 02. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1998
    Geliefert am 07. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a a piece or parcel of land to the rear of 79 nottingham road spondon derby part t/no.DY109282. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 1997
    Geliefert am 19. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being land off beaumont street derby fixed charge all buildings & structures fixed charge over any goodwill and all plant machinery & chattels and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a st werburghs nursing home church street spondon derby together with allbuildings and other structures the goodwill relating to the property all plant machinery and other items thereon assigns the rental sums with the benefit of all rights and remedies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the laurels nursing home 77 nottingham road spondon derby together with all buildings and other structures the goodwill relating to the business all plant machinery and other items thereon assigns the rental sums with the benefit of all rights and remedies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at beafort street derby derbyshire together with all buildings and other structures the goodwill relating to the property all plant machinery and other items thereon assigns the rental sums with the benefit of all rights and remedies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Dez. 1996
    Geliefert am 08. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 1996
    Geliefert am 17. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the laurels nursing homes limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    77 nottingham road, spondon, derby, derbyshire t/no: DY15352.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 1989
    Geliefert am 05. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Okt. 1988
    Geliefert am 25. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The old vicarage, spondon, derbyshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GUESTPLAN LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Juli 2017Beginn der Liquidation
    09. Nov. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0