YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED

YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameYUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02197377
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP23 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LUCAS YUASA BATTERIES LTD.15. Juli 198815. Juli 1988
    LUCAS-YUASA BATTERIES LIMITED02. Juni 198802. Juni 1988
    ALNERY NO.650 LIMITED23. Nov. 198723. Nov. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis27. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Mr John Paul Alan Houmoller als Sekretär am 30. Apr. 2013

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Anthony Groves als Sekretär am 30. Apr. 2013

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Paul Anthony Groves als Geschäftsführer am 30. Apr. 2013

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    3 SeitenCC04

    Kapitalaufstellung am 25. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Articles of associaton deleted and in place model articles 23/04/2013
    RES13
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 27. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Masaaki Hirooka als Geschäftsführer am 07. Apr. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Satoshi Sugitani als Direktor am 07. Apr. 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 27. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Masaaki Hirooka als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Akio Furukawa als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOUMOLLER, John Paul Alan
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP23 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    Sekretär
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP23 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    178043190001
    SUGITANI, Satoshi
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP23 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    Geschäftsführer
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP23 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    United KingdomJapanese168300700001
    EMM, Andrew Timothy
    79 Kelvin Road
    CV32 7TG Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    79 Kelvin Road
    CV32 7TG Leamington Spa
    Warwickshire
    British13659380001
    GROVES, Paul Anthony
    Merry Meet
    Glasllwch Lane
    NP20 3PR Newport
    Sekretär
    Merry Meet
    Glasllwch Lane
    NP20 3PR Newport
    British126738760001
    JAYNE, Paul Darryl
    Brookfields
    Crickhowell
    NP8 1DJ Powys
    24
    South Wales
    Sekretär
    Brookfields
    Crickhowell
    NP8 1DJ Powys
    24
    South Wales
    British129208770001
    KANEKO, Hiromichi
    17 Sarno Square
    NP7 5JT Abergavenny
    Monmouthshire
    Sekretär
    17 Sarno Square
    NP7 5JT Abergavenny
    Monmouthshire
    Japanese99767560002
    KANEKO, Hiromichi
    15 Elkington Croft
    Monkspath
    B90 4PB Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    15 Elkington Croft
    Monkspath
    B90 4PB Solihull
    West Midlands
    Japanese99767560001
    KING, Andrew Mark
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    British96568110001
    KOJIRI, Shoken
    20 Malvern Park Avenue
    B91 3EA Solihull
    West Midlands
    England
    Sekretär
    20 Malvern Park Avenue
    B91 3EA Solihull
    West Midlands
    England
    Japanese68657510001
    LUNN, David Bryan
    2 Crantock Close
    Essington
    WV11 2ED Wolverhampton
    Sekretär
    2 Crantock Close
    Essington
    WV11 2ED Wolverhampton
    British62099080001
    STONES, Stephen Anthony
    Burley View
    Ullingswick
    HR1 3PL Hereford
    Herefordshire
    Sekretär
    Burley View
    Ullingswick
    HR1 3PL Hereford
    Herefordshire
    British48006190001
    WILLIAMSON, Christopher John
    Kingswood Vauxhall Lane
    NP6 5PZ Chepstow
    Gwent
    Sekretär
    Kingswood Vauxhall Lane
    NP6 5PZ Chepstow
    Gwent
    British29100650001
    BOMOTO, Toru
    1 Alderwood Place
    Princes Way
    B91 3HX Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    1 Alderwood Place
    Princes Way
    B91 3HX Solihull
    West Midlands
    Japanese68102230003
    CRESSALL, Peter Alan Gordon
    Aston Hall
    SY7 9EB Aston Dunslow
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Aston Hall
    SY7 9EB Aston Dunslow
    Shropshire
    British26420970001
    FURUKAWA, Akio
    Stoke Cottage Cherry Orchard Lane
    Llanwenarth
    NP7 7EP Abergavenny
    Geschäftsführer
    Stoke Cottage Cherry Orchard Lane
    Llanwenarth
    NP7 7EP Abergavenny
    JapanJapanese104414460001
    FURUKAWA, Hiroshi
    43 Ravenswood Drive South
    B91 3LP Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    43 Ravenswood Drive South
    B91 3LP Solihull
    West Midlands
    Japanese52553100001
    GROVES, Paul Anthony
    Merry Meet
    Glasllwch Lane
    NP20 3PR Newport
    Geschäftsführer
    Merry Meet
    Glasllwch Lane
    NP20 3PR Newport
    WalesBritish126738760001
    HALLOWS, Jack
    10 White House Way
    B91 1SE Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 White House Way
    B91 1SE Solihull
    West Midlands
    British13659400001
    HAMADA, Osamu
    8 Cotheridge Close
    B90 4LS Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    8 Cotheridge Close
    B90 4LS Solihull
    West Midlands
    Japanese81622820002
    HEATHER, Marcus
    Alderminster Road
    B91 3GL Solihull
    42
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Alderminster Road
    B91 3GL Solihull
    42
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish131597640001
    HIROOKA, Masaaki
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP23 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    Geschäftsführer
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP23 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    United KingdomJapanese147953400001
    KANEKO, Hiromichi
    17 Sarno Square
    NP7 5JT Abergavenny
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    17 Sarno Square
    NP7 5JT Abergavenny
    Monmouthshire
    Japanese99767560002
    KING, Andrew Mark
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish96568110001
    KOJIRI, Shoken
    20 Malvern Park Avenue
    B91 3EA Solihull
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    20 Malvern Park Avenue
    B91 3EA Solihull
    West Midlands
    England
    Japanese68657510001
    LITTLEJOHNS, Michael Ian
    Roseland
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Roseland
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    British77904210001
    LONG-LEATHER, Christopher
    88 High Street
    Hillmorton
    CV21 4EE Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    88 High Street
    Hillmorton
    CV21 4EE Rugby
    Warwickshire
    British13750060001
    MURATA, Kazuo
    9-10 Amaiwate-Cho
    FOREIGN Takatsuki
    Osaka
    Japan
    Geschäftsführer
    9-10 Amaiwate-Cho
    FOREIGN Takatsuki
    Osaka
    Japan
    Japanese55403750001
    NAKAMURA, Massaaki
    34 Darren View
    NP8 1DS Crickhowell
    Powys
    Geschäftsführer
    34 Darren View
    NP8 1DS Crickhowell
    Powys
    British45353020001
    OKAMOTO, Kenichi
    Greenlands Church Close
    NP8 1NY Llangynidr
    Powys
    Geschäftsführer
    Greenlands Church Close
    NP8 1NY Llangynidr
    Powys
    Japanese52552980001
    OTSUBO, Naruo
    5-53-4 Matsubara
    Setagaya-Ku 156
    Japan
    Geschäftsführer
    5-53-4 Matsubara
    Setagaya-Ku 156
    Japan
    Japanese41324010001
    PLANT, John Charles
    The Homestead
    Peachfield Road
    WR14 3LE Malvern
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The Homestead
    Peachfield Road
    WR14 3LE Malvern
    Worcestershire
    British62694340001
    SAHASHI, Hiroshi
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP3 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    Geschäftsführer
    Unit 22
    Rassau Industrial Estate
    NP3 5SD Ebbw Vale
    Gwent
    Japanese13659430001
    SAKAI, Yasueazu
    No D 1102 Kamakura Rojiman
    1241-4 Okamoto Kamaura-6n1
    Japan
    Geschäftsführer
    No D 1102 Kamakura Rojiman
    1241-4 Okamoto Kamaura-6n1
    Japan
    Japanese26420990002
    SATO, Takashi
    15 Beaufort Avenue
    Llangattock
    NP8 1PN Crickhowell
    Powys
    Geschäftsführer
    15 Beaufort Avenue
    Llangattock
    NP8 1PN Crickhowell
    Powys
    Japanese69361890001
    STONES, Stephen Anthony
    Burley View
    Ullingswick
    HR1 3PL Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Burley View
    Ullingswick
    HR1 3PL Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish48006190001

    Hat YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 15. Juni 2006
    Geliefert am 23. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Formans road/cole valley industrial site tysley, birmingham, west midlands t/n's WM444713 & WM638287. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 08. Juli 1999
    Geliefert am 19. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or arising in connection with the facility agreement dated 15 november 1990
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 5 merrington close solihull t/n WM349823 and all fixtures and fittings fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Sakura Bank Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 08. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or arising in connection with the facility agreement (as defined) and the supplemental debenture
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a 5 merrington close solihull t/no: WM349823 together with all fixtures and fitting (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery owned by the company from time to time thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Sakura Bank, Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 1999
    Geliefert am 10. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) under any of the finance documents
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h land and premises lying to the southwest of weston lane tyseley and land and premises lying to the north of formans road sparkhill t/n-WM444713. F/h land and premises lying to the north side of formans road sparkhill t/n-WM638287. F/h land and premises k/a 5 merrington close hillfield solihull t/n-WM349823. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limitedas Security Trustee for the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 10. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Agreement and legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 1998
    Geliefert am 21. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £600,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Tyseley industrial site,formans rd,sparkhill,birmingham.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham City Council
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Jan. 1997
    Geliefert am 04. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or arising in connection with the facility agreement dated 15 november 1990 as amended 1 august 1991 and further amended by a deed dated 6 july 1995
    Kurze Angaben
    Land to the north of formans road sparkhill t/n WM638287.
    Berechtigte Personen
    • The Sakura Bank Limited
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 1996
    Geliefert am 09. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or arising in connection with the facility letter agreement dated 30TH december 1996 whereby the bank has made availible to the company a revolving cash advances facility of up to £2,000,000 and all other monies due under the debenture
    Kurze Angaben
    Lucas yuasa battery works and situate to the southwest of weston lane tysley and land to the north of formans road sparkhill birmingham t/no.WM444713 but excluding that part of such land comprising 1.63 acres transferred to birmingham city council on 18TH may 1990. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Nov. 1990
    Geliefert am 16. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of the facilities agreement of even date and the charge
    Kurze Angaben
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Mitsui Taiyo Kobe Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0