YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02197377 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 22 Rassau Industrial Estate NP23 5SD Ebbw Vale Gwent |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LUCAS YUASA BATTERIES LTD. | 15. Juli 1988 | 15. Juli 1988 |
| LUCAS-YUASA BATTERIES LIMITED | 02. Juni 1988 | 02. Juni 1988 |
| ALNERY NO.650 LIMITED | 23. Nov. 1987 | 23. Nov. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr John Paul Alan Houmoller als Sekretär am 30. Apr. 2013 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Anthony Groves als Sekretär am 30. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Anthony Groves als Geschäftsführer am 30. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 3 Seiten | CC04 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 25. Apr. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 27. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Masaaki Hirooka als Geschäftsführer am 07. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Satoshi Sugitani als Direktor am 07. Apr. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 27. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Masaaki Hirooka als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Akio Furukawa als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUMOLLER, John Paul Alan | Sekretär | Unit 22 Rassau Industrial Estate NP23 5SD Ebbw Vale Gwent | 178043190001 | |||||||
| SUGITANI, Satoshi | Geschäftsführer | Unit 22 Rassau Industrial Estate NP23 5SD Ebbw Vale Gwent | United Kingdom | Japanese | 168300700001 | |||||
| EMM, Andrew Timothy | Sekretär | 79 Kelvin Road CV32 7TG Leamington Spa Warwickshire | British | 13659380001 | ||||||
| GROVES, Paul Anthony | Sekretär | Merry Meet Glasllwch Lane NP20 3PR Newport | British | 126738760001 | ||||||
| JAYNE, Paul Darryl | Sekretär | Brookfields Crickhowell NP8 1DJ Powys 24 South Wales | British | 129208770001 | ||||||
| KANEKO, Hiromichi | Sekretär | 17 Sarno Square NP7 5JT Abergavenny Monmouthshire | Japanese | 99767560002 | ||||||
| KANEKO, Hiromichi | Sekretär | 15 Elkington Croft Monkspath B90 4PB Solihull West Midlands | Japanese | 99767560001 | ||||||
| KING, Andrew Mark | Sekretär | 23 Yew Croft Avenue Harborne B17 9TR Birmingham West Midlands | British | 96568110001 | ||||||
| KOJIRI, Shoken | Sekretär | 20 Malvern Park Avenue B91 3EA Solihull West Midlands England | Japanese | 68657510001 | ||||||
| LUNN, David Bryan | Sekretär | 2 Crantock Close Essington WV11 2ED Wolverhampton | British | 62099080001 | ||||||
| STONES, Stephen Anthony | Sekretär | Burley View Ullingswick HR1 3PL Hereford Herefordshire | British | 48006190001 | ||||||
| WILLIAMSON, Christopher John | Sekretär | Kingswood Vauxhall Lane NP6 5PZ Chepstow Gwent | British | 29100650001 | ||||||
| BOMOTO, Toru | Geschäftsführer | 1 Alderwood Place Princes Way B91 3HX Solihull West Midlands | Japanese | 68102230003 | ||||||
| CRESSALL, Peter Alan Gordon | Geschäftsführer | Aston Hall SY7 9EB Aston Dunslow Shropshire | British | 26420970001 | ||||||
| FURUKAWA, Akio | Geschäftsführer | Stoke Cottage Cherry Orchard Lane Llanwenarth NP7 7EP Abergavenny | Japan | Japanese | 104414460001 | |||||
| FURUKAWA, Hiroshi | Geschäftsführer | 43 Ravenswood Drive South B91 3LP Solihull West Midlands | Japanese | 52553100001 | ||||||
| GROVES, Paul Anthony | Geschäftsführer | Merry Meet Glasllwch Lane NP20 3PR Newport | Wales | British | 126738760001 | |||||
| HALLOWS, Jack | Geschäftsführer | 10 White House Way B91 1SE Solihull West Midlands | British | 13659400001 | ||||||
| HAMADA, Osamu | Geschäftsführer | 8 Cotheridge Close B90 4LS Solihull West Midlands | Japanese | 81622820002 | ||||||
| HEATHER, Marcus | Geschäftsführer | Alderminster Road B91 3GL Solihull 42 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 131597640001 | |||||
| HIROOKA, Masaaki | Geschäftsführer | Unit 22 Rassau Industrial Estate NP23 5SD Ebbw Vale Gwent | United Kingdom | Japanese | 147953400001 | |||||
| KANEKO, Hiromichi | Geschäftsführer | 17 Sarno Square NP7 5JT Abergavenny Monmouthshire | Japanese | 99767560002 | ||||||
| KING, Andrew Mark | Geschäftsführer | 23 Yew Croft Avenue Harborne B17 9TR Birmingham West Midlands | England | British | 96568110001 | |||||
| KOJIRI, Shoken | Geschäftsführer | 20 Malvern Park Avenue B91 3EA Solihull West Midlands England | Japanese | 68657510001 | ||||||
| LITTLEJOHNS, Michael Ian | Geschäftsführer | Roseland Penn Lane Tanworth In Arden B94 5HH Solihull West Midlands | British | 77904210001 | ||||||
| LONG-LEATHER, Christopher | Geschäftsführer | 88 High Street Hillmorton CV21 4EE Rugby Warwickshire | British | 13750060001 | ||||||
| MURATA, Kazuo | Geschäftsführer | 9-10 Amaiwate-Cho FOREIGN Takatsuki Osaka Japan | Japanese | 55403750001 | ||||||
| NAKAMURA, Massaaki | Geschäftsführer | 34 Darren View NP8 1DS Crickhowell Powys | British | 45353020001 | ||||||
| OKAMOTO, Kenichi | Geschäftsführer | Greenlands Church Close NP8 1NY Llangynidr Powys | Japanese | 52552980001 | ||||||
| OTSUBO, Naruo | Geschäftsführer | 5-53-4 Matsubara Setagaya-Ku 156 Japan | Japanese | 41324010001 | ||||||
| PLANT, John Charles | Geschäftsführer | The Homestead Peachfield Road WR14 3LE Malvern Worcestershire | British | 62694340001 | ||||||
| SAHASHI, Hiroshi | Geschäftsführer | Unit 22 Rassau Industrial Estate NP3 5SD Ebbw Vale Gwent | Japanese | 13659430001 | ||||||
| SAKAI, Yasueazu | Geschäftsführer | No D 1102 Kamakura Rojiman 1241-4 Okamoto Kamaura-6n1 Japan | Japanese | 26420990002 | ||||||
| SATO, Takashi | Geschäftsführer | 15 Beaufort Avenue Llangattock NP8 1PN Crickhowell Powys | Japanese | 69361890001 | ||||||
| STONES, Stephen Anthony | Geschäftsführer | Burley View Ullingswick HR1 3PL Hereford Herefordshire | United Kingdom | British | 48006190001 |
Hat YUASA AUTOMOTIVE BATTERIES (EUROPE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 15. Juni 2006 Geliefert am 23. Juni 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Feb. 2003 Geliefert am 28. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Formans road/cole valley industrial site tysley, birmingham, west midlands t/n's WM444713 & WM638287. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 08. Juli 1999 Geliefert am 19. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or arising in connection with the facility agreement dated 15 november 1990 | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 5 merrington close solihull t/n WM349823 and all fixtures and fittings fixed plant and machinery thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 08. Juli 1999 Geliefert am 09. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or arising in connection with the facility agreement (as defined) and the supplemental debenture | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/a 5 merrington close solihull t/no: WM349823 together with all fixtures and fitting (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery owned by the company from time to time thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Apr. 1999 Geliefert am 10. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) under any of the finance documents | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage f/h land and premises lying to the southwest of weston lane tyseley and land and premises lying to the north of formans road sparkhill t/n-WM444713. F/h land and premises lying to the north side of formans road sparkhill t/n-WM638287. F/h land and premises k/a 5 merrington close hillfield solihull t/n-WM349823. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement and legal charge | Erstellt am 31. Dez. 1998 Geliefert am 21. Jan. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £600,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Tyseley industrial site,formans rd,sparkhill,birmingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Jan. 1997 Geliefert am 04. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or arising in connection with the facility agreement dated 15 november 1990 as amended 1 august 1991 and further amended by a deed dated 6 july 1995 | |
Kurze Angaben Land to the north of formans road sparkhill t/n WM638287. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Dez. 1996 Geliefert am 09. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or arising in connection with the facility letter agreement dated 30TH december 1996 whereby the bank has made availible to the company a revolving cash advances facility of up to £2,000,000 and all other monies due under the debenture | |
Kurze Angaben Lucas yuasa battery works and situate to the southwest of weston lane tysley and land to the north of formans road sparkhill birmingham t/no.WM444713 but excluding that part of such land comprising 1.63 acres transferred to birmingham city council on 18TH may 1990. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Nov. 1990 Geliefert am 16. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of the facilities agreement of even date and the charge | |
Kurze Angaben (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0