CURNOW CARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCURNOW CARE LIMITED
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 02201080
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CURNOW CARE LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich CURNOW CARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 Witan Way
    OX28 6FH Witney
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CURNOW CARE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CURNOW CARE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CURNOW CARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Registrierungsbescheinigung eines Sozialvereins

    CERTIPS

    Verschiedenes

    Forms b & z to convert to i&ps
    2 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to i&ps 20/06/2011
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 ohne Mitgliederliste

    4 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 10-11 Edward Street Truro Cornwall TR1 3AJ* am 19. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Julie Lynda Layton als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Derek Healy als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter Willson als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Judith Uden als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Frances Eliot als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Judith Coode als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Sandry als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Trefusis als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Maureen Tetley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mark Adams als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    14 SeitenAA

    legacy

    10 SeitenMG01

    legacy

    10 SeitenMG01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    8 SeitenMG01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von CURNOW CARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ADAMS, Mark James
    Witan Way
    OX28 6FH Witney
    2
    Oxfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Witan Way
    OX28 6FH Witney
    2
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish162187150001
    HEALY, Derek Christopher
    Witan Way
    OX28 6FH Witney
    2
    Oxon
    England
    Geschäftsführer
    Witan Way
    OX28 6FH Witney
    2
    Oxon
    England
    EnglandBritish114482230001
    LAYTON, Julie Lynda
    Witan Way
    OX28 6FH Witney
    2
    Oxon
    England
    Geschäftsführer
    Witan Way
    OX28 6FH Witney
    2
    Oxon
    England
    EnglandBritish114916340001
    ANNEAR, David Roy
    149 Henver Road
    TR7 3EJ Newquay
    Cornwall
    Sekretär
    149 Henver Road
    TR7 3EJ Newquay
    Cornwall
    British29707420001
    SANDRY, Anthony Leonard Kempthorne
    46 Crabtree Lane
    PL31 1BL Bodmin
    Cornwall
    Sekretär
    46 Crabtree Lane
    PL31 1BL Bodmin
    Cornwall
    British176530650001
    WILLSON, Peter Edward
    Bowood The Ropewalk
    Penpol Point
    TR3 6NS Truro
    Cornwall
    Sekretär
    Bowood The Ropewalk
    Penpol Point
    TR3 6NS Truro
    Cornwall
    British15323030003
    WILLSON, Peter Edward
    Tresithick House
    Carnon Downs
    TR3 6JW Truro
    Cornwall
    Sekretär
    Tresithick House
    Carnon Downs
    TR3 6JW Truro
    Cornwall
    British15323030001
    BAXTER, Ian Stuart
    Weston House Haye Road
    PL17 7JJ Callington
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Weston House Haye Road
    PL17 7JJ Callington
    Cornwall
    British42316550001
    BRYCE, Alexander Wither
    Wild Air Hain Walk
    TR26 2AF St Ives
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Wild Air Hain Walk
    TR26 2AF St Ives
    Cornwall
    British14847200001
    BURDEN, William James Hamley
    16 Beacon Road
    PL31 1AS Bodmin
    Cornwall
    Geschäftsführer
    16 Beacon Road
    PL31 1AS Bodmin
    Cornwall
    British15323070001
    COODE, Judith Anne
    Trebyan House
    Lanhydrock
    PL30 5AE Bodmin
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Trebyan House
    Lanhydrock
    PL30 5AE Bodmin
    Cornwall
    Great BritainBritish96410950001
    ELIOT, Frances
    Brightor House
    Tideford
    PL12 5HY Saltash
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Brightor House
    Tideford
    PL12 5HY Saltash
    Cornwall
    EnglandBritish126376810001
    EMUSS, Robert James, Ptr
    Treemuss
    Higher Tremarcoombe
    PL14 5HP Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Treemuss
    Higher Tremarcoombe
    PL14 5HP Liskeard
    Cornwall
    British98496420001
    HARDING, Bernard
    Trebrownbridge Farm
    Horning Tops
    PL14 3PS Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Trebrownbridge Farm
    Horning Tops
    PL14 3PS Liskeard
    Cornwall
    British20077960002
    LADBROKE, Suzie Margaret
    The Old House
    Rilla Mill
    PL17 7NT Callington
    Cornwall
    Geschäftsführer
    The Old House
    Rilla Mill
    PL17 7NT Callington
    Cornwall
    British71794710002
    MCNULTY, Bryan Denis
    Highgate 5 Wadham Road
    PL14 3BD Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Highgate 5 Wadham Road
    PL14 3BD Liskeard
    Cornwall
    British72107740001
    NEVILLE, Paul, Councillor
    24 Tronolieth Estate
    North Country
    TR16 4AR Redruth
    Cornwall
    Geschäftsführer
    24 Tronolieth Estate
    North Country
    TR16 4AR Redruth
    Cornwall
    British15323060001
    SANDRY, Anthony Leonard Kempthorne
    46 Crabtree Lane
    PL31 1BL Bodmin
    Cornwall
    Geschäftsführer
    46 Crabtree Lane
    PL31 1BL Bodmin
    Cornwall
    United KingdomBritish176530650001
    TETLEY, Maureen
    Garlenick Manor
    Grampound
    TR2 4RE Truro
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Garlenick Manor
    Grampound
    TR2 4RE Truro
    Cornwall
    United KingdomBritish15807020001
    TREFUSIS, Nicholas John
    Trefusis
    Flushing
    TR11 5TD Falmouth
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Trefusis
    Flushing
    TR11 5TD Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish101663090001
    UDEN, Judy Mary
    Sunnyvale
    Hewas Water
    PL26 7JF St Austell
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Sunnyvale
    Hewas Water
    PL26 7JF St Austell
    Cornwall
    EnglandBritish177276940001
    WILLSON, Peter Edward
    Bowood The Ropewalk
    Penpol Point
    TR3 6NS Truro
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Bowood The Ropewalk
    Penpol Point
    TR3 6NS Truro
    Cornwall
    British15323030003

    Hat CURNOW CARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 11 carwinion terrace liskeard t/no CL49294 and CL32894 and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 102 dracaena avenue falmouth t/no CL90219 and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 14 trebarwith crescent newquay t/no CL24037 and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H hillyar bodmin hill lostwithiel t/no CL35292 and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 35 roskear tuckingmill camborne and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 72 ranelagh road st austell t/no CL38333 and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 2 penare road penzance t/no CL78354 and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 17 roskear camborne t/no CL78166 and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it, any policies of insurance the benefit of all contracts, guarantees and warranties and all authorisations see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cornwall & Isles of Scilly Primary Care Trust
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Tolvean house west end redruth cornwall. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bolitho house laregan hill penzance cornwall. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Trelill court 11 market street bodmin cornwall. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Aug. 2001
    Geliefert am 29. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the property lomond hall hotel, st ives road, carbis bay, st ives, cornwall. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Jan. 2001
    Geliefert am 08. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the alexandra hotel alexandra road st austell cornwall t/no CL75439. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Aug. 1998
    Geliefert am 12. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H lower cardrew house north street redruth cornwall t/n-CL107203.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juni 1998
    Geliefert am 05. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as oakleigh house menheniot liskeard cornwall; t/no cl 25726. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juni 1998
    Geliefert am 05. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as selwood house hotel 60 alexandra road st austell cornwall; t/no cl 26240. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Mai 1993
    Geliefert am 19. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 102 dracaena avenue falmouth cornwall and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Geliefert am 22. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    72 ranelagh road st austell cornwall. T/n-CL38333 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Feb. 1992
    Geliefert am 04. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H- property k/a porthminster 2 penare road penzance cornwall and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 1992
    Geliefert am 13. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 17 roskear camborne cornwall and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Jan. 1992
    Geliefert am 22. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Carwinion house carwinion terrace station road liskeard cornwall title nos. CL49294 and CL32894 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Jan. 1992
    Geliefert am 16. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hillyar bodmin hill lostwithiel restormel cornwall t/n-CL39292 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Dez. 1991
    Geliefert am 19. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Feb. 1991
    Geliefert am 05. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 trebarwith crescent, newquary, cornwall, and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 08. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Aug. 1988
    Geliefert am 22. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-10 stanford close, penzance, cornwall and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0