DYNIX LTD
Überblick
| Unternehmensname | DYNIX LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02207720 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DYNIX LTD?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich DYNIX LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o SIRSIDYNIX 54 Clarendon Road WD17 1DU Watford |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DYNIX LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EPIXTECH LTD | 02. Feb. 2000 | 02. Feb. 2000 |
| AMERITECH LIBRARY SERVICES LTD. | 21. März 1997 | 21. März 1997 |
| DYNIX LIBRARY SYSTEMS (UK) LIMITED | 25. März 1988 | 25. März 1988 |
| BROADURGENT LIMITED | 23. Dez. 1987 | 23. Dez. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DYNIX LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DYNIX LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 25. Okt. 2013
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Okt. 2013
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von William Charles Davison Jr als Direktor am 24. Feb. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Mark Rautenstrauch als Geschäftsführer am 24. Feb. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Chequers St Marys Way Chesham Buckinghamshire HP5 1LL am 24. Feb. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DYNIX LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDINER, John Houston, Mr. | Sekretär | c/o Sirsidynix Clarendon Road WD17 1DU Watford 54 United Kingdom | 146655780001 | |||||||
| DAVISON JR, William Charles | Geschäftsführer | c/o Sirsidynix Clarendon Road WD17 1DU Watford 54 United Kingdom | United States | American | 167741700001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Sekretär | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| BEZAULT, Sandra Gwat Tjhing | Sekretär | Poortsebos 5 3951 Bk Maarn The Netherlands | British | 40394360001 | ||||||
| BRECK, David M, Mr. | Sekretär | 368 North 960 East 84062 Pleasant Grove Not Applicable Utah Usa | Other | 139205340001 | ||||||
| COLLETT, Brian | Sekretär | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| ELDER, Andrew | Sekretär | Quay South Salamander Quay Park Lane Harefield UB9 6NY Uxbridge Middlesex | British | 22708030001 | ||||||
| FARRINGTON, David John | Sekretär | 23 Napoleon Road TW1 3EW Twickenham Middlesex | British | 13372050001 | ||||||
| GETHIN, Peter Eric | Sekretär | 213 Darkes Lane EN6 1BX Potters Bar Hertfordshire | British | 8538600001 | ||||||
| IVEY, Jeffrey | Sekretär | 32 Larchmoor Park Gerrards Cross Road SL2 4EY Stoke Poges Buckinghamshire | Australian | 73092470001 | ||||||
| MEHTA, Mrugesh | Sekretär | 5 Mentmore View HP23 4HR Tring Hertfordshire | British | 60311150002 | ||||||
| RYAN, Sally Ann | Sekretär | 95 Clapham Common West Side SW4 9AZ London | British | 56564050001 | ||||||
| BLOUNT, Jack | Geschäftsführer | 2072 Mahre Drive Park City Utah 84608 Usa | Us Citizen | 85636660001 | ||||||
| BRADY, Arthur | Geschäftsführer | 2 Fallowfield Close Harefield UB9 6QE Uxbridge Middlesex | British | 40183940001 | ||||||
| CARDEN, Mark Thomas Jan | Geschäftsführer | Barnane House Tickmorend Horsley GL6 0PE Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 44874740001 | |||||
| DIMANT, Nicholas Leigh | Geschäftsführer | 19 Finchley Way N3 1AG London | England | British | 8538590002 | |||||
| DOWNIE, William | Geschäftsführer | The Stable, Perton, Stoke Edith HR1 4HP Hereford Herefordshire | British | 75847350001 | ||||||
| ELDER, Andrew | Geschäftsführer | Tigharry 8 Turnstone Close Winnersh RG11 5LQ Wokingham Berkshire | British | 59273640001 | ||||||
| EZEKIEL, Christopher | Geschäftsführer | 3 Lingard House Marshfield Street E14 3HH London | United Kingdom | British | 51046530003 | |||||
| FORTUNE, Michael | Geschäftsführer | 1 Connaught Gardens HP4 1SF Berkhamsted Hertfordshire | British | 46859460001 | ||||||
| GETHIN, Peter Eric | Geschäftsführer | 213 Darkes Lane EN6 1BX Potters Bar Hertfordshire | British | 8538600001 | ||||||
| MACDONALD, Thomas William | Geschäftsführer | 347 East 1090 North 84057 Orem Utah Usa | American | 40984850001 | ||||||
| MCCAUSLAND, Dean Alexander | Geschäftsführer | 36 Carver Road Wellesly Massachusetts 02481 Usa | American | 112104500001 | ||||||
| PATTERSON, Iain Armorer | Geschäftsführer | Otterburn 2 Cumberland Close HP21 7HH Aylesbury Buckinghamshire | British | 70074960001 | ||||||
| PORTER, Lana, President | Geschäftsführer | 1127 Courtland Place 60504 Avora Illinois Usa | American | 51512340001 | ||||||
| QUARTON, Thomas | Geschäftsführer | 4149 East Prospector Drive 84121 Salt Lake City Ut Usa | American | 44283040001 | ||||||
| RANCROFT, William Marler | Geschäftsführer | Dynix Management Inc 4345 North Windsor Provo Utah 84606 U S A | Canadian | 22708040001 | ||||||
| RAUTENSTRAUCH, Gary Mark, Mr. | Geschäftsführer | c/o Sirsidynix Clarendon Road WD17 1DU Watford 54 United Kingdom | Usa | United States | 82766870001 | |||||
| RYAN, Sally Ann | Geschäftsführer | 95 Clapham Common West Side SW4 9AZ London | British | 56564050001 | ||||||
| SHETH, Brian | Geschäftsführer | 59 Lupine Ave Apartment 501 FOREIGN California San Franciso 94118 Usa | American | 120515160001 | ||||||
| SLOAN, Roger | Geschäftsführer | 2262 East High Ridge Lane Sandy Utah 84092 FOREIGN Usa | American | 40183630001 | ||||||
| SMITH, Larry D | Geschäftsführer | 117 Maximillion Drive Madison Alabama 35758 Usa | American | 107125410001 | ||||||
| SMITH, Robert | Geschäftsführer | 25 Vista Del Sol Mill Valley California 94941 Usa | American | 134493060001 | ||||||
| SOMMERS, Patrick Charles | Geschäftsführer | 18 Ledge View Drive Huntsville Alabama 35802 Usa | American | 107125530001 | ||||||
| SOWUL, Christian | Geschäftsführer | 150 California St, 19th Floor FOREIGN San Francisco Ca 94111 Usa | United States | 120514960001 |
Hat DYNIX LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit | Erstellt am 02. Jan. 2002 Geliefert am 07. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £13,000 credited to account designation 83623396 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 13. Sept. 1993 Geliefert am 17. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The due performance and observance by the company of the covenants agreements and conditions to salamander investments limited | |
Kurze Angaben £80,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of cash deposit | Erstellt am 09. März 1992 Geliefert am 13. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sum of £15,000.00 credited to account number /designated 12184575 with the bank together with all sums in the future credited to that account and including all interest accrued or accruing in the future on the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent security deposit deed | Erstellt am 09. Sept. 1991 Geliefert am 12. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £7,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargees supplemental to a lease dated 9.9.91 and under the terms of this deed. | |
Kurze Angaben The sum of £7,000 together with the further sum or sums covenanted to be paid under the terms of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent security deposit deed | Erstellt am 09. Sept. 1991 Geliefert am 12. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £14,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 9.9.91 and under the terms of the deed. | |
Kurze Angaben The sum of £14,000 together with the further sum or sums covenanted to be paid under the terms of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement | Erstellt am 14. Aug. 1991 Geliefert am 20. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. The deposit means the debt owing to the company by the bank or any party. (Please see m 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 25. Mai 1990 Geliefert am 30. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any moneys now or hereafter standing to the credit of a designated account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 09. März 1990 Geliefert am 20. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0