SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02211403 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
- Andere Forschung und experimentelle Entwicklung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (72190) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Farnborough Business Park 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Hampshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INC RESEARCH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED | 31. Jan. 2012 | 31. Jan. 2012 |
| KENDLE CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED | 17. Okt. 2006 | 17. Okt. 2006 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES CLINICAL SERVICES INTERNATIONAL LTD | 29. Sept. 2005 | 29. Sept. 2005 |
| INVERESK RESEARCH LIMITED | 02. Juli 2001 | 02. Juli 2001 |
| CLINTRIALS RESEARCH LIMITED | 25. März 1994 | 25. März 1994 |
| CLINTRIALS LIMITED | 16. März 1992 | 16. März 1992 |
| CLINICAL RESEARCH INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED | 25. März 1988 | 25. März 1988 |
| ALIGNBECK LIMITED | 18. Jan. 1988 | 18. Jan. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Apr. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Syneos Health, Inc as a person with significant control on 07. Mai 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nyla Natalie Donna Maria Singh als Sekretär am 05. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Kirstin Maura Mackenzie Connell als Direktor am 05. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Nyla Natalie Donna Maria Singh als Direktor am 05. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Farnborough Business Park Pinehurst Road Farnborough GU14 7BF England zum Farnborough Business Park 1 Pinehurst Road Farnborough Hampshire GU14 7BF am 04. Juni 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Riverview the Meadows Business Park Station Approach Camberley Surrey GU17 9AB zum Farnborough Business Park Pinehurst Road Farnborough GU14 7BF am 30. Mai 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Inc Research Holdings, Inc as a person with significant control on 04. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alistair John Macdonald am 01. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNELL, Kirstin Maura Mackenzie | Geschäftsführer | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | England | British | 121742610001 | |||||
| MACDONALD, Alistair John | Geschäftsführer | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | England | British | 177452780002 | |||||
| SINGH, Nyla Natalie Donna Maria | Geschäftsführer | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152049680001 | |||||
| COWAN, Desmond Joseph Paul Edward | Sekretär | 52 Leith Walk EH6 5HW Edinburgh Midlothian | British | 83009100001 | ||||||
| FRENCH, Charlotte Ann | Sekretär | Hudson Cottage Howsham YO6 7PH York North Yorkshire | British | 35214860001 | ||||||
| HARRISON, Leigh Gordon | Sekretär | Peak House The Ridge, Cold Ash RG18 9HZ Thatcham Berkshire | British | 71250990001 | ||||||
| JOHST, David P | Sekretär | 7 Meadow View Lane Andover Massachusetts 01810 U S A | American | 101051040001 | ||||||
| JONES, Angela Margaret | Sekretär | The Beren Hatchgate Farm Cockpole Green Wargrave RG10 8NE Reading Berkshire | British | 35510100002 | ||||||
| LESLIE, Stewart Gordon | Sekretär | 11 Walker Street EH3 7NE Edinburgh Midlothian | British | 66170500001 | ||||||
| MOORE, Douglas Frank | Sekretär | Welham Hall Welham YO17 9QF Malton North Yorkshire | British | 7282400001 | ||||||
| SAYERS, James Christopher | Sekretär | 5 Whitchurch Close SL6 7TZ Maidenhead Berkshire | British | 36434820001 | ||||||
| SHAW, William Lawson, Dr | Sekretär | 2 Autumn Walk SL6 4ND Maidenhead Berkshire | British | 48559390005 | ||||||
| SINGH, Nyla Natalie Donna Maria | Sekretär | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | British | 177453250001 | ||||||
| SINGH, Nyla Natalie | Sekretär | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | British | 53140790003 | ||||||
| WALL, Karen Malinda | Sekretär | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | British | 162650850001 | ||||||
| WILLIAMS, Nigel James, Dr | Sekretär | Slievehamon Oakleigh Road Hatch End HA5 4HB Pinner Middlesex | British | 58705320001 | ||||||
| YENDELL, Timothy Patrick | Sekretär | 64 Donnington Gardens RG1 5LZ Reading Berkshire | British | 64274200001 | ||||||
| ACKERMAN, Thomas Francis | Geschäftsführer | 11 Athertone Circle Lynnfield Massachusetts 01940 U S A | American | United States | 101051180001 | |||||
| BERGEN, Christopher | Geschäftsführer | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 62057130002 | |||||
| BOYCE, Alan James | Geschäftsführer | Cambrian Close GU15 3LD Camberley 35 Surrey | United Kingdom | British | 78141200001 | |||||
| BRENKERT III, Karl | Geschäftsführer | 981 Paxton Lake Drive Loveland Ohio 45140 Usa | American | 86872650002 | ||||||
| CHEESMAN, Keith A | Geschäftsführer | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 138222390001 | |||||
| COWAN, Desmond Joseph Paul Edward | Geschäftsführer | 52 Leith Walk EH6 5HW Edinburgh Midlothian | British | 83009100001 | ||||||
| DE WITT, Jan, Dr | Geschäftsführer | Charlotte De Bourbonlaan 3708 CD Zeist Holland | Dutch | 58705310001 | ||||||
| FOSTER, James Clifford | Geschäftsführer | 16 Hancock Road Weston Massachusetts 02493 U S A | Usa | 101050900001 | ||||||
| GANLEY, John Leo | Geschäftsführer | Wedgefield Plantation Georgetown South Carolina 29440 FOREIGN Usa | Us Citizen | 7518960001 | ||||||
| GILL, David Neil | Geschäftsführer | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 167395680001 | |||||
| GOODMAN, Nigel | Geschäftsführer | 52 Westover Road SW18 2RH London | British | 60771380001 | ||||||
| HARRISON, Leigh Gordon | Geschäftsführer | Peak House The Ridge, Cold Ash RG18 9HZ Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | 71250990001 | |||||
| JOHST, David P | Geschäftsführer | 7 Meadow View Lane Andover Massachusetts 01810 U S A | American | American | 101051040001 | |||||
| JONES, Angela Margaret | Geschäftsführer | The Beren Hatchgate Farm Cockpole Green Wargrave RG10 8NE Reading Berkshire | British | 35510100002 | ||||||
| KENDLE, Candace | Geschäftsführer | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 62038310002 | |||||
| KERKHOF, Glenn Cornelis | Geschäftsführer | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | Netherlands | 99733300002 | ||||||
| KERKHOF, Glenn Cornelis | Geschäftsführer | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | Netherlands | 99733300002 | ||||||
| LESLIE, Stewart Gordon | Geschäftsführer | 11 Walker Street EH3 7NE Edinburgh Midlothian | British | 66170500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syneos Health, Inc | 06. Apr. 2016 | Silverside Road Tatnall Building #104 Wilmington 3411 De 19810 United States | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 18. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to one or more lenders or their respective affiliates on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures & equipment see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2006 Geliefert am 05. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and the other loan parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A collateral agreement | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 16. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers or any of their subsidiaries to the lenders or the agents under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in the following property now owned or at any time acquired by the grantor after the date of the collateral agreement, all accounts all cash and currency all chattel paper all commercial tort claims all deposit accounts all documents all equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 16. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juni 2002 Geliefert am 10. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0