GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED

GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02212509
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    • Herstellung anderer Behälter aus Papier und Pappe (17219) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STANDTYPE LIMITED21. Jan. 198821. Jan. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Aug. 2020

    21 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    23 SeitenAM10

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    24 SeitenAM22

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    21 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    23 SeitenAM10

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA/AM02SOC

    16 SeitenAM02

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    5 SeitenAM07

    Vorschlag des Verwalters

    49 SeitenAM03

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Pullman House Treefield Industrial Estate Gelderd Road Leeds LS27 7JU zum Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ am 16. Feb. 2018

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2017

    20 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    1 SeitenMR04

    Notification of John Eric Rose as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC01

    Notification of Barry Frank Williamson as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC01

    Notification of Ian Roger Mitchelson as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC01

    Notification of Warren Bruce Shermer as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2016

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 26. Juli 2016

    • Kapital: GBP 120,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 022125090021 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 20 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHERMER, Warren Bruce
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    Sekretär
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    BritishManging Director90009410002
    MITCHELSON, Ian Roger
    Pemberley Court
    Ripponden
    HX6 4JF Sowerby Bridge
    4
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pemberley Court
    Ripponden
    HX6 4JF Sowerby Bridge
    4
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSales Director105776290002
    ROSE, John Eric
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    Geschäftsführer
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    EnglandBritishDirector152833810001
    SHERMER, Warren Bruce
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    Geschäftsführer
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    EnglandBritishManaging Director90009410002
    WILLIAMSON, Barry Frank
    Apartment 5 Buckley House
    Lancaster Road
    M20 2QU Manchester
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    Apartment 5 Buckley House
    Lancaster Road
    M20 2QU Manchester
    Greater Manchester
    EnglandBritishDirector105787550002
    BASNETT, Robert William
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Director105776210001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Sekretär
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrishCompany Director54812330001
    GILL, Jane
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    Sekretär
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    British12519680001
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    Sekretär
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    65475060002
    BASNETT, Robert William
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director105776210001
    CARTLIDGE, Donald William
    14 Rievaulx Close
    HG5 8NG Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    14 Rievaulx Close
    HG5 8NG Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishDirector54001690002
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Geschäftsführer
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishCompany Director54812330001
    CROISDALE, John Russell
    27 Lightridge Road
    Fixby
    HD2 2HE Huddersfield
    Geschäftsführer
    27 Lightridge Road
    Fixby
    HD2 2HE Huddersfield
    BritishDirector48813710002
    CROISDALE, John Russell
    47 Tofts Grove
    Rastrick
    HD6 3XG Brighouse
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    47 Tofts Grove
    Rastrick
    HD6 3XG Brighouse
    West Yorkshire
    BritishDirector48813710001
    GILL, Anthony Stephen
    Angel House Church Street
    Kirk Hammerton
    YO26 8DD York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Angel House Church Street
    Kirk Hammerton
    YO26 8DD York
    North Yorkshire
    EnglandEnglishCompany Director57831700001
    GILL, Jane
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    BritishCompany Director12519680001
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Geschäftsführer
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishCompany Director78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant96288470001
    MULLER, Philip Harvey
    71 Oakdale
    HG1 2LT Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    71 Oakdale
    HG1 2LT Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector75652830001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    PENNIE, Richard Kevin
    20 Vinery Close
    Clayton West
    HD8 9XH Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Vinery Close
    Clayton West
    HD8 9XH Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishKey Accounts Director105963010001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Barry Frank Williamson
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06. Apr. 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Warren Bruce Shermer
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06. Apr. 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Ian Roger Mitchelson
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06. Apr. 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr John Eric Rose
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06. Apr. 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juni 2016
    Geliefert am 10. Juni 2016
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Juni 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juni 2016
    Geliefert am 10. Juni 2016
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Juni 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Aug. 2013
    Geliefert am 21. Aug. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aldermore Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 23. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 2011
    Geliefert am 23. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chattels being 5 colour offset printing press with: sheet feeder, max sheet size 820MM x 1130MM 5 printing heads coating head ir dryer shhet stacket s/n 157 (for details of further chattels charged please refer to form MG01) including all engines, appliances, parts, spare parts, components, instruments, appurtenances, accessories and other equipment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aldermore Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Dez. 2011
    Geliefert am 22. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 17. Aug. 2006
    Geliefert am 22. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Winkler & dunnebier - refurbished high speed envelope machine serial no. 10.674.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 14. Juni 2006
    Geliefert am 22. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Winkler & dunnebier - envelope makeing machine - s/no: 15608.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 2005
    Geliefert am 05. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Halm two colour envelope printing press s/no SJP7142.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 21. Sept. 2005
    Geliefert am 29. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Winkler & dunnebier-high speed envelope machine-s/n 11.146.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 24. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Halm web offset printer/feeder/cylinders/water system/delivery table/counter/dryer/cooling unit s/no EM57120.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 25. Mai 2005
    Geliefert am 01. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the baring english growth fund (north) LP, baring english growth fund (south) LP or the chargee (together the beneficiaries) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit d, treefield industrial estate, gelderd road, gildersome, leeds, LS27 7JU;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bpep Management (UK) Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 01. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Mai 2005
    Geliefert am 01. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 25. Mai 2005
    Geliefert am 01. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 01. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2005
    Geliefert am 28. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Model lithrome l-44 s/n 157 description 44" five colour press with coaster, 68886.315 million imps including the chattels shown on the additional asset list to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Mai 2005
    Geliefert am 28. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000
    Erstellt am 30. Aug. 2000
    Geliefert am 08. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Apr. 1996
    Geliefert am 09. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC in Its Capacity as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 09. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 16. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 06. Juni 1995
    Geliefert am 13. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 05. Apr. 1995
    Geliefert am 13. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment the debts and the benefit of all securities and guarantees for the same and all interest (if any) due or which becomes due in respect thereof by way of specific equitable charge all the equitably charged property (other than the f/h's at maserati house gelderd road leeds and ingram road holbeck leeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Nov. 1994
    Geliefert am 22. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the north west side of ingram road holbeck leeds west yorkshire t/n wyk 556729 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1992
    Geliefert am 10. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north west side of gelderd road leeds west yorkshire t/n ywe 13880 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Nov. 1989
    Geliefert am 13. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 30. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Mai 1988
    Geliefert am 24. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 121E whitehall estate leeds. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Feb. 2018Beginn der Verwaltung
    16. Aug. 2019Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas Edward Reed
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    16. Aug. 2019Beginn der Liquidation
    11. Apr. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas Edward Reed
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Nicholas Edward Reed
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0