DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED

DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02215690
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED?

    • Fitnessstudios (93130) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DRAGONS HEALTH CLUBS PLC15. Apr. 199715. Apr. 1997
    DRAGONS HEALTH & LEISURE CLUBS LIMITED05. Juli 198805. Juli 1988
    PARKVIEW LEISURE LIMITED01. Feb. 198801. Feb. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY United Kingdom zum 15 Canada Square London E14 5GL am 28. Feb. 2018

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 06. Feb. 2018

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Jacques De Bruin als Geschäftsführer am 30. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter William Denby Roberts als Geschäftsführer am 30. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Notification of L a Fitness Limited as a person with significant control on 01. Aug. 2017

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Crown Sports Limited as a person with significant control on 01. Aug. 2017

    1 SeitenPSC07

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 12. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 3,114,864.75
    SH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2015 bis 31. Dez. 2015

    1 SeitenAA01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall Doncaster South Yorkshire DN3 1QR zum C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY am 06. Nov. 2015

    1 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 42 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 44 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 46 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 022156900047 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 45 vollständig

    4 SeitenMR04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter William Denby Roberts am 08. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2014

    8 SeitenAA

    Ernennung von Mr Adam John Gordon Bellamy als Sekretär am 28. Mai 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ross Steven Chester als Geschäftsführer am 28. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    198433750001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish172693720002
    COBBOLD, Humphrey Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish100141010001
    DAVIES, Raymond Alan
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    Sekretär
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    British4878250001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    British124301460001
    JARVIS, Diane
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    Sekretär
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    British79818790001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Sekretär
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    British114849640001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Sekretär
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    British114849640001
    TAYLOR, Graham
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    Sekretär
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    British82374420004
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    British71126560002
    ACLAND, Simon Hugh Verdon
    Charlwood Lodge
    42 Charlwood Road Putney
    SW15 1PW London
    Geschäftsführer
    Charlwood Lodge
    42 Charlwood Road Putney
    SW15 1PW London
    United KingdomBritish15257290003
    BROSTER, Stuart Paul
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    United KingdomBritish114847350001
    BRUIN, Jacques De
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomSouth African198346420001
    BRUNNING, Charles Bruce
    Netton Farmhouse
    Noss Mayo
    PL8 1HB Plymouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Netton Farmhouse
    Noss Mayo
    PL8 1HB Plymouth
    Devon
    British10628800002
    CHESTER, Ross Steven
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    British137527310001
    DAVIES, Raymond Alan
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    British4878250001
    DONALD, Christopher James
    Coombe House
    Coombe Lane
    TN5 6NU Wadhurst London
    Geschäftsführer
    Coombe House
    Coombe Lane
    TN5 6NU Wadhurst London
    United KingdomBritish178430070001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124301460001
    GREALEY, Martyn
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    United KingdomBritish125401590001
    JARVIS, Diane
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    Geschäftsführer
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    EnglandBritish79818790001
    LONG, Martin
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish125885350001
    MCCOLL, Arthur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    AustraliaBritish139099550001
    PIERCE, Raymond Francis
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish3231870001
    PURSLOW, Christian Mark Cecil
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Geschäftsführer
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    United KingdomBritish83244210001
    ROBERTS, Peter William Denby
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    EnglandBritish106538510001
    ROBERTS, Peter William Denby
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    Geschäftsführer
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    EnglandBritish106538510001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritish114849640001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritish114849640001
    TARRY, Richard John
    20 Orchid Drive
    GU24 9SB Bisley
    Surrey
    Geschäftsführer
    20 Orchid Drive
    GU24 9SB Bisley
    Surrey
    British62912620001
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    British71126560002
    TRAVERS CLARKE, John
    6 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    Geschäftsführer
    6 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    EnglandBritish2680980001
    TREHARNE, John Robert
    Forsdyke House Rocky Lane
    RH16 4RN Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Forsdyke House Rocky Lane
    RH16 4RN Haywards Heath
    West Sussex
    British53953950001
    TUROK, Frederick Oliver
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    EnglandSouth African41174400002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    01. Aug. 2017
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03224406
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02476401
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. Juni 2014
    Geliefert am 10. Juni 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 21. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A supplemental security and confirmation deed
    Erstellt am 30. Aug. 2011
    Geliefert am 13. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and all monies due or to become due from the chargors to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its relevant assets as more specifically referred to in the relevant security documents upon the terms contained in the relevant security documents. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Amendment deed
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 31. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The remaining assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Various Lenders (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 31. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 21. Juni 2006
    Geliefert am 03. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 81-83 kimbolton road bedford bedfordshire t/nos BD19226 and BD22062, l/h dragons health club chindits lane warley brentwood essex t/no EX590850 and l/h land and buildings on the south east side of liversage road derby t/NODY136843 for details of further properties charged please refer to form 395.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 03. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 23. März 2006
    Geliefert am 03. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the crunch finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its interest in the land referred to opposite its name in schedule 1 meaning, 81-83 kimbolton road, bedford, bedfordshire t/no's BD19226 and BD22062. Dragons health club, chindits lane, warley, brentwood, essex t/no EX590850. Land and buildings on the south east side of liversage road, derby t/no DY136843, for details of further land charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 23. März 2006
    Geliefert am 03. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 26. Apr. 2002
    Geliefert am 09. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies,liabilities and obligations whatsoever due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including (I) the f/hold property known as northwood squash club,chestnut ave,northwood,midd'x; AGL37538; (ii) f/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks road,halstead sevenoaks; K588424 and K685755; (iii) l/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks rd,halstead,sevenoaks; K725693; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Juli 2001
    Geliefert am 04. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at witham park waterside south lincoln. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2000
    Geliefert am 20. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Orpington club sandy lane st pauls cray orpington kent. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 06. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at the manor howarth lane yeadon leeds. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Aug. 1999
    Geliefert am 25. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 46/48 bedford street leamington spa. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Aug. 1999
    Geliefert am 12. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a dragons heath club rowdell road western avenue northolt. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at witham house witham park lincoln (leasehold). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 1999
    Geliefert am 06. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at land to the south of epsom road merrow (known as dragons health club)(freehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Okt. 1998
    Geliefert am 22. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying on the north west side of st heliers avenue hove east sussex t/n ESX125381. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Sept. 1998
    Geliefert am 10. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H dragons health club rowdell road western avenue northolt. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Jan. 1998
    Geliefert am 27. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Brenfield club brentwood essex. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings lying to the south east of imperial way croydon surrey t/n-SGL573088 and part of t/n-SGL70205 which includes all buildings fixtures and fittings now or at any time after the date of the mortgage, and the mortgagor's beneficial interest in the property or the sale proceeds. The benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights accrued as a result of being a member of a management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; any other payments whatever in respect of the property, for example, payments from any insurance policy or any compensation money. And for the purposes of the above, the terms "mortgage" and "mortgagor" shall have the meanings set out in the mortgage deed dated 30 april 1997.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    Kurze Angaben
    F/H property known as land and buildings lying to the south east of liversage road derby t/n-DY136843 which includes all buildings fixtures and fittings now or at any time after the date of the mortgage, and the mortgagor's beneficial interest in the property or the sale proceeds. The benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights accrued as a result of being a member of a management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; any other payments whatever in respect of the property, for example, payments from any insurance policy or any compensation money. And for the purposes of the above, the terms "mortgage" and "mortgagor" shall have the meanings set out in the mortgage deed dated 30 april 1997.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 81-83 kimbolton road bedford t/n-BD19226 which includes all buildings fixtures and fittings now or at any time after the date of the mortgage, and the mortgagor's beneficial interest in the property or the sale proceeds. The benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights accrued as a result of being a member of a management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; any other payments whatever in respect of the property, for example, payments from any insurance policy or any compensation money. And for the purposes of the above, the terms "mortgage" and "mortgagor" shall have the meanings set out in the mortgage deed dated 30 april 1997.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the south east side of kimbolton road bedford t/n-BD22062 which includes all buildings fixtures and fittings now or at any time after the date of the mortgage, and the mortgagor's beneficial interest in the property or the sale proceeds. The benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights accrued as a result of being a member of a management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; any other payments whatever in respect of the property, for example, payments from any insurance policy or any compensation money. And for the purposes of the above, the terms "mortgage" and "mortgagor" shall have the meanings set out in the mortgage deed dated 30 april 1997.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 85 kimbolton road bedford t/n-BD18987 which includes all buildings fixtures and fittings now or at any time after the date of the mortgage, and the mortgagor's beneficial interest in the property or the sale proceeds. The benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights accrued as a result of being a member of a management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; any other payments whatever in respect of the property, for example, payments from any insurance policy or any compensation money. And for the purposes of the above, the terms "mortgage" and "mortgagor" shall have the meanings set out in the mortgage deed dated 30 april 1997.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    Kurze Angaben
    F/H-property k/a hillfield park muswell hill london t/n-NGL390776 which includes all buildings fixtures and fittings now or at any time after the date of the mortgage, and the mortgagor's beneficial interest in the property or the sale proceeds. The benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights accrued as a result of being a member of a management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; any other payments whatever in respect of the property, for example, payments from any insurance policy or any compensation money. And for the purposes of the above, the terms "mortgage" and "mortgagor" shall have the meanings set out in the mortgage deed dated 30 april 1997.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1995
    Geliefert am 18. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold lands/premises known as land lying to the west of st heliers ave,hove with all fixtures/fittings; esx 74091; all rights,licences and goodwill of business.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1995
    Geliefert am 18. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold lands/premises- land lying to the south of portland rd,aldrington,hove; esx 125380; all fixtures/fittings and all rights,licences and goodwill of business.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Apr. 2019Aufgelöst am
    06. Feb. 2018Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0