CSC PROPERTIES 2021 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CSC PROPERTIES 2021 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02218116 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
- (4521) /
Wo befindet sich CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 40 Broadway London Sw1h 0bu |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| C&C PROPERTIES 2021 LIMITED | 11. Dez. 2001 | 11. Dez. 2001 |
| BROADWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (BROMLEY) LIMITED | 31. März 1988 | 31. März 1988 |
| MODERNTWIN LIMITED | 05. Feb. 1988 | 05. Feb. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Susan Folger am 04. Juni 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Kildea als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kay Elizabeth Chaldecott am 13. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Edward Matthew Giles Roberts als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Kay Elizabeth Chaldecott als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mark Kildea als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Gary Richard Hoskins als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Caroline Kirby als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Yardley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Balbinder Tattar als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Hawksworth als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed c&c properties 2021 LIMITED\certificate issued on 21/05/10 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gary James Yardley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Balbinder Singh Tattar am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian David Hawksworth am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Andrew Fischel am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Susan Folger am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSDEN, Susan | Sekretär | Broadway SW1H 0BU London 40 | British | 68599110004 | ||||||
| CHALDECOTT, Kay Elizabeth | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | England | British | 68694110002 | |||||
| FISCHEL, David Andrew | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 8845220002 | |||||
| HOSKINS, Gary Richard | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BT London 40 | United Kingdom | British | 153902440001 | |||||
| KIRBY, Caroline | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | England | British | 108375400001 | |||||
| ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 154029500001 | |||||
| BOTTLE, Jeremy Stephen | Sekretär | 39 Farnaby Road Shortlands BR1 4BL Bromley Kent | British | 14465210001 | ||||||
| ABEL, John George | Geschäftsführer | 9 Hutton Gate Hutton Mount CM13 2XA Brentwood Essex | Uk | British | 14465220002 | |||||
| BLACK, William Reginald | Geschäftsführer | Marley Side Marley Heights Kingsley Green GU27 3LU Haslemere Surrey | England | British | 41017610002 | |||||
| HAWKSWORTH, Ian David | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 115713550001 | |||||
| JOLLY, Brian Anthony | Geschäftsführer | 14 Links Road KT17 3PS Epsom Surrey | United Kingdom | British | 14465250001 | |||||
| KILDEA, Mark | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 89161850003 | |||||
| MARCUCCILLI, Gary John | Geschäftsführer | 29 Manor Wood Road CR8 4LG Purley Surrey | United Kingdom | British | 65438590002 | |||||
| SAGGERS, John Ian | Geschäftsführer | Galleon House Martlesham Road Little Bealings IP13 6LX Woodbridge Suffolk | British | 35538650002 | ||||||
| SMITH, Aidan Christopher | Geschäftsführer | 50 Wavendon Avenue Chiswick W4 4NS London | United Kingdom | British | 31140320001 | |||||
| TATTAR, Balbinder Singh | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 105287960002 | |||||
| YARDLEY, Gary James | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 55671660002 |
Hat CSC PROPERTIES 2021 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Trust deed | Erstellt am 05. Okt. 2006 Geliefert am 06. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £354,876,000 5.562 per cent. First mortgage debenture stock 2027 of capital & counties debenture PLC and all other moneys under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n sf 358502 l/h marland house 26-29 sloane street and 43-47 (odd numbers) pavillion road kensington london t/n LN216478 * for details of further property charged please refer to form 395 *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 17. Feb. 2006 Geliefert am 22. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/H property k/a queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n SF358502. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First supplemental trust deed | Erstellt am 03. Sept. 2002 Geliefert am 04. Sept. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The principal of £80,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies payable by virtue of any insurances on the mortgaged premises,as defined in the principal deed,pursuant to clauses 17(m) and 17(n) of the principal trust deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 15. Okt. 2001 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/Hold property being dudley house,169 piccadilly,london W1; ngl 804655. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 04. Mai 2000 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/Hold property being 32 and 33 long acre,london WC2; NGL775393. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 21. Mai 1998 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/Hold property being 12 and 14 new fetter lane,london EC4; NGL573821. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 21. Mai 1998 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/Hold property being carrington house,126,128 and 130 regent st,4 regent place and 36,38 and 40 warwick st,london W1; ngl 530323. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 02. Juni 1997 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 11. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/H commonwealth house hammersmith london t/no NGL385177. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assurance and release | Erstellt am 06. Okt. 1994 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/Hold property being capital place,bath rd,harlington; agl 443. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assurance and release | Erstellt am 06. Okt. 1994 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/Hold property being walmar house,288-300 (even) regent st,15-16 great castle st,45-46 margaret st,london W1; t/no ngl 440302. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 14. März 1991 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/Hold property being 190 strand,194 strand,2-8 maltravers st,canberra house,10-16 maltravers st,18-24 maltravers st,1 maltravers street and 7 arundel st,strand,london WC2; t/no NGL32297. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 14. März 1991 Erworben am 03. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/Hold property being marland house,26-29 sloane street and 43-47 (odd nos) pavillion rd,london SW1; t/no LN216478. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0