CSC PROPERTIES 2021 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCSC PROPERTIES 2021 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02218116
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    • (4521) /

    Wo befindet sich CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    40 Broadway
    London
    Sw1h 0bu
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    C&C PROPERTIES 2021 LIMITED11. Dez. 200111. Dez. 2001
    BROADWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (BROMLEY) LIMITED31. März 198831. März 1988
    MODERNTWIN LIMITED05. Feb. 198805. Feb. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Sekretärs für Susan Folger am 04. Juni 2011

    1 SeitenCH03

    legacy

    4 SeitenMG02

    Beendigung der Bestellung von Mark Kildea als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 24. Mai 2011

    • Kapital: GBP 250
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Kay Elizabeth Chaldecott am 13. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    11 SeitenAA

    Ernennung von Edward Matthew Giles Roberts als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Kay Elizabeth Chaldecott als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mark Kildea als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Gary Richard Hoskins als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Caroline Kirby als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Gary Yardley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Balbinder Tattar als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ian Hawksworth als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed c&c properties 2021 LIMITED\certificate issued on 21/05/10
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 11. Mai 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Änderung der Details des Direktors für Gary James Yardley am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Balbinder Singh Tattar am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ian David Hawksworth am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für David Andrew Fischel am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Susan Folger am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARSDEN, Susan
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Sekretär
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    British68599110004
    CHALDECOTT, Kay Elizabeth
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    EnglandBritish68694110002
    FISCHEL, David Andrew
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish8845220002
    HOSKINS, Gary Richard
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    United KingdomBritish153902440001
    KIRBY, Caroline
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    EnglandBritish108375400001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish154029500001
    BOTTLE, Jeremy Stephen
    39 Farnaby Road
    Shortlands
    BR1 4BL Bromley
    Kent
    Sekretär
    39 Farnaby Road
    Shortlands
    BR1 4BL Bromley
    Kent
    British14465210001
    ABEL, John George
    9 Hutton Gate
    Hutton Mount
    CM13 2XA Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    9 Hutton Gate
    Hutton Mount
    CM13 2XA Brentwood
    Essex
    UkBritish14465220002
    BLACK, William Reginald
    Marley Side Marley Heights
    Kingsley Green
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Marley Side Marley Heights
    Kingsley Green
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish41017610002
    HAWKSWORTH, Ian David
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish115713550001
    JOLLY, Brian Anthony
    14 Links Road
    KT17 3PS Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    14 Links Road
    KT17 3PS Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish14465250001
    KILDEA, Mark
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish89161850003
    MARCUCCILLI, Gary John
    29 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    29 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritish65438590002
    SAGGERS, John Ian
    Galleon House
    Martlesham Road Little Bealings
    IP13 6LX Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Galleon House
    Martlesham Road Little Bealings
    IP13 6LX Woodbridge
    Suffolk
    British35538650002
    SMITH, Aidan Christopher
    50 Wavendon Avenue
    Chiswick
    W4 4NS London
    Geschäftsführer
    50 Wavendon Avenue
    Chiswick
    W4 4NS London
    United KingdomBritish31140320001
    TATTAR, Balbinder Singh
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish105287960002
    YARDLEY, Gary James
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Geschäftsführer
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish55671660002

    Hat CSC PROPERTIES 2021 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Trust deed
    Erstellt am 05. Okt. 2006
    Geliefert am 06. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £354,876,000 5.562 per cent. First mortgage debenture stock 2027 of capital & counties debenture PLC and all other moneys under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n sf 358502 l/h marland house 26-29 sloane street and 43-47 (odd numbers) pavillion road kensington london t/n LN216478 * for details of further property charged please refer to form 395 *. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 22. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    F/H property k/a queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n SF358502. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First supplemental trust deed
    Erstellt am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 04. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of £80,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies payable by virtue of any insurances on the mortgaged premises,as defined in the principal deed,pursuant to clauses 17(m) and 17(n) of the principal trust deed.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 15. Okt. 2001
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    L/Hold property being dudley house,169 piccadilly,london W1; ngl 804655.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 04. Mai 2000
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    F/Hold property being 32 and 33 long acre,london WC2; NGL775393.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 21. Mai 1998
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    L/Hold property being 12 and 14 new fetter lane,london EC4; NGL573821.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 21. Mai 1998
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    L/Hold property being carrington house,126,128 and 130 regent st,4 regent place and 36,38 and 40 warwick st,london W1; ngl 530323.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 02. Juni 1997
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 11. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    L/H commonwealth house hammersmith london t/no NGL385177.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assurance and release
    Erstellt am 06. Okt. 1994
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    F/Hold property being capital place,bath rd,harlington; agl 443.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assurance and release
    Erstellt am 06. Okt. 1994
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    L/Hold property being walmar house,288-300 (even) regent st,15-16 great castle st,45-46 margaret st,london W1; t/no ngl 440302.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed
    Erstellt am 14. März 1991
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    L/Hold property being 190 strand,194 strand,2-8 maltravers st,canberra house,10-16 maltravers st,18-24 maltravers st,1 maltravers street and 7 arundel st,strand,london WC2; t/no NGL32297.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    Trust deed
    Erstellt am 14. März 1991
    Erworben am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    L/Hold property being marland house,26-29 sloane street and 43-47 (odd nos) pavillion rd,london SW1; t/no LN216478.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0