GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02220656 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Phoenix Building Central Boulevard Blythe Valley Park Shirley B90 8BG Solihull West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JBA SOFTWARE PRODUCTS LIMITED | 29. Juli 1991 | 29. Juli 1991 |
| OLYMPIC SOFTWARE LIMITED | 11. Feb. 1988 | 11. Feb. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Mai 2012 | 2 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 2 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von George Bisnought als Geschäftsführer am 20. Feb. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2010 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2009 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte vollständige Konten erstellt bis 31. Mai 2008 | 9 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLDROYD, Andrew | Geschäftsführer | The Street Ewhurst GU6 7QD Cranleigh Corner House Surrey United Kingdom | England | British | 136724940001 | |||||
| BISNOUGHT, George | Sekretär | Surley Row Emmer Green RG4 8ND Caversham Flower Hill Berks. United Kingdom | British | 140313340001 | ||||||
| DANIELS, Pascale Isabelle Denise Louise Marie Ghuislaine | Sekretär | 2 Rue Van Winghen Anderlecht 1070 Belgium | British | 86539580001 | ||||||
| DEANE, Keith | Sekretär | 34 Mill Lane SL9 8BA Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 113569550001 | ||||||
| GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr. | Sekretär | 440 Edenbrooke Way FOREIGN Roswell Georgia 30075-7154 Usa | American | 112513570001 | ||||||
| GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr. | Sekretär | 440 Edenbrooke Way FOREIGN Roswell Georgia 30075-7154 Usa | American | 112513570001 | ||||||
| JETHWA, Amritlal | Sekretär | 117 Passage Road Westbury On Trym BS9 3LF Bristol | British | 33776800004 | ||||||
| SUTTON, Matthew Jeremy | Sekretär | 15 Newfield Road DY9 0JP Hagley West Midlands | British | 92738100001 | ||||||
| TOWERS, Antony John | Sekretär | The Hayloft Manor Farm Barns Stratford Road WR11 7PP Honeybourne Worcestershire | British | 91463240002 | ||||||
| WILLIAMS, David | Sekretär | Tong Lodge Ruckley TF11 8PQ Shifnal Salop | British | 4180840002 | ||||||
| WRAGG, Peter Thomas Currie | Sekretär | Bank House Main Street Church Lench WR11 4UE Evesham Worcestershire | British | 101526370002 | ||||||
| WRAGG, Peter Thomas Currie | Sekretär | Bank House Main Street Church Lench WR11 4UE Evesham Worcestershire | British | 101526370002 | ||||||
| BISNOUGHT, George | Geschäftsführer | Surley Row Emmer Green RG4 8ND Caversham Flower Hill Berks. United Kingdom | United Kingdom | British | 140313340001 | |||||
| BRIDDON, Kenneth Carl | Geschäftsführer | Rose Farmhouse Village Road Waverton CH3 7QN Chester Cheshire | British | 76868400001 | ||||||
| CULLENS, Alan Russell | Geschäftsführer | Newfields Chandlers Lane GU46 7SP Yateley Hampshire | British | 99247410001 | ||||||
| FLEISCHER, Russell Lawrence | Geschäftsführer | 1504 Thomas Pl Forw Worth Texas 75252 U.S.A. | United States | American | 154096470001 | |||||
| GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr. | Geschäftsführer | 440 Edenbrooke Way FOREIGN Roswell Georgia 30075-7154 Usa | United States | American | 112513570001 | |||||
| JETHWA, Amritlal | Geschäftsführer | 117 Passage Road Westbury On Trym BS9 3LF Bristol | British | 33776800004 | ||||||
| JONES, John Kevin | Geschäftsführer | Southlands 1 Bearnett Drive WV4 5NN Wolverhampton West Midlands | British | 68103800001 | ||||||
| JORDAN, Philip | Geschäftsführer | 18 Cheyne Court Flood Street SW3 5TP London | British | 51718170002 | ||||||
| KASPER, Jochen Berthold | Geschäftsführer | Taubenstrasse 66740 Saarlouis 8 66740 Germany | Germany | German | 113569900002 | |||||
| KLINGWALL, Per Nils Christer | Geschäftsführer | Forge Cottage 10 Rosemary Lane HP17 8JS Haddenham Buckinghamshire | Swedish | 70508330002 | ||||||
| NEEMAN, Ellen | Geschäftsführer | 1 Tahoe Court Toronto M3b 3m6 Ontario | Canadian | 70543520001 | ||||||
| NELSON, William George | Geschäftsführer | 2217 Hidden Creek Court Lisle Illinois 60532 Usa | American | 50467760007 | ||||||
| ROSE, Malcolm James | Geschäftsführer | 46 Leigh Road WS4 2DS Walsall West Midlands | British | 21913860001 | ||||||
| SCIARD, Bertrand Andre Robert | Geschäftsführer | 15 Avenue Sainte Foy Neuilly Sur Seine 92200 France | French | 70543450001 | ||||||
| VICKERY, Alan Graham | Geschäftsführer | Greensleeves Talbot Avenue B74 3DB Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 4180850001 | |||||
| WHEELER, Paul Michael | Geschäftsführer | Squirrel Lodge Pinewoods Road Longworth OX13 5HH Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 76692640002 | |||||
| WILLIAMS, David | Geschäftsführer | Tong Lodge Ruckley TF11 8PQ Shifnal Salop | England | British | 4180840002 | |||||
| WRIGHT, Timothy John | Geschäftsführer | 55b Hancock Street Lexington Massachusetts 02420 Usa | British | 97675480001 |
Hat GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A loan,guaranty and security agreement | Erstellt am 09. Sept. 2003 Geliefert am 18. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All loans,advances,debts, and principal due or to become due from the borrowers and duties of any kind due from the loan parties to the lender group under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The amount paid to the company on account of any rights of suborgation the company may eequire under any loan document to which it is party; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An intercompany subordination agreement | Erstellt am 09. Sept. 2003 Geliefert am 18. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness due or to become due from the borrowers to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any payment of any kind to any of the subordinated creditors on account of the subordinated indebtedness; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2001 Geliefert am 02. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies or liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent for the lenders (in such capacity the "agent") or any other loan party (as defined) (the "secured party") on any account whatsoever under pursuant to or in connection with the facility agreement (as defined) | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 1999 Geliefert am 07. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant of the loan documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Nov. 1995 Geliefert am 21. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited | |
Kurze Angaben "Eagle house" the slough studley warwickshire and the goodwill and connection of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Nov. 1995 Geliefert am 21. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited | |
Kurze Angaben "Needles house" birmingham road studley warwickshire and the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 16. Nov. 1995 Geliefert am 21. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. In its capacity as trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 21. März 1994 Geliefert am 25. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 1993 Geliefert am 05. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0