TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02223843 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?
- Großhandel mit Arzneimitteln (46460) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Phoenix House Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Wall Family Europe Limited as a person with significant control on 16. Dez. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sean Patrick Ryan als Geschäftsführer am 12. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Hess als Geschäftsführer am 12. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 36 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brendan Wall als Geschäftsführer am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Joseph Wall als Geschäftsführer am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jude David Rake als Geschäftsführer am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anne Marie Wall als Geschäftsführer am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Rashke als Geschäftsführer am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Victor James als Geschäftsführer am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Louise Mary Claire Macdonald als Geschäftsführer am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Newmarket Road CB5 8EP Cambridge 42 England |
| 72965600001 | ||||||||||
FINNIE, Paul Michael | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House United Kingdom | United Kingdom | British | Uk Managing Director | 252314040001 | ||||||||
THOMAS, Lee Michael | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | England | British | Director | 135463070001 | ||||||||
KANE, William John | Sekretär | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | British | Finance Director | 23753080003 | |||||||||
ROBBINS, Richard | Sekretär | Sedgley Alvaston Cottages Middlewich Road Wistaston CW5 6PB Nantwich Cheshire | British | 41393800002 | ||||||||||
WILTON MORGAN, Susan Elizabeth | Sekretär | The Croft Fishers Lane Burland CW5 8LZ Nantwich Cheshire | British | Director | 47772600001 | |||||||||
ANDREWS, Paul | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House United Kingdom | England | British | Director | 208072040001 | ||||||||
BRANDMEIER, Sandra | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | United States | American | Company Director | 175206160002 | ||||||||
CHAUDRY, Muhammed | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Executive | 247031280001 | ||||||||
CONWAY, Robert | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | United States | American | Director | 131804780004 | ||||||||
CROSS, Lori Jo | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | None | 101388320001 | ||||||||
DJAHANBAKHSH, Mohamad | Geschäftsführer | 2 Geddings Road EN11 0NT Hoddesdon Grange House Hertfordshire England | England | British | Director | 178554890001 | ||||||||
EDDY, Jan | Geschäftsführer | Waters Edge Court WT 53578 Prairie Du Sac E12237 Wisconsin | United States | British | Director | 147650010001 | ||||||||
EDWARDS, Martyn Andrew | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United Kingdom | British | Director Of Operations | 175165210001 | ||||||||
FISK, Richard | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | United States | British | Director | 147650250002 | ||||||||
HESS, William | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Director | 259005830001 | ||||||||
HICKEY, Jonathan Steven | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire | England | British | Managing Director | 193367400001 | ||||||||
HOLDEMAN, Steven | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | United States | American | Director | 118362570001 | ||||||||
JAMES, James Victor | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Director | 159359420001 | ||||||||
KANE, William John | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | United Kingdom | British | Finance Director | 23753080003 | ||||||||
LARSON, Greg | Geschäftsführer | Marshfield Bank CW2 8UY Crewe Timstar House Cheshire | Usa | United States | Director | 118360940001 | ||||||||
LEGGETT, Simon Anthony | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | Wales | British | Director | 200132720001 | ||||||||
MACDONALD, Louise Mary Claire | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | None | 156925910001 | ||||||||
PEIRCE, Roger | Geschäftsführer | Marshfield Bank CW2 8UY Crewe Timstar House Cheshire | America | United States | Director | 147797070001 | ||||||||
RAKE, Jude David | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Director | 197140110001 | ||||||||
RASHKE, Daniel | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Owner-Operator | 247018070001 | ||||||||
ROBBINS, Richard | Geschäftsführer | Sedgley Alvaston Cottages Middlewich Road Wistaston CW5 6PB Nantwich Cheshire | British | Secretary | 41393800002 | |||||||||
RYAN, Sean Patrick | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Director | 259006110001 | ||||||||
SOUTHERN, David | Geschäftsführer | Ion Path Winsford Industrial Estate CW7 3BX Winsford Unit 12 Cheshire England | England | British | Managing Director | 162259710001 | ||||||||
STRONER, William | Geschäftsführer | Marshfield Bank CW2 8UY Crewe Timstar House Cheshire | Usa | American | Director | 79444870001 | ||||||||
TOMLINSON, Philip John | Geschäftsführer | Marshfield Bank CW2 8UY Crewe Timstar House Cheshire | England | British | Director | 101436190002 | ||||||||
WALL, Anne Marie | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | N/A | 183795670001 | ||||||||
WALL, Brendan | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Owner-Operator | 247017660001 | ||||||||
WALL, Kevin Joseph | Geschäftsführer | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House England | United States | American | Company Director | 175190420001 | ||||||||
WALL, Kevin | Geschäftsführer | Ten Hillside Avenue Marblehead Massachusetts Ma 01945 Usa | United States | Us Citizen | Director | 131953980001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wf Education Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Stafford Drive Battlefield Enterprise Park SY1 3FE Shrewsbury Phoenix House United Kingdom | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 2002 Geliefert am 10. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a plot 7C marshfield bank middlewich road crewe cheshire CW2 8UY. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Okt. 2001 Geliefert am 05. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The leasehold property known as plot 7C marshfield bank employment park, middlewich road, woolstanwood, crewe, cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Juni 1998 Geliefert am 15. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H unit S1 herald park industrial estate herald drive crewe cheshire CW1 1EA. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 21. Dez. 1994 Geliefert am 07. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The rents reserved and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the lease and this deed | |
Kurze Angaben The sum of £2,795.00 and all other monies standing to the credit from time to time in an account at national westminster bank PLC stratford place branch london W1 (account number 50497901). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Mai 1989 Geliefert am 25. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0