TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED

TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02223843
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?

    • Großhandel mit Arzneimitteln (46460) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Phoenix House Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2020 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Change of details for Wall Family Europe Limited as a person with significant control on 16. Dez. 2019

    2 SeitenPSC05

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    11 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2019

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    The cancellatioin and extinguishing of ordinary shares 12/12/2019
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Sean Patrick Ryan als Geschäftsführer am 12. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von William Hess als Geschäftsführer am 12. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    20 SeitenAA

    legacy

    36 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    2 SeitenGUARANTEE2

    Beendigung der Bestellung von Brendan Wall als Geschäftsführer am 22. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kevin Joseph Wall als Geschäftsführer am 22. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jude David Rake als Geschäftsführer am 22. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anne Marie Wall als Geschäftsführer am 22. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Daniel Rashke als Geschäftsführer am 22. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James Victor James als Geschäftsführer am 22. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Louise Mary Claire Macdonald als Geschäftsführer am 22. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HS SECRETARIAL LIMITED
    Newmarket Road
    CB5 8EP Cambridge
    42
    England
    Sekretär
    Newmarket Road
    CB5 8EP Cambridge
    42
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer04069036
    72965600001
    FINNIE, Paul Michael
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    United Kingdom
    United KingdomBritishUk Managing Director252314040001
    THOMAS, Lee Michael
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    EnglandBritishDirector135463070001
    KANE, William John
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Sekretär
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    BritishFinance Director23753080003
    ROBBINS, Richard
    Sedgley Alvaston Cottages
    Middlewich Road Wistaston
    CW5 6PB Nantwich
    Cheshire
    Sekretär
    Sedgley Alvaston Cottages
    Middlewich Road Wistaston
    CW5 6PB Nantwich
    Cheshire
    British41393800002
    WILTON MORGAN, Susan Elizabeth
    The Croft Fishers Lane
    Burland
    CW5 8LZ Nantwich
    Cheshire
    Sekretär
    The Croft Fishers Lane
    Burland
    CW5 8LZ Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector47772600001
    ANDREWS, Paul
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector208072040001
    BRANDMEIER, Sandra
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    United StatesAmericanCompany Director175206160002
    CHAUDRY, Muhammed
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanExecutive247031280001
    CONWAY, Robert
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    United StatesAmericanDirector131804780004
    CROSS, Lori Jo
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanNone101388320001
    DJAHANBAKHSH, Mohamad
    2 Geddings Road
    EN11 0NT Hoddesdon
    Grange House
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    2 Geddings Road
    EN11 0NT Hoddesdon
    Grange House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector178554890001
    EDDY, Jan
    Waters Edge Court
    WT 53578 Prairie Du Sac
    E12237
    Wisconsin
    Geschäftsführer
    Waters Edge Court
    WT 53578 Prairie Du Sac
    E12237
    Wisconsin
    United StatesBritishDirector147650010001
    EDWARDS, Martyn Andrew
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United KingdomBritishDirector Of Operations175165210001
    FISK, Richard
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    United StatesBritishDirector147650250002
    HESS, William
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanDirector259005830001
    HICKEY, Jonathan Steven
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director193367400001
    HOLDEMAN, Steven
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    United StatesAmericanDirector118362570001
    JAMES, James Victor
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanDirector159359420001
    KANE, William John
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director23753080003
    LARSON, Greg
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    UsaUnited StatesDirector118360940001
    LEGGETT, Simon Anthony
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    WalesBritishDirector200132720001
    MACDONALD, Louise Mary Claire
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanNone156925910001
    PEIRCE, Roger
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    AmericaUnited StatesDirector147797070001
    RAKE, Jude David
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanDirector197140110001
    RASHKE, Daniel
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanOwner-Operator247018070001
    ROBBINS, Richard
    Sedgley Alvaston Cottages
    Middlewich Road Wistaston
    CW5 6PB Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Sedgley Alvaston Cottages
    Middlewich Road Wistaston
    CW5 6PB Nantwich
    Cheshire
    BritishSecretary41393800002
    RYAN, Sean Patrick
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanDirector259006110001
    SOUTHERN, David
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Ion Path
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3BX Winsford
    Unit 12
    Cheshire
    England
    EnglandBritishManaging Director162259710001
    STRONER, William
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    UsaAmericanDirector79444870001
    TOMLINSON, Philip John
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    Timstar House
    Cheshire
    EnglandBritishDirector101436190002
    WALL, Anne Marie
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanN/A183795670001
    WALL, Brendan
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanOwner-Operator247017660001
    WALL, Kevin Joseph
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    Geschäftsführer
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    England
    United StatesAmericanCompany Director175190420001
    WALL, Kevin
    Ten Hillside Avenue
    Marblehead
    Massachusetts Ma 01945
    Usa
    Geschäftsführer
    Ten Hillside Avenue
    Marblehead
    Massachusetts Ma 01945
    Usa
    United StatesUs CitizenDirector131953980001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Wf Education Group Holdings Limited
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Stafford Drive
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3FE Shrewsbury
    Phoenix House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat TIMSTAR LABORATORY SUPPLIERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a plot 7C marshfield bank middlewich road crewe cheshire CW2 8UY. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Okt. 2001
    Geliefert am 05. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as plot 7C marshfield bank employment park, middlewich road, woolstanwood, crewe, cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1998
    Geliefert am 15. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H unit S1 herald park industrial estate herald drive crewe cheshire CW1 1EA. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 21. Dez. 1994
    Geliefert am 07. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The rents reserved and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the lease and this deed
    Kurze Angaben
    The sum of £2,795.00 and all other monies standing to the credit from time to time in an account at national westminster bank PLC stratford place branch london W1 (account number 50497901).
    Berechtigte Personen
    • Donington Investments Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Mai 1989
    Geliefert am 25. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transaktionen
    • 25. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0