HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02223858 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Hanover Square W1S 1HQ London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
NEWSONG LIMITED | 24. Feb. 1988 | 24. Feb. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Aycliffe and Peterlee Investment Company Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Eric Slade als Geschäftsführer am 25. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Helical Registrars Limited am 01. Sept. 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 11-15 Farm Street London W1J 5RS zum 5 Hanover Square London W1S 1HQ am 18. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy John Murphy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Mcnair Scott als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELICAL REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England |
| 89869830001 | ||||||||||
KAYE, Gerald Anthony | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United Kingdom | British | Development Director | 38299690006 | ||||||||
MURPHY, Timothy John | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | Chartered Accountant | 40547240005 | ||||||||
GONDHIA, Sima | Sekretär | 114 Squirrels Heath Lane RM11 2DY Hornchurch Essex | British | 83926180001 | ||||||||||
GONDHIA, Sima | Sekretär | 114 Squirrels Heath Lane RM11 2DY Hornchurch Essex | British | 83926180001 | ||||||||||
MARSTON, Lisa Margaret | Sekretär | 18 Terrapin Road Tooting SW17 8QN London | British | 27528570001 | ||||||||||
ROLFE, Lee-Ann | Sekretär | Flat 2 307 Upper Richmond Road Putney SW15 6SS London | South African | 79280470001 | ||||||||||
BUTCHER, Michael William | Geschäftsführer | 19 Rigault Road SW6 4JJ London | British | Chartered Surveyor | 1279410002 | |||||||||
MCNAIR SCOTT, Nigel Guthrie | Geschäftsführer | 11-15 Farm Street London W1J 5RS | England | British | Finance Director | 6065190002 | ||||||||
MOSS, Brian | Geschäftsführer | 70 Deverill Court Avenue Road SE20 7SA London | British | Company Director | 35008800001 | |||||||||
SCOTT, Clive David | Geschäftsführer | Eildon Hall TD6 9HD Melrose Roxburghshire | British | Company Director | 48826800001 | |||||||||
SLADE, Michael Eric | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | Managing Director | 38913980001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aycliffe And Peterlee Investment Company Limited | 06. Apr. 2016 | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent on any account whatsoever. Under the terms of a loan agreement dated 23.6.89 and the mortgage debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
First legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/89 as defined therein. | |
Kurze Angaben Land k/a 116, crayford rd., Bexley, kent title no: p 48787 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and materials of all kinds. Please see mort. Doc. M378 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security. | Erstellt am 12. Mai 1989 Geliefert am 19. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from aycliffe & peterlee investment co LTD. Under the terms of a syndicated loan agreement dated 11-7-88. to the chargee | |
Kurze Angaben Clifton trading estate extending to 6-57 acre or thereby at newbridge midlothian. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 1989 Geliefert am 03. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from aycliffe and peterlee investment company limited to the chargee on any account whatsoever. Under the terms of a loan agreement dated 11.7.88. | |
Kurze Angaben F/H property k/a land & buildings on north side of hereward rise, halesowen, title no wm 109934 & all income arising from the property. Floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 1989 Geliefert am 03. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from aycliffe and peterlee investment company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 11.7.88. | |
Kurze Angaben L/H property comprising land & buildings on south west side of finlan road, stakehill industrial park, middleton, rochdale, greater manchester title no. Gm 424985 & all income arising from the property. Floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
First legal charge | Erstellt am 13. März 1989 Geliefert am 29. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for and on behalf of the banks) as defined in the charge under the terms of a loan agreement dated 13-3-89. | |
Kurze Angaben Land on the north west side of boarshaw lane middleton rochdale greater manchester (title no: gm 464167.) floating charge over all a charge over all insurance monies received in respect of the property.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 11. Juli 1988 Geliefert am 28. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks named in the charge on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 11.7.88 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Juli 1988 Geliefert am 28. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks named in the charge under the terms of the loan agreement dated 11.7.88 | |
Kurze Angaben Fist legal charge over land & buildings on the north side of charlton mead lane, hoddesdon, herfordshire, title no hd 139375. land k/a southbury works, adjoining lincoln way. Title no mx 132743 land & buildings north & east of lincoln way, enfield. Title no mx 74097. land east of great cambridge road, enfield. Title no ngl 220384. land on south side of southbury road, enfield title no ngl 334012. land with frontages to princess elizabeth way & kings mead road, cheltenham gloucestershire. Land at tramway industrial estate, banbury, oxford; haslemere industrial estate, pig lane, bishop's stortford, hertford, wigan road, bryn, ashton-in-makerfield, lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 26. Mai 1988 Geliefert am 02. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First legal charge 1 land and buildings on the north side of charlton mead lane, hoddesdon, hertfordshire f/h title no hd 139375 (2A) f/h land k/a southbury works adjoining lincoln way in the london borough of enfield. Title no mx 132742 (b) land and buildings to the north and east of lincoln way enfield f/h title no mx 74097. (c) land lying to the east of great cambridge road, enfield f/h title no ngl 220384. (d) the land on the south side of southbury road enfield f/h title no ngl 334012. (3) land having frontages to princess elizabeth way and kings mead road (formerly arle road) cheltenham, gloucester. (4) land at tramway industrial estate banbury in the county of oxford (6) land at haslemere industrial estate pig lane bishops stortford in the county of hereford now k/a haslemere industrial estate pig lane bishop's stortford. (6) land at wigan road, bryn ashton - makerfield, lancashire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0