HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED

HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02223858
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Hanover Square
    W1S 1HQ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NEWSONG LIMITED24. Feb. 198824. Feb. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Notification of Aycliffe and Peterlee Investment Company Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Michael Eric Slade als Geschäftsführer am 25. Juli 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Juli 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 31. Juli 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Helical Registrars Limited am 01. Sept. 2014

    1 SeitenCH04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    13 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 11-15 Farm Street London W1J 5RS zum 5 Hanover Square London W1S 1HQ am 18. Aug. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 06. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    14 SeitenAA

    Ernennung von Mr Timothy John Murphy als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Mcnair Scott als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HELICAL REGISTRARS LIMITED
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Sekretär
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4701446
    89869830001
    KAYE, Gerald Anthony
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritishDevelopment Director38299690006
    MURPHY, Timothy John
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritishChartered Accountant40547240005
    GONDHIA, Sima
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    Sekretär
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    British83926180001
    GONDHIA, Sima
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    Sekretär
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    British83926180001
    MARSTON, Lisa Margaret
    18 Terrapin Road
    Tooting
    SW17 8QN London
    Sekretär
    18 Terrapin Road
    Tooting
    SW17 8QN London
    British27528570001
    ROLFE, Lee-Ann
    Flat 2 307 Upper Richmond Road
    Putney
    SW15 6SS London
    Sekretär
    Flat 2 307 Upper Richmond Road
    Putney
    SW15 6SS London
    South African79280470001
    BUTCHER, Michael William
    19 Rigault Road
    SW6 4JJ London
    Geschäftsführer
    19 Rigault Road
    SW6 4JJ London
    BritishChartered Surveyor1279410002
    MCNAIR SCOTT, Nigel Guthrie
    11-15 Farm Street
    London
    W1J 5RS
    Geschäftsführer
    11-15 Farm Street
    London
    W1J 5RS
    EnglandBritishFinance Director6065190002
    MOSS, Brian
    70 Deverill Court
    Avenue Road
    SE20 7SA London
    Geschäftsführer
    70 Deverill Court
    Avenue Road
    SE20 7SA London
    BritishCompany Director35008800001
    SCOTT, Clive David
    Eildon Hall
    TD6 9HD Melrose
    Roxburghshire
    Geschäftsführer
    Eildon Hall
    TD6 9HD Melrose
    Roxburghshire
    BritishCompany Director48826800001
    SLADE, Michael Eric
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritishManaging Director38913980001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Aycliffe And Peterlee Investment Company Limited
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    06. Apr. 2016
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Registrierungsnummer2195005
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat HELICAL PROPERTIES (HSM) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Juni 1989
    Geliefert am 11. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent on any account whatsoever. Under the terms of a loan agreement dated 23.6.89 and the mortgage debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank
    Transaktionen
    • 11. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First legal charge
    Erstellt am 23. Juni 1989
    Geliefert am 11. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/89 as defined therein.
    Kurze Angaben
    Land k/a 116, crayford rd., Bexley, kent title no: p 48787 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and materials of all kinds. Please see mort. Doc. M378 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank.
    Transaktionen
    • 11. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security.
    Erstellt am 12. Mai 1989
    Geliefert am 19. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from aycliffe & peterlee investment co LTD. Under the terms of a syndicated loan agreement dated 11-7-88. to the chargee
    Kurze Angaben
    Clifton trading estate extending to 6-57 acre or thereby at newbridge midlothian.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank.
    Transaktionen
    • 19. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 1989
    Geliefert am 03. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from aycliffe and peterlee investment company limited to the chargee on any account whatsoever. Under the terms of a loan agreement dated 11.7.88.
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land & buildings on north side of hereward rise, halesowen, title no wm 109934 & all income arising from the property. Floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank.
    Transaktionen
    • 03. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 1989
    Geliefert am 03. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from aycliffe and peterlee investment company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 11.7.88.
    Kurze Angaben
    L/H property comprising land & buildings on south west side of finlan road, stakehill industrial park, middleton, rochdale, greater manchester title no. Gm 424985 & all income arising from the property. Floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank.
    Transaktionen
    • 03. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First legal charge
    Erstellt am 13. März 1989
    Geliefert am 29. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for and on behalf of the banks) as defined in the charge under the terms of a loan agreement dated 13-3-89.
    Kurze Angaben
    Land on the north west side of boarshaw lane middleton rochdale greater manchester (title no: gm 464167.) floating charge over all a charge over all insurance monies received in respect of the property.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank.
    Transaktionen
    • 29. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Juli 1988
    Geliefert am 28. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks named in the charge on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 11.7.88
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank
    Transaktionen
    • 28. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 1988
    Geliefert am 28. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks named in the charge under the terms of the loan agreement dated 11.7.88
    Kurze Angaben
    Fist legal charge over land & buildings on the north side of charlton mead lane, hoddesdon, herfordshire, title no hd 139375. land k/a southbury works, adjoining lincoln way. Title no mx 132743 land & buildings north & east of lincoln way, enfield. Title no mx 74097. land east of great cambridge road, enfield. Title no ngl 220384. land on south side of southbury road, enfield title no ngl 334012. land with frontages to princess elizabeth way & kings mead road, cheltenham gloucestershire. Land at tramway industrial estate, banbury, oxford; haslemere industrial estate, pig lane, bishop's stortford, hertford, wigan road, bryn, ashton-in-makerfield, lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank
    Transaktionen
    • 28. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 15. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. Mai 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First legal charge 1 land and buildings on the north side of charlton mead lane, hoddesdon, hertfordshire f/h title no hd 139375 (2A) f/h land k/a southbury works adjoining lincoln way in the london borough of enfield. Title no mx 132742 (b) land and buildings to the north and east of lincoln way enfield f/h title no mx 74097. (c) land lying to the east of great cambridge road, enfield f/h title no ngl 220384. (d) the land on the south side of southbury road enfield f/h title no ngl 334012. (3) land having frontages to princess elizabeth way and kings mead road (formerly arle road) cheltenham, gloucester. (4) land at tramway industrial estate banbury in the county of oxford (6) land at haslemere industrial estate pig lane bishops stortford in the county of hereford now k/a haslemere industrial estate pig lane bishop's stortford. (6) land at wigan road, bryn ashton - makerfield, lancashire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific National Bank
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 15. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0