DATAFORM (NORTHERN) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DATAFORM (NORTHERN) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02229065 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DATAFORM (NORTHERN) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich DATAFORM (NORTHERN) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Communisis House Manston Lane LS15 8AH Leeds |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DATAFORM (NORTHERN) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
YORKSHIRE BUSINESS FORMS LIMITED | 24. Juni 1988 | 24. Juni 1988 |
BANGQUOTE LIMITED | 10. März 1988 | 10. März 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DATAFORM (NORTHERN) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DATAFORM (NORTHERN) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven Clive Rawlins als Sekretär am 28. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sarah Louise Caddy als Sekretär am 28. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Miss Sarah Louise Caddy am 15. Aug. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Rowlatt Huber Riddle am 15. Aug. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Wakefield Road Leeds West Yorkshire LS10 1DU zum Communisis House Manston Lane Leeds LS15 8AH am 15. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Miss Sarah Louise Morton am 20. Sept. 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DATAFORM (NORTHERN) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAWLINS, Steven Clive | Sekretär | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | 256219410001 | |||||||
RIDDLE, Jonathan Rowlatt Huber | Geschäftsführer | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | England | British | Tax Manager | 53609030001 | ||||
CADDY, Sarah Louise | Sekretär | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | 146627560002 | |||||||
EGERTON, Peter Wilfrid | Sekretär | 54 Callander Ouston DH2 1LG Chester Le Street County Durham | British | 6042050002 | ||||||
MILTON, Keith Bertram | Sekretär | 25 Rectory Grove NE3 1AL Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Company Secretary | 76950940001 | |||||
WARE, Andrew | Sekretär | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | British | Director | 110947260001 | |||||
WORSNOP, Marshall Barry | Sekretär | 6 Florence Road HG2 0LD Harrogate North Yorkshire | British | 22406990001 | ||||||
WYNDHAM, Rupert Charles Edward | Sekretär | Oakwood 15 Crabtree Road NE43 7NX Stocksfield Northumberland | British | Company Secretary | 43721290001 | |||||
YOUNG, Martin Keay | Sekretär | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | British | Company Secretary | 41926620002 | |||||
GOLDMAN, Alan David | Geschäftsführer | 13 Fernville Road Gosforth NE3 4HT Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Director | 6042060001 | |||||
HARRISON, Kenneth John | Geschäftsführer | 5 St Georges Avenue Timperley WA15 6HF Altrincham Cheshire | British | North West Divisional Director | 9436420001 | |||||
HOLBROOK, Bradley | Geschäftsführer | North Moor 36 Station Road Stannington NE61 6DU Morpeth Northumberland | England | British | Company Director | 50693590001 | ||||
HOLBROOK, Graham | Geschäftsführer | 19 Ashdale Mount Pleasant DH4 7SL Fatfield, Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | Company Director | 50927850001 | |||||
MILTON, Keith Bertram | Geschäftsführer | 25 Rectory Grove NE3 1AL Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Company Director | 76950940001 | |||||
MORAN, Denise | Geschäftsführer | Beech House High Street Billingley S72 0HY Barnsley South Yorkshire | British | Director | 99531800001 | |||||
POWELL, Bruce Lewis Hamilton | Geschäftsführer | Broadhatch House Bentley GU10 5JJ Farnham Surrey | United Kingdom | British | Director | 15809770001 | ||||
PYGALL, Christopher | Geschäftsführer | 1 Mulberry Close NE24 3XR Blyth Northumberland | British | Company Director | 56373380002 | |||||
RATCLIFFE, Paula Eileen | Geschäftsführer | The Grange Granby NG13 9PW Nottingham | British | Director | 50190420001 | |||||
SIMPSON, Paul Stephen | Geschäftsführer | The Corfields Pinfold Lane DN6 0ED Moss South Yorkshire | England | British | Director | 150743370001 | ||||
SPENCE, Ian Roger | Geschäftsführer | 6 Redhills Lane DH1 4AJ Durham | British | Marketing | 79113550001 | |||||
STEEN, John Matheson | Geschäftsführer | 88 Main Street Felton NE65 9PZ Morpeth Northumberland | British | Director | 56207820002 | |||||
WALKER, Paul Ashton | Geschäftsführer | 1 Furzefield Road Gosforth NE3 4EA Newcastle Upon Tyne | British | Company Director | 19807800002 | |||||
WARE, Andrew | Geschäftsführer | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | United Kingdom | British | Director | 110947260001 | ||||
WORSNOP, Marshall Barry | Geschäftsführer | 6 Florence Road HG2 0LD Harrogate North Yorkshire | British | Regional Sales Manager | 22406990001 | |||||
YOUNG, Martin Keay | Geschäftsführer | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Secretary | 41926620002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DATAFORM (NORTHERN) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communisis Dataform Limited | 06. Apr. 2016 | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat DATAFORM (NORTHERN) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 18. Dez. 1997 Geliefert am 27. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as yorkshire business forms limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Dez. 1994 Geliefert am 03. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 7 didcot way boldon business park boldon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Mai 1993 Geliefert am 13. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 7 didcot way, boldon business park, boldon. By way of fixed charged all the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils now and in the future at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. Juni 1990 Geliefert am 30. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 7 didcot way, boldon business park, boldon, tyne & wear fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment & fixtures & fittings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Okt. 1989 Geliefert am 11. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 48 bradford road stanningley, leeds west yorkshire title no wyk 385329 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixtures & fittings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Mai 1988 Geliefert am 07. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0