CAREDANE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CAREDANE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02230267 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAREDANE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CAREDANE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 238 Station Road Addlestone KT15 2PS Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAREDANE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2015 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CAREDANE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CAREDANE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mahesh Shivabhai Patel am 04. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Surendra Shivabhai Patel am 04. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für John Neal Alflatt am 04. Feb. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 08. Jan. 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAREDANE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFLATT, John Neal | Sekretär | Station Road KT15 2PS Addlestone 238 Surrey United Kingdom | British | 86320800002 | ||||||
| PATEL, Mahesh Shivabhai | Geschäftsführer | Station Road KT15 2PS Addlestone 238 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 80756410001 | |||||
| PATEL, Surendra Shivabhai | Geschäftsführer | Station Road KT15 2PS Addlestone 238 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 44101520001 | |||||
| HUSSAIN, Mussarat | Sekretär | 52 Beeston Fields Drive Beeston NG9 3DD Nottingham Nottinghamshire | British | 9650510001 | ||||||
| GIRDHER, Andrew Rajesh, Doctor | Geschäftsführer | 72b Mayford Road SW12 8SN London | British | 36908100002 | ||||||
| GIRDHER, Raj Kumar | Geschäftsführer | 56 Beeston Fields Drive Beeston NG9 3DD Nottingham Nottinghamshire | British | 9650520001 | ||||||
| HUSSAIN, Mussarat | Geschäftsführer | 52 Beeston Fields Drive Beeston NG9 3DD Nottingham Nottinghamshire | England | British | 9650510001 | |||||
| HUSSAIN, Syed Iqbal Tawassul | Geschäftsführer | 52 Beeston Fields Drive Beeston NG9 3DD Nottingham Nottinghamshire | British | 36908280001 |
Hat CAREDANE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 20. Jan. 2006 Geliefert am 01. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Jan. 2006 Geliefert am 27. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h land known a 108 110 112 and 114 broadgate beeston broxtowe chilwell nottinghamshire t/n NT185339,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Jan. 2006 Geliefert am 27. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as land and buildings lying on the south side of middle street beeston broxtowe nottinghamshire t/n NT16550 and f/h land and buildings on the south west side of hallam road chilwell broxtowe nottinghamshire t/n NT297456,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Jan. 1998 Geliefert am 03. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that freehold property known as land and buildings on the south side of middle street, beeston, nottingham title number NT16550 and all that property known as land and buildings on the south west side of hallam road, chilwell, nottingham title number NT297456. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Juli 1988 Geliefert am 03. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 108,110,112 & 114 broadgate beeston nottinghamshire fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0