AUS REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAUS REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02235248
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AUS REALISATIONS LIMITED?

    • (4030) /

    Wo befindet sich AUS REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    159 Huddersfield Road
    Oldham
    OL1 3PA
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AUS REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ATLANTIC UTILITY SERVICES LIMITED27. Aug. 199927. Aug. 1999
    NEW EARTH WATER SERVICES LIMITED24. März 199324. März 1993
    NEW EARTH PLUMBING (1988) LIMITED24. März 198824. März 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AUS REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2003

    Welche sind die letzten Einreichungen für AUS REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92
    RQO0KREU

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Vermögensübersicht in der Zwangsverwaltung nach Bericht an die Gläubiger

    37 Seiten3.3

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    6 Seiten3.10

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed atlantic utility services limite d\certificate issued on 03/12/04
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    21 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002

    21 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten403b

    legacy

    3 Seiten403b

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von AUS REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRETT, Ian Martin
    13 Thumwood
    Chineham
    RG24 8TE Basingstoke
    Hampshire
    Sekretär
    13 Thumwood
    Chineham
    RG24 8TE Basingstoke
    Hampshire
    BritishAccountant69955670003
    BEAN, David John
    2 Park Wood Way
    BD23 1UZ Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Park Wood Way
    BD23 1UZ Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishOperations Director89962140001
    BRETT, Ian Martin
    13 Thumwood
    Chineham
    RG24 8TE Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    13 Thumwood
    Chineham
    RG24 8TE Basingstoke
    Hampshire
    BritishAccountant69955670003
    SOUTHON, Anthony David
    4 Cavendish Court
    RG14 2RY Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    4 Cavendish Court
    RG14 2RY Newbury
    Berkshire
    BritishDirector68703840004
    TURNER, Graham Ronald
    2 The Lees
    Ardsley
    S71 5HJ Barnsley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 The Lees
    Ardsley
    S71 5HJ Barnsley
    South Yorkshire
    BritishDirector92870450001
    ENTWISTLE, Jayne
    203 Broad Lane
    Burnedge
    OL16 4PU Rochdale
    Lancashire
    Sekretär
    203 Broad Lane
    Burnedge
    OL16 4PU Rochdale
    Lancashire
    BritishCompany Secretary/Director41787520001
    ENTWISTLE, Jayne
    203 Broad Lane
    Burnedge
    OL16 4PU Rochdale
    Lancashire
    Sekretär
    203 Broad Lane
    Burnedge
    OL16 4PU Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector41787520001
    HALLETT, Ricky Courtney
    20 St Davids Road
    Maesycwmmer
    CF82 7QU Hengoed
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    20 St Davids Road
    Maesycwmmer
    CF82 7QU Hengoed
    Mid Glamorgan
    BritishDirector56262290002
    WIBBERLEY, Margaret
    West End Lodge
    67 Ashley Road
    FY8 3EL St Annes On Sea
    Lancashire
    Sekretär
    West End Lodge
    67 Ashley Road
    FY8 3EL St Annes On Sea
    Lancashire
    British23000390002
    ADAMS, Rodney
    5 Chapel Row Broad Lane
    OL16 4QQ Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    5 Chapel Row Broad Lane
    OL16 4QQ Rochdale
    Lancashire
    BritishContract Development Director55257060004
    BROWNBRIDGE, James
    11 Broadacre
    Norden
    OL12 7RP Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    11 Broadacre
    Norden
    OL12 7RP Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector37159980001
    CLARK, Raymond Harry
    183 Counthill Road
    Moorside
    OL4 2PX Oldham
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    183 Counthill Road
    Moorside
    OL4 2PX Oldham
    Greater Manchester
    BritishDirector39454680001
    CROWTHER, Gary
    43 Ivy Green Drive
    Springhead
    OL4 4PR Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    43 Ivy Green Drive
    Springhead
    OL4 4PR Oldham
    Lancashire
    BritishPlumber23000360001
    EDWARDS, Stephen Gerald
    288 New Chester Road
    Port Sunlight
    L62 4RH Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    288 New Chester Road
    Port Sunlight
    L62 4RH Wirral
    Merseyside
    BritishProject Director55257190001
    ENTWISTLE, Jayne
    203 Broad Lane
    Burnedge
    OL16 4PU Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    203 Broad Lane
    Burnedge
    OL16 4PU Rochdale
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector41787520001
    EVANS, Phillip David
    20 Bron Y Deri
    CF45 4LL Mountain Ash
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    20 Bron Y Deri
    CF45 4LL Mountain Ash
    Mid Glamorgan
    United KingdomBritishDirector22452160001
    FORD, Alan
    11 Lovers Lane
    Grasscroft
    OL4 4DP Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    11 Lovers Lane
    Grasscroft
    OL4 4DP Oldham
    Lancashire
    BritishDirector63803480001
    HALOM, Victor Lewis
    5 Richbell Close
    Irlam
    M44 5DG Manchester
    Salford
    Geschäftsführer
    5 Richbell Close
    Irlam
    M44 5DG Manchester
    Salford
    BritishDirector72098570002
    HODSON, Jack
    17 Dunsters Avenue
    Brandlesholme
    BL8 1EF Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    17 Dunsters Avenue
    Brandlesholme
    BL8 1EF Bury
    Lancashire
    BritishDirector39454640001
    HOUGHTON, Brenda
    57 Cathedral Road
    OL9 0RP Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    57 Cathedral Road
    OL9 0RP Oldham
    Lancashire
    BritishPersonnel Director55257140001
    HOUGHTON, Gary
    57 Cathedral Road
    Chadderton
    OL9 0RP Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    57 Cathedral Road
    Chadderton
    OL9 0RP Oldham
    Lancashire
    BritishDirector23000370003
    HUDSON, Alison Charlotte
    Marine House
    Marine Parade
    CF64 3BE Penarth
    S Glam
    Geschäftsführer
    Marine House
    Marine Parade
    CF64 3BE Penarth
    S Glam
    BritishDirector17452970001
    JAY, Christopher
    14 Blackchapel Drive
    Hurst Meadow
    OL16 4QU Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Blackchapel Drive
    Hurst Meadow
    OL16 4QU Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector37160070002
    JAY, Robert
    36 Thornham Lane
    Royton
    OL2 6UW Oldham
    Geschäftsführer
    36 Thornham Lane
    Royton
    OL2 6UW Oldham
    BritishDirector37159830002
    KELLAR, John Trevor
    19 Sharon Close
    OL7 0DW Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Geschäftsführer
    19 Sharon Close
    OL7 0DW Ashton Under Lyne
    Lancashire
    BritishSystems Director55257010001
    KILDUFF, Terence
    40 Mayfair Close
    Great Sankey
    WA5 3PL Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    40 Mayfair Close
    Great Sankey
    WA5 3PL Warrington
    Cheshire
    BritishDirector38997770001
    LEECH, David Ernest
    62 Sherwood Way
    High Crompton
    OL2 7NB Shaw
    Lancashire
    Geschäftsführer
    62 Sherwood Way
    High Crompton
    OL2 7NB Shaw
    Lancashire
    BritishProject Director103315030002
    LEVER, Philip
    10 Delta Close
    Royton
    OL2 5DR Oldham
    Geschäftsführer
    10 Delta Close
    Royton
    OL2 5DR Oldham
    BritishDirector37160140002
    LOCK, Stuart
    25 Usk Way
    CF62 7XL Barry
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    25 Usk Way
    CF62 7XL Barry
    South Glamorgan
    BritishResearch And Development Dir55256930001
    MCDERMOTT, Karen
    19 Winchester Avenue
    Chadderton
    OL9 0RH Oldham
    Geschäftsführer
    19 Winchester Avenue
    Chadderton
    OL9 0RH Oldham
    BritishProject Director55257370001
    OLIVER, Derek
    7 Polefield Road
    Blackley
    Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Polefield Road
    Blackley
    Manchester
    Lancashire
    BritishDirector39626030001
    PARTRIDGE, Richard Ennis
    14 Elms Park
    Miskin
    CF7 8PU Pontyclun
    Mid-Glamorgan
    Geschäftsführer
    14 Elms Park
    Miskin
    CF7 8PU Pontyclun
    Mid-Glamorgan
    WalesBritishDirector17453010001
    PATTERSON, John
    14 Randolph Street
    Bramley
    LS13 3HT Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    14 Randolph Street
    Bramley
    LS13 3HT Leeds
    Yorkshire
    BritishDirector39454600001
    ROPER, Paul
    135 Nore Road
    Portishead
    BS20 8DX Bristol
    North Somerset
    Geschäftsführer
    135 Nore Road
    Portishead
    BS20 8DX Bristol
    North Somerset
    BritishProject Director55257260001
    SHARP, Nicholas
    21 Higher Rise
    High Crompton Shaw
    OL2 7QD Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    21 Higher Rise
    High Crompton Shaw
    OL2 7QD Oldham
    Lancashire
    BritishDirector37160300002

    Hat AUS REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Feb. 2004
    Geliefert am 13. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of deposit
    Erstellt am 24. Dez. 2003
    Geliefert am 31. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation NO09222359 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    All asset debenture
    Erstellt am 20. Mai 2003
    Geliefert am 23. Mai 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transaktionen
    • 23. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2004Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 12. Okt. 2006Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
      • Aktenzeichen 1
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Okt. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Business Cashflow Finance Limited
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Juni 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 23. Jan. 2002
    Geliefert am 02. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all (a) specified debts being any book debts the ownership of which shall fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (b) all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever; by way of floating charge the undertaking and all the property rights and assets of the company.
    Berechtigte Personen
    • First National Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Licence to alter
    Erstellt am 05. Juni 2001
    Geliefert am 21. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the licence at the end of term under a lease dated 27/05/80
    Kurze Angaben
    All monies (including interest) standing to the credit of the account to be opened in a UK clearing bank in which the sum of £5,000 has been deposited.
    Berechtigte Personen
    • Quattrocento Limited
    Transaktionen
    • 21. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2001
    Geliefert am 07. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2000
    Geliefert am 19. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as unit 20,bristol vale,centre for industry,hartcliffe way,bristol and parking spaces; t/no av 129563.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 27. März 2000
    Geliefert am 12. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juli 1998
    Geliefert am 11. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Apr. 1997
    Geliefert am 06. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H-159 huddersfield road oldham greater manchester t/nos. GM241955 and LA310690 and/or the proceeds of sale thereof, floating charge over all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, and an assignment of the goodwill and connection of any business, together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Sept. 1994
    Geliefert am 06. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    West end lodge, 67 ashley road, st annes, lancashire. T/n LA442789.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Aug. 1992
    Geliefert am 27. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AUS REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Mai 2003Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony R Fanshawe
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Praktiker
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Stephen John Adshead
    Fanshawe Lofts
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Praktiker
    Fanshawe Lofts
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0