YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02240906 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Monkspath Hall Road B90 4SJ Solihull United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MAJORLOCAL LIMITED | 06. Apr. 1988 | 06. Apr. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 26. Feb. 2026 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 26. Nov. 2026 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Sept. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Okt. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Sept. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2025 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Forvis Mazars Company Secretaries Limited als Sekretär am 16. Sept. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2024 | 3 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Mazars Company Secretaries Limited am 11. Juni 2024 | 1 Seiten | CH04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2023 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2022 | 2 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Mazars Company Secretaries Limited am 26. Apr. 2022 | 1 Seiten | CH04 | ||
Ernennung von Bestrustees Limited als Direktor am 13. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP02 | ||
Beendigung der Bestellung von Alban Actuarial Solutions Limited als Geschäftsführer am 13. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2021 | 2 Seiten | AA | ||
Change of details for Bay Restaurant Group Limited as a person with significant control on 04. Dez. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Porter Tun House 500 Capability Green Luton Bedfordshire LU1 3LS zum 3 Monkspath Hall Road Solihull B90 4SJ am 08. Dez. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2020 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2018 | 3 Seiten | AA | ||
Ernennung von Janet Christine Perry als Direktor am 16. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Alban Actuarial Solutions Limited als Direktor am 31. Mai 2017 | 2 Seiten | AP02 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATTERSON, John Barry | Geschäftsführer | Linnet Lane FY8 4AJ Lytham St Annes 7 Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 2543260009 | ||||||||
PERRY, Janet Christine | Geschäftsführer | Poplar Grove M33 3AX Sale 19 Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 47938640002 | ||||||||
BESTRUSTEES LIMITED | Geschäftsführer | 49-51 Blagrave Street RG1 1PL Reading Aquis House Berkshire United Kingdom |
| 53139550008 | ||||||||||
BEE, John Derek | Sekretär | Hollowforth Mill Cottage Hollowforth Lane Woodplumpton PR4 0BD Preston Lancashire | British | 46464230001 | ||||||||||
COOPER, Andrew James | Sekretär | 9 Grenfell Road M20 6TG Manchester Lancashire | British | Solicitor | 63484760001 | |||||||||
HODDINOTT, Ruth Elizabeth | Sekretär | 12 Waterside House Chandlers Row Worsley M28 2BW Manchester | British | 56095180001 | ||||||||||
INGHAM, Michael Harry Peter | Sekretär | 3 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | Company Secretary | 2739650001 | |||||||||
KAY, Dominic Jude | Sekretär | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | 145920530001 | ||||||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
FORVIS MAZARS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Old Bailey EC4M 7AU London 30 United Kingdom |
| 130398850027 | ||||||||||
NEWHALL NOMINEES LIMITED | Sekretär | 115 Colmore Row B3 3AL Birmingham | 18182520002 | |||||||||||
BEE, John Derek | Geschäftsführer | Westfield Bennethead, Watermillock CA11 0LT Penrith Cumbria | England | British | Company Director | 46464230003 | ||||||||
BROWN, Aaron Maxwell | Geschäftsführer | 11 Carlyle Close N2 0QU London | American | Business Consultant | 98928830001 | |||||||||
BROWN, Stephen John | Geschäftsführer | 17 Mill Road SL7 1PX Marlow Buckinghamshire | England | British | Director | 102228010001 | ||||||||
BUCHANAN, Andrew | Geschäftsführer | 24 Regent Close Birkdale PR8 2EJ Southport Merseyside | British | Director | 127668580001 | |||||||||
DICKSON, Peter Alan | Geschäftsführer | Pointer House Farm Langley Lane Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | British | Company Director | 13332510001 | |||||||||
FOWLER, Stevan Lloyd | Geschäftsführer | The Tower House Kirkless Hall Clifton HD6 4DH Brighouse Yorkshire | British | Finance Director | 88380470001 | |||||||||
GREEN, Jeremy John | Geschäftsführer | Hunters Wood Northwich Road,Cranage CW4 8HL Holmes Chapel Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 2718520003 | ||||||||
HUNTLEY, Perry Melvin | Geschäftsführer | Tithe Farm Close SG18 9NE Langford 24 Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Food | 167650130001 | ||||||||
KEEN, Christian | Geschäftsführer | The Paddock Alverton NG13 9PB Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 117424240001 | ||||||||
MARTIN-BIRD, Christopher Jelf | Geschäftsführer | Clay House Farm Clay Lane Mobberley WA16 7BH Knutsford Cheshire | British | Company Director | 16735350001 | |||||||||
RILEY, Frank David | Geschäftsführer | 38 Beeston Drive CW7 1ER Winsford Cheshire | United Kingdom | British | Retired | 120897580001 | ||||||||
RODDICK, Jacqueline | Geschäftsführer | The Hollies Church End Steppingley MK45 5AU Bedford Bedfordshire | British | Hr Director | 118151060001 | |||||||||
ROWLINSON, Colin | Geschäftsführer | Copt Hill Shaw Alcocks Lane KT20 6BB Kingswood Surrey | British | Chartered Accountant | 77454060001 | |||||||||
SMALLEY, Timothy John | Geschäftsführer | Chivers Road CM15 0LG Stondon Massey Stondon Place Essex | United Kingdom | British | Bank Manager | 102593650002 | ||||||||
SMITH, Vincent Andrew | Geschäftsführer | Apartment 26 The Boatman's Yard 40 City Road East M15 4QF Manchester Lancashire | British | Audio Visual Manager | 106476100001 | |||||||||
SYMONDS, Paul | Geschäftsführer | Willow House 10a Vicars Close, Biddenham MK40 4BG Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 80167420001 | ||||||||
WILLCOCK, Mary Elizabeth | Geschäftsführer | Clifton Road Heaton Moor SK4 4DD Stockport 4 Cheshire | United Kingdom | British | Managing Director | 134904140001 | ||||||||
ALBAN ACTUARIAL SOLUTIONS LIMITED | Geschäftsführer | Abbey Avenue AL3 4BJ St Albans 21 Hertfordshire United Kingdom |
| 233725630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei YATES GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay Restaurant Group Limited | 06. Apr. 2016 | Monkspath Hall Road B90 4SJ Solihull 3 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0