DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED

DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02241896
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Fisher Partners Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HANDYGIFT LIMITED01. März 199401. März 1994
    LONDON AND REGIONAL PROPERTIES LIMITED13. Juni 198913. Juni 1989
    GADE PROPERTIES LIMITED08. Apr. 198808. Apr. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Feb. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Chris Barton am 09. Nov. 2015

    1 SeitenCH03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Aug. 2015

    3 Seiten4.68

    Ernennung von Mr Chris Barton als Sekretär am 05. Jan. 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Marcus Owen Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Aug. 2014

    4 Seiten4.68

    Ernennung von Mr Marcus Owen Shepherd als Sekretär am 01. Sept. 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Helen Maria Ratsey als Sekretär am 01. Sept. 2014

    1 SeitenTM02

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    11 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS* am 03. Sept. 2013

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Weiner als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charles Barwick als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Apr. 2013

    Kapitalaufstellung am 30. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2012

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Charles Julian Barwick am 11. Aug. 2012

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2011 bis 29. Feb. 2012

    3 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Charles Julian Barwick am 29. Sept. 2011

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Sekretär
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    193873580001
    MARX, Michael Henry
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish35019090001
    DEVELOPMENT SECURITIES ESTATES PLC
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer657311
    53858600001
    BUNT, Philip Alan
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    Sekretär
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    British33027500001
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Sekretär
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Sekretär
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    British75831270001
    LIVINGSTONE, Richard John
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    Sekretär
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    British51534890002
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158447900001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190659990001
    BARWICK, Charles Julian
    Campana Road
    SW6 4AT London
    45
    England
    Geschäftsführer
    Campana Road
    SW6 4AT London
    45
    England
    EnglandBritish3818640003
    BODIE, Anthony Ellyah
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    Geschäftsführer
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    British34902790002
    CHEER, Bruce Baxter
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    British66762930001
    CORDEREY, Neil Sinclair
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish74024640001
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Geschäftsführer
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    British75831270001
    LIVINGSTONE, Richard John
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    Geschäftsführer
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    British51534890002
    ROSE, William Marcus Henderson
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    Geschäftsführer
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    United KingdomBritish9127840001
    VAUGHAN, Steven Mark
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    British9092330001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    British4779170001
    WEINER, Matthew Simon
    24 Southway
    NW11 6RU London
    Geschäftsführer
    24 Southway
    NW11 6RU London
    United KingdomBritish72888710002

    Hat DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dted 23 december 1998)
    Erstellt am 18. Feb. 2002
    Geliefert am 07. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 104 camley street, l/b of camden including all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. Fixed charge all moneys from timr to time deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the principal deed. Floating charge the company's property assets rights and revenues, present and future including the unacalled share capital (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment
    Erstellt am 18. Feb. 2002
    Geliefert am 07. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from development securities PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all moneys from time to time owing or incurred to the company under the leases in respect of 104 camley street, london (the lease) other than sums receivable by the company by way of insurance contributions service charge, payments to sinking funds or any vat payable thereon (rents) including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof (the assigned rights). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juli 1995
    Geliefert am 17. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Whilem works, forest road, hainault, l/b of redbridge t/no.EGL7113.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Apr. 1994
    Geliefert am 12. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rents licence fees & other like sums payable under the terms of any lease underlease agreement for lease or tenancy relating to the property k/a whilem works & lorely forest road hainault essex. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 12. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Apr. 1994
    Geliefert am 12. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 12. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Aug. 1993
    Geliefert am 06. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a gaywood house 29 great peter street vlondon t/no 221951 with fixtures & fittings fixed plant & machinery (other than trade).
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Aug. 1993
    Geliefert am 06. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of yearly rents
    Erstellt am 20. Aug. 1993
    Geliefert am 06. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the agreement dated 19/8/93, the assignment or any related security document (as defined in the assignment)
    Kurze Angaben
    All right title & interest in & to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the lease of building k/a gaywood house 29 great peter street london the benefit of any surety or guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Residual floating charge
    Erstellt am 29. Jan. 1993
    Geliefert am 13. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge the whole of the undertaking property and assets of the company.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Jan. 1993
    Geliefert am 13. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 104 camley street london title no NGL474499. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment or rent
    Erstellt am 22. Mai 1992
    Geliefert am 03. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge of even date
    Kurze Angaben
    The benefit of all rents and all other sums payable under a lease together with any arrears existing at the date of this deed.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Mai 1992
    Geliefert am 27. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land & buildings k/a 52 standard rd, acton london t/no agl 12123 with a & goodwill & all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal & floating charge
    Erstellt am 11. Mai 1992
    Geliefert am 16. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,350,000 & all other monies due from the company to the chargee on any account whatsoever & a participation fee in the maximum sum of £54,000 due from the company to the chargee (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    L/H land & building k/a 104 camley st, london t/no ngl 474499 with A. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 1989
    Geliefert am 16. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 52 standard road acton london and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juli 1989
    Geliefert am 13. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a units 1-18 telford close, burnett road norwich & the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 13. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 1989
    Geliefert am 17. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a "loreley", forest road, hainault with fixed plant, machinery (except personal chattels) & the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited.
    Transaktionen
    • 17. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Apr. 1989
    Geliefert am 27. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a whilemworks, forest rd. Haincuilt tno elg 7113 tog with together with, fixed and plant machienry fixtures by way of:. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. März 1989
    Geliefert am 07. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 94 ballords lane london N3. (Title no: mx 468172. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Banks Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 1989
    Geliefert am 03. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    221 camben high street T.N. ln 92414. together with fixed plant machinery & other fixtures. & stocks of building materials goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juli 1988
    Geliefert am 19. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    69 & 71 praed street, london W2 by way of a floating charge. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juli 1988
    Geliefert am 08. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transaktionen
    • 08. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Aug. 2013Beginn der Liquidation
    17. Juni 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas H O'Reilly
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Praktiker
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0