H. WILLIAMS & SONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | H. WILLIAMS & SONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02245096 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von H. WILLIAMS & SONS LIMITED?
- Sammlung von nicht gefährlichen Abfällen (38110) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
- Sammlung von gefährlichen Abfällen (38120) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
- Behandlung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen (38210) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
- Behandlung und Beseitigung von gefährlichen Abfällen (38220) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
Wo befindet sich H. WILLIAMS & SONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Albert Works Kenninghall Road N18 2PD Edmonton London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von H. WILLIAMS & SONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für H. WILLIAMS & SONS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für H. WILLIAMS & SONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lee Peter Simmons als Geschäftsführer am 23. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von George Derek Bond als Geschäftsführer am 05. März 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 45 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
legacy | 15 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2011 bis 30. Apr. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Franklin Rice am 01. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von H. WILLIAMS & SONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE, John Franklin | Sekretär | Albert Works Kenninghall Road N18 2PD Edmonton London | British | 7699640001 | ||||||
| MANN, Gary Samuel | Geschäftsführer | Albert Works Kenninghall Road N18 2PD Edmonton London | United Kingdom | British | 30168220002 | |||||
| RICE, John Franklin | Geschäftsführer | Albert Works Kenninghall Road N18 2PD Edmonton London | United Kingdom | British | 7699640001 | |||||
| SCULLY, Richard Andrew | Geschäftsführer | Albert Works Kenninghall Road N18 2PD Edmonton London | England | British | 63194950001 | |||||
| HUXTABLE, Richard | Sekretär | 38 Newis Crescent Clifton SG17 5HU Shefford Bedfordshire | British | 33606470001 | ||||||
| MANN, Gary Samuel | Sekretär | 9 The Sheilings Emerson Park RM11 2QD Hornchurch Essex | British | 30168220002 | ||||||
| ASHMAN, Herbert Robert | Geschäftsführer | Athlone Hitchin Road SG6 3LT Letchworth Herts | British | 11493260001 | ||||||
| BOND, George Derek | Geschäftsführer | Albert Works Kenninghall Road N18 2PD Edmonton London | United Kingdom | British | 46487300001 | |||||
| PORTER, John David | Geschäftsführer | 4 Whetstone Court AL6 0QY Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | 11493250001 | |||||
| SIMMONS, Lee Peter | Geschäftsführer | Albert Works Kenninghall Road N18 2PD Edmonton London | United Kingdom | British | 95040840001 | |||||
| TOMLINSON, Gavin Malcolm | Geschäftsführer | Brambles Briary Wood End AL6 0TD Welwyn Hertfordshire | England | British | 77645310001 | |||||
| WIDDOWSON, Gary Albert | Geschäftsführer | Bretts Rolls Park IG7 6DJ Chigwell Essex | United Kingdom | British | 18202670001 | |||||
| WILLIAMS, John | Geschäftsführer | Roffen House Tompions End Ickwell Green SG18 9EH Biggleswade Beds | United Kingdom | British | 21321570001 |
Hat H. WILLIAMS & SONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 26. März 2013 Geliefert am 05. Apr. 2013 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 2008 Geliefert am 05. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 18. Okt. 2006 Geliefert am 19. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the chattels being a 6000 hp lynx fragmentiser (s/no 06/81/01) together with any part or parts and all additions the insurance policies and the contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Feb. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 29. Juli 2002 Geliefert am 29. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant machinery and things being 2 x liebherr cranes type A914 s/n's 672 6156 - 672 6282, 1 x liebherr crane type A912 s/n 145 2012, 2 x liebherr cranes type R914 s/n's 640 6730 - 640 8153 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 25. Okt. 1999 Geliefert am 04. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from d m c recycling limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 00313165. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 14. Juli 1999 Geliefert am 14. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben One used 1996 cantium heavy duty 185 x 210 scrap shredder shredder mill serial no 96/003 for further details see ch microfiche. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 11. März 1996 Geliefert am 11. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben One new cantium heavy duty 185 x 210 scrap shredder together with ancillary equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Nov. 1990 Geliefert am 08. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over l/h wallace way, hitchin herts. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 29. Juni 1988 Geliefert am 07. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts and uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0