XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02247736 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?
- Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Walbrook Building 25 Walbrook EC4N 8AQ London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ALBIS ASSOCIATES LIMITED | 25. Apr. 1988 | 25. Apr. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Aug. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Neville Whitaker als Geschäftsführer am 21. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gary Neville Whitaker am 09. Apr. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX* am 07. Apr. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Timothy Llewellyn Croom als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Fussell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gary Neville Whitaker am 01. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROOM, Timothy Llewellyn | Geschäftsführer | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 184906470001 | ||||
CAMPBELL, Kenneth Francis | Sekretär | 9 Cheldon Barton SS1 3TX Thorpe Bay Essex | British | Accountant | 101302400001 | |||||
FUSSELL, Christopher Mark | Sekretär | 2 Acris Street SW18 2QP London | British | 63476510003 | ||||||
GALLAGHER, Anthony James | Sekretär | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | Irish | Solicitor Chartered Secretary | 127048740001 | |||||
LONEY, Nicholas John | Sekretär | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
OWEN, David Ronald | Sekretär | 14 Boulthurst Way Limpsfield RH8 0HU Oxted Surrey | British | 20395210001 | ||||||
SCORE, Timothy | Sekretär | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
TOWN, John Richard | Sekretär | 24 Singer Avenue Jaywick CO15 2LR Clacton On Sea Essex | British | Company Secretary | 60220540002 | |||||
HEXAGON REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Ten Dominion Street EC2M 2EE London | 4004080002 | |||||||
BARBER, John Philip | Geschäftsführer | St Paul's School House Langton Road TN4 8XD Tunbridge Wells Kent | England | English | Corporate Adviser | 113021160001 | ||||
BAUERNFEIND, David Gregory | Geschäftsführer | The Coachouse Bathampton Lane BA2 6SW Bath | United Kingdom | British | Accountant | 99529910001 | ||||
BEARD, Steven Mark | Geschäftsführer | 210 Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood Kent | British | Director | 95763170001 | |||||
BELL, George | Geschäftsführer | Burdon Lane Cheam SM2 7DA Sutton 96 Surrey United Kingdom | England | British | Director | 140717300001 | ||||
BUESNEL, Clive Stephen | Geschäftsführer | Byways Woodland Drive GU10 4SG Farnham Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 78778770002 | ||||
CAMPBELL, Kenneth Francis | Geschäftsführer | 9 Cheldon Barton SS1 3TX Thorpe Bay Essex | British | Accountant | 101302400001 | |||||
DENMAN, Christine | Geschäftsführer | Homemead Farm Woolmongers Lane CM4 0JX Blackmore Ingatestone Essex | British | Administrator | 76852570001 | |||||
DENMAN, Douglas Frederick | Geschäftsführer | Homemead Farm Woolmongers Lane Blackmore CM4 0JX Ingatestone Essex | England | British | Chartered Accountant | 20395230002 | ||||
EDWARDS, Nicholas | Geschäftsführer | 76a Broomwood Road Battersea SW11 6LA London | British | Director | 112441680001 | |||||
FISHER, Darren Michael | Geschäftsführer | 41 Radnor Gardens TW1 4NA Twickenham | United Kingdom | Australian | Finance Director | 82844640002 | ||||
FUSSELL, Christopher Mark | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 1AX London 34 | England | British | Solicitor | 138509190001 | ||||
GOGEL, Robert Neil, Mr. | Geschäftsführer | 16 Av Emile Deschanel FOREIGN Paris 75007 France | France | Us/French | Chief Executive Officer | 151744580001 | ||||
OWEN, David Ronald | Geschäftsführer | 14 Boulthurst Way Limpsfield RH8 0HU Oxted Surrey | British | Company Director | 20395210001 | |||||
PEARCE, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 4 Witham Close Chandlers Ford SO53 4TJ Eastleigh Hampshire | British | Production Director | 117903290001 | |||||
PRESLAND, Peter Eric | Geschäftsführer | Rats Castle Castletons Oak Cranbrook Road TN27 8DY Biddenden Ashford Kent | England | British | Company Director | 7649630002 | ||||
SCORE, Timothy | Geschäftsführer | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | Company Director | 103319060001 | |||||
SUMMERS, Roger Denis | Geschäftsführer | Florins Birchwood Road Cock Clarks CM3 6PR Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Company Director | 8559710002 | ||||
WARD, David Charles | Geschäftsführer | 5 Beadon Road BR2 9AS Bromley | British | Insurance Manager | 80258920001 | |||||
WELFARE, Sandy | Geschäftsführer | 86 Finborough Road Flat 1 Chelsea SW10 9ED London | American | Director | 126158250001 | |||||
WHITAKER, Gary Neville | Geschäftsführer | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | Legal Counsel | 138557390001 |
Hat XCHANGING INSURANCE PROFESSIONAL SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 28. Okt. 2011 Geliefert am 09. Nov. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 february 2007 and | Erstellt am 30. Juli 2007 Geliefert am 17. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement dated 19/02/2007 and | Erstellt am 02. Juli 2007 Geliefert am 05. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 19. Feb. 2007 Geliefert am 23. Feb. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 09. Jan. 2006 Geliefert am 12. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re xchanging insurance professional services limited and numbered 0836864 and any account(s) for the time being re placing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury diviions in the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 15. Sept. 1999 Geliefert am 05. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent for the finance parties (as defined) pursuant to the facilities agreement dated 12TH february 1999 or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent security deed | Erstellt am 03. Juli 1995 Geliefert am 05. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Kurze Angaben £2,500. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. März 1993 Geliefert am 11. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Okt. 1992 Geliefert am 05. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (for full details refer to doc M395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 13. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Kurze Angaben £7,500. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0