LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED

LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLIONSGATE MANAGEMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02247762
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PORTFOLIO ESTATES LIMITED08. Sept. 199708. Sept. 1997
    DUKEMINSTER LIMITED14. Juli 198814. Juli 1988
    VALUEMAJOR PUBLIC LIMITED COMPANY25. Apr. 198825. Apr. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Umregistrierung

    RES02

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175(5)(a) 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    C/O Reit Asset Management
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    C/O Reit Asset Management
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICES LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135401070001
    IVES, Stephen Edward
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    Sekretär
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    British50173270002
    JACOBS, Adrian Mark
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    Sekretär
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    British59392140001
    SAMUELS, Adam Bernard Andrew
    49 Plymouth Wharf
    Isle Of Dogs
    E14 3EL London
    Sekretär
    49 Plymouth Wharf
    Isle Of Dogs
    E14 3EL London
    British9202270001
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Sekretär
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    AARONSON, Glenn Hunter
    Little Stone House Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Stone House Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haslemere
    Surrey
    Us Citizen61193890001
    BENJAMIN, William Stephen
    44 Campden Hill Square
    Holland Park
    W8 7JR London
    Geschäftsführer
    44 Campden Hill Square
    Holland Park
    W8 7JR London
    United KingdomBritish71600980002
    BINNINGTON, Timothy John
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritish4831260001
    BLENKO, Don Balman
    27 Burlington Gardens
    W4 4LT London
    Geschäftsführer
    27 Burlington Gardens
    W4 4LT London
    UsaUk Us45456900001
    FALLS, Robert Richard William
    28b Chalcot Road
    Primrose Hill
    NW1 8LN London
    Geschäftsführer
    28b Chalcot Road
    Primrose Hill
    NW1 8LN London
    British16501250004
    IVES, Stephen Edward
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish50173270002
    KHALASTCHI, Ephraim Menashi Frank
    Flat 65 Waterside Point
    2 Anhalt Road
    SW11 4PD London
    Geschäftsführer
    Flat 65 Waterside Point
    2 Anhalt Road
    SW11 4PD London
    EnglandBritish56359120001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Geschäftsführer
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    NASH, Jeffrey Frederick
    The Coach House St Matthews Road
    Ealing
    W5 3JT London
    Geschäftsführer
    The Coach House St Matthews Road
    Ealing
    W5 3JT London
    United KingdomBritish53992520001
    NEWMAN, Graeme Phillip
    Magpies Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Magpies Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    British4831270001
    ORF, Roger Gerard
    Pelham Crescent
    SW7 2NP London
    1
    Geschäftsführer
    Pelham Crescent
    SW7 2NP London
    1
    United KingdomBritish38079110001
    PASHLEY, Michael
    31 Saint Michaels Road
    MK40 2LZ Bedford
    Geschäftsführer
    31 Saint Michaels Road
    MK40 2LZ Bedford
    British77493420001
    PATRICK, Christopher John
    12 Fitzroy Crescent
    Chiswick Place
    W4 3EL London
    Geschäftsführer
    12 Fitzroy Crescent
    Chiswick Place
    W4 3EL London
    Usa48804210001
    PERHIA, Naomi
    10 Mortimer Road
    Ealing
    W5 London
    Geschäftsführer
    10 Mortimer Road
    Ealing
    W5 London
    British19820830001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Geschäftsführer
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SHOHET, Edward
    77 Bryanston Court (No 2)
    137 George Street
    W1H 7AD London
    Geschäftsführer
    77 Bryanston Court (No 2)
    137 George Street
    W1H 7AD London
    Italian35535690002
    SHOHET, Meir Miro
    Goya 47
    Madrid
    28001
    Spain
    Geschäftsführer
    Goya 47
    Madrid
    28001
    Spain
    SpainBritish96891340001
    SHOHET, Saleh Haron
    Flat J Upper Fielde
    71 Park Street
    W1Y 3HB London
    Geschäftsführer
    Flat J Upper Fielde
    71 Park Street
    W1Y 3HB London
    EnglandBritish17408410003
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of legal charge
    Erstellt am 22. März 2000
    Geliefert am 25. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from any group member (as defined ) to norwich union mortgage finance limited (the "trustee") or any lender (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Surrey house and department store,high street,throwley road and throwley way,sutton t/no.sgl 192010.fixed charge all moneys from time to time deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 of the deed.floating charge such of its undertaking which is not otherwise charged pursuant to clauses 3.1(a),3.1(b) or 3.2 of the deed.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 15. Nov. 1999
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land lying on the north-east side of dunstable road luton t/n BD90802.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Supplemental deed
    Erstellt am 20. Juni 1999
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    F/H property k/a wedge house 799 london road croydon t/n SGL15383. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Supplemental deed
    Erstellt am 22. Dez. 1998
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 95 kilburn high road l/b of camden t/n 346021. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 1997
    Geliefert am 23. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property situate at and k/a land on the east side of london road peterborough t/n CB168963 all rents and other income.
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank Limited
    Transaktionen
    • 23. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 27. Juni 1997
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 10. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (I) f/hold property known as 100-102 uxbridge rd,hammersmith; t/no NGL421539 and described as wellington public house and 96-102 uxbridge rd,london W.12; (ii) f/hold property known as 39/41 high street and 56/60 calthorpe st,banbury; ON186122; (iii) f/hold land lying to the west of calthorpe st,banbury; ON190050; all buildings,fixtures plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Supplemental deed
    Erstellt am 27. Juni 1997
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    F/H property k/a castle house 37-45 (odd) paul street l/b of islington t/n NGL488502.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Floating charge
    Erstellt am 26. Mai 1997
    Geliefert am 06. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 03. Feb. 1997
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a 89,91,93,95 and 97 london street and 56 58 and 60 east street reading t/n BK762118. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Supplemental deed
    Erstellt am 03. Feb. 1997
    Geliefert am 12. Feb. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and indebtedness due from the company,turnshire limited and chaselands limited and any other group member (as defined) to the chargee as trustee for itself and the other lenders and to any other lenders supplemental to the legal charge dated 23RD december 1996
    Kurze Angaben
    89 91 93 95 & 97 london street and 56,58 & 60 east street reading title number BK76218 with all buildings erections and fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed of legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 14. Jan. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £10,000,000 due or to become due from the company to the chargee secured by the loan agreement dated 31ST december 1996
    Kurze Angaben
    All sums from time to time standing to the credit of the borrowers account open or to be opened in the lenders books entitle norwich union mortgage finance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1996
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    F/H property k/a bakery house 27/29 buckingham street and rycote house 23/25 buckingham street aylesbury in the county of buckinghamshire t/n BM204069 and bm 192803. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the company,chaselands limited,soundmen limited and any other group member (as defined) to the chargee as agent for itself and others and to any lenders (as defined) on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 to 26 rushbottom lane great tarpots south byfleet essex t/n EX498562 with all buildingg fixtures and fittings and by way of floating charge all property assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security
    Erstellt am 22. Dez. 1995
    Geliefert am 23. Dez. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Seafield road inverness.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 1995
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the east of dragon lane gilesgate moor durham in the county of durham t/n DU86462. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Deed of agreement
    Erstellt am 20. Dez. 1995
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £8,010,000
    Kurze Angaben
    Land on the north side of winterstone road weston super mare t/n AV247071.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Deed of legal charge and mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 1995
    Erworben am 22. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the north ide of stanley road whitefield bury greater manchester k/a safeway supermarket bury t/n LA313417 f/h land and buildings lying to the south of elms street whitefield bury greater manchester t/n GM26271. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung eines Erwerbs (400)
    Deed of legal charge and mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 1995
    Geliefert am 09. Jan. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge and mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 1995
    Geliefert am 05. Jan. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the north east of sealand road chester cheshire t/n CH233052 and f/h land lying to the north of sealand road chester cheshire t/n CH96799 (and other properties as defined), the benefit of an environmental consultants deed of warranty dated 20/12/94, floating charge the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH may 1996
    Erstellt am 19. Dez. 1995
    Geliefert am 24. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Seafield road inverness.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 24. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15TH may 1996
    Erstellt am 19. Dez. 1995
    Geliefert am 17. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    107 kelvinhaugh street glasgow.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15TH may 1996
    Erstellt am 19. Dez. 1995
    Geliefert am 17. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    107 kelvinhaugh street glasgow.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 17. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 6TH january 1996
    Erstellt am 19. Dez. 1995
    Geliefert am 26. Jan. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    1.03 acres at seafield road inverness.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security presented for registration in scotland
    Erstellt am 19. Dez. 1995
    Geliefert am 23. Dez. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Strathmartine road,dundee.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for reguistration in scotland on the 22ND december 1995
    Erstellt am 19. Dez. 1995
    Geliefert am 23. Dez. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Slateford road edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0