LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02247762 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PORTFOLIO ESTATES LIMITED | 08. Sept. 1997 | 08. Sept. 1997 |
| DUKEMINSTER LIMITED | 14. Juli 1988 | 14. Juli 1988 |
| VALUEMAJOR PUBLIC LIMITED COMPANY | 25. Apr. 1988 | 25. Apr. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||||||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 652a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | C/O Reit Asset Management 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 79571870001 | |||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||
| TRAFALGAR OFFICES LIMITED | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor 5 | 135401070001 | |||||||
| IVES, Stephen Edward | Sekretär | Cottars St Leonards Hill SL4 4AL Windsor Berkshire | British | 50173270002 | ||||||
| JACOBS, Adrian Mark | Sekretär | 13 Beaufort Gardens Hendon NW4 3QN London | British | 59392140001 | ||||||
| SAMUELS, Adam Bernard Andrew | Sekretär | 49 Plymouth Wharf Isle Of Dogs E14 3EL London | British | 9202270001 | ||||||
| T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | 64631620001 | |||||||
| AARONSON, Glenn Hunter | Geschäftsführer | Little Stone House Bell Vale Lane GU27 3DJ Haslemere Surrey | Us Citizen | 61193890001 | ||||||
| BENJAMIN, William Stephen | Geschäftsführer | 44 Campden Hill Square Holland Park W8 7JR London | United Kingdom | British | 71600980002 | |||||
| BINNINGTON, Timothy John | Geschäftsführer | Thakeham Place Thakeham RH20 3EP Pulborough West Sussex | England | British | 4831260001 | |||||
| BLENKO, Don Balman | Geschäftsführer | 27 Burlington Gardens W4 4LT London | Usa | Uk Us | 45456900001 | |||||
| FALLS, Robert Richard William | Geschäftsführer | 28b Chalcot Road Primrose Hill NW1 8LN London | British | 16501250004 | ||||||
| IVES, Stephen Edward | Geschäftsführer | Cottars St Leonards Hill SL4 4AL Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 50173270002 | |||||
| KHALASTCHI, Ephraim Menashi Frank | Geschäftsführer | Flat 65 Waterside Point 2 Anhalt Road SW11 4PD London | England | British | 56359120001 | |||||
| MCGRATH, Kevin David | Geschäftsführer | 19 Elm Avenue W5 3XA London | England | British | 83872490002 | |||||
| NASH, Jeffrey Frederick | Geschäftsführer | The Coach House St Matthews Road Ealing W5 3JT London | United Kingdom | British | 53992520001 | |||||
| NEWMAN, Graeme Phillip | Geschäftsführer | Magpies Lynx Hill East Horsley KT24 5AX Leatherhead Surrey | British | 4831270001 | ||||||
| ORF, Roger Gerard | Geschäftsführer | Pelham Crescent SW7 2NP London 1 | United Kingdom | British | 38079110001 | |||||
| PASHLEY, Michael | Geschäftsführer | 31 Saint Michaels Road MK40 2LZ Bedford | British | 77493420001 | ||||||
| PATRICK, Christopher John | Geschäftsführer | 12 Fitzroy Crescent Chiswick Place W4 3EL London | Usa | 48804210001 | ||||||
| PERHIA, Naomi | Geschäftsführer | 10 Mortimer Road Ealing W5 London | British | 19820830001 | ||||||
| SHEPPARD, Martin Paul | Geschäftsführer | 53 Etchingham Park Road N3 2EB London | United Kingdom | British | 127658820001 | |||||
| SHOHET, Edward | Geschäftsführer | 77 Bryanston Court (No 2) 137 George Street W1H 7AD London | Italian | 35535690002 | ||||||
| SHOHET, Meir Miro | Geschäftsführer | Goya 47 Madrid 28001 Spain | Spain | British | 96891340001 | |||||
| SHOHET, Saleh Haron | Geschäftsführer | Flat J Upper Fielde 71 Park Street W1Y 3HB London | England | British | 17408410003 | |||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of legal charge | Erstellt am 22. März 2000 Geliefert am 25. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities due or to become due from any group member (as defined ) to norwich union mortgage finance limited (the "trustee") or any lender (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Surrey house and department store,high street,throwley road and throwley way,sutton t/no.sgl 192010.fixed charge all moneys from time to time deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 of the deed.floating charge such of its undertaking which is not otherwise charged pursuant to clauses 3.1(a),3.1(b) or 3.2 of the deed.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 15. Nov. 1999 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben F/H property k/a land lying on the north-east side of dunstable road luton t/n BD90802. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 20. Juni 1999 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben F/H property k/a wedge house 799 london road croydon t/n SGL15383. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 22. Dez. 1998 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben F/H property k/a 95 kilburn high road l/b of camden t/n 346021. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Juli 1997 Geliefert am 23. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property situate at and k/a land on the east side of london road peterborough t/n CB168963 all rents and other income. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 27. Juni 1997 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 10. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (I) f/hold property known as 100-102 uxbridge rd,hammersmith; t/no NGL421539 and described as wellington public house and 96-102 uxbridge rd,london W.12; (ii) f/hold property known as 39/41 high street and 56/60 calthorpe st,banbury; ON186122; (iii) f/hold land lying to the west of calthorpe st,banbury; ON190050; all buildings,fixtures plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 27. Juni 1997 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben F/H property k/a castle house 37-45 (odd) paul street l/b of islington t/n NGL488502. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 26. Mai 1997 Geliefert am 06. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 03. Feb. 1997 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/a 89,91,93,95 and 97 london street and 56 58 and 60 east street reading t/n BK762118. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 12. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies and indebtedness due from the company,turnshire limited and chaselands limited and any other group member (as defined) to the chargee as trustee for itself and the other lenders and to any other lenders supplemental to the legal charge dated 23RD december 1996 | |
Kurze Angaben 89 91 93 95 & 97 london street and 56,58 & 60 east street reading title number BK76218 with all buildings erections and fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of legal charge | Erstellt am 31. Dez. 1996 Geliefert am 14. Jan. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £10,000,000 due or to become due from the company to the chargee secured by the loan agreement dated 31ST december 1996 | |
Kurze Angaben All sums from time to time standing to the credit of the borrowers account open or to be opened in the lenders books entitle norwich union mortgage finance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 23. Dez. 1996 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben F/H property k/a bakery house 27/29 buckingham street and rycote house 23/25 buckingham street aylesbury in the county of buckinghamshire t/n BM204069 and bm 192803. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 23. Dez. 1996 Geliefert am 07. Jan. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the company,chaselands limited,soundmen limited and any other group member (as defined) to the chargee as agent for itself and others and to any lenders (as defined) on any account whatsoever and in any manner whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 2 to 26 rushbottom lane great tarpots south byfleet essex t/n EX498562 with all buildingg fixtures and fittings and by way of floating charge all property assets and rights of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 22. Dez. 1995 Geliefert am 23. Dez. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Seafield road inverness. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1995 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben F/H land lying to the east of dragon lane gilesgate moor durham in the county of durham t/n DU86462. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of agreement | Erstellt am 20. Dez. 1995 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £8,010,000 | |
Kurze Angaben Land on the north side of winterstone road weston super mare t/n AV247071. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge and mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1995 Erworben am 22. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the north ide of stanley road whitefield bury greater manchester k/a safeway supermarket bury t/n LA313417 f/h land and buildings lying to the south of elms street whitefield bury greater manchester t/n GM26271. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge and mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1995 Geliefert am 09. Jan. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge and mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1995 Geliefert am 05. Jan. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land lying to the north east of sealand road chester cheshire t/n CH233052 and f/h land lying to the north of sealand road chester cheshire t/n CH96799 (and other properties as defined), the benefit of an environmental consultants deed of warranty dated 20/12/94, floating charge the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH may 1996 | Erstellt am 19. Dez. 1995 Geliefert am 24. Mai 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Seafield road inverness. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 15TH may 1996 | Erstellt am 19. Dez. 1995 Geliefert am 17. Mai 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 107 kelvinhaugh street glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 15TH may 1996 | Erstellt am 19. Dez. 1995 Geliefert am 17. Mai 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 107 kelvinhaugh street glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 6TH january 1996 | Erstellt am 19. Dez. 1995 Geliefert am 26. Jan. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 1.03 acres at seafield road inverness. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland | Erstellt am 19. Dez. 1995 Geliefert am 23. Dez. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Strathmartine road,dundee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for reguistration in scotland on the 22ND december 1995 | Erstellt am 19. Dez. 1995 Geliefert am 23. Dez. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Slateford road edinburgh. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0