CORBY TC LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCORBY TC LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02248576
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CORBY TC LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CORBY TC LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Sloane Square
    SW1W 8ER London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CORBY TC LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HELICAL (CORBY) LIMITED15. Nov. 201115. Nov. 2011
    TOPS SHOP PRECINCTS LIMITED20. Mai 198820. Mai 1988
    MONORARE LIMITED27. Apr. 198827. Apr. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CORBY TC LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2015
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2015
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für CORBY TC LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Nov. 2015

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Pricewaterhouse Coopers Llp 7 More London Riverside London SE1 2RT United Kingdom zum 15 Sloane Square London SW1W 8ER am 02. Juni 2015

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Hanover Square London W1S 1HQ zum Pricewaterhouse Coopers Llp 7 More London Riverside London SE1 2RT am 13. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Hugo Marcus Vernon Black als Direktor am 16. März 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Justin Bhalla als Sekretär am 16. März 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Duncan Charles Eades Walker als Geschäftsführer am 16. März 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Eric Slade als Geschäftsführer am 16. März 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Helical Registrars Limited als Sekretär am 16. März 2015

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von John Charles Inwood als Geschäftsführer am 16. März 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Philip Palmer Anderson als Geschäftsführer am 16. März 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy John Murphy als Geschäftsführer am 16. März 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Robert David Criag Sim als Direktor am 16. März 2015

    2 SeitenAP01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 27. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Helical Registrars Limited am 26. Aug. 2014

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 11-15 Farm Street London W1J 5RS zum 5 Hanover Square London W1S 1HQ am 28. Aug. 2014

    1 SeitenAD01

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung 24

    2 SeitenMR05

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung 24

    2 SeitenMR05

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung 24

    2 SeitenMR05

    Wer sind die Geschäftsführer von CORBY TC LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BHALLA, Justin
    15 Sloane Square
    SW1W 8ER London
    Europa Capital Partners Llp
    United Kingdom
    Sekretär
    15 Sloane Square
    SW1W 8ER London
    Europa Capital Partners Llp
    United Kingdom
    196676720001
    BLACK, Hugo Marcus Vernon
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    Geschäftsführer
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    United KingdomBritish179500420001
    SIM, Robert David Craig
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    Geschäftsführer
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    EnglandBritish153901920001
    COHEN, Adam Hayden
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    Sekretär
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    British205044390001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Sekretär
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    HELICAL REGISTRARS LIMITED
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Sekretär
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04701446
    89869830001
    LS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4365193
    159674790001
    AKERS, Richard John
    Shepherds Down
    Hill Road
    GU27 2NH Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Shepherds Down
    Hill Road
    GU27 2NH Haslemere
    Surrey
    United KingdomEnglish73246590001
    ANDERSON, Thomas Philip Palmer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritish160720640002
    COHEN, Adam Hayden
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish205044390001
    DESSON, Ernest Vincent
    Meadows
    Rickmans Lane
    RH14 0NT Plaistow
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Meadows
    Rickmans Lane
    RH14 0NT Plaistow
    West Sussex
    British14948630001
    GARROD, Douglas Victor
    Westmorland House
    Station Road
    RG17 9UP Kintbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Westmorland House
    Station Road
    RG17 9UP Kintbury
    Berkshire
    EnglandBritish104783210001
    GILL, Christopher Marshall
    Church Street
    KT17 4QA Epsom
    63
    Surrey
    Geschäftsführer
    Church Street
    KT17 4QA Epsom
    63
    Surrey
    United KingdomBritish133825020001
    GOODMAN, Everard Nicholas
    5 Bryanston Court
    W1H 7HA London
    Geschäftsführer
    5 Bryanston Court
    W1H 7HA London
    United KingdomBritish3080770001
    INWOOD, John Charles
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritish56398550002
    LAYCOCK, Anthony Ernest
    One Shoreham Lane
    TN13 3DT Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    One Shoreham Lane
    TN13 3DT Sevenoaks
    Kent
    British35572520001
    LEVY, Jonathan Adrian
    2 St Marks Road
    TW11 9DD Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 St Marks Road
    TW11 9DD Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritish124364140001
    MCNAIR SCOTT, Nigel Guthrie
    Farm Street
    W1J 5RS London
    11-15
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Farm Street
    W1J 5RS London
    11-15
    United Kingdom
    EnglandBritish6065190002
    MURPHY, Timothy John
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritish40547240005
    PATTESON-KNIGHT, Richard Julian
    Gadbrook House
    Gadbrook Road
    RH3 7AH Betchworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Gadbrook House
    Gadbrook Road
    RH3 7AH Betchworth
    Surrey
    EnglandBritish55013110001
    SHARPE, Darren John
    192 Noak Hill Road
    CM12 9UX Billericay
    Essex
    Geschäftsführer
    192 Noak Hill Road
    CM12 9UX Billericay
    Essex
    United KingdomBritish30525300003
    SLADE, Michael Eric
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritish38913980001
    SMITH, Roger Peter
    Bramble Lodge
    Saunders Copse
    GU22 0NS Mayford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bramble Lodge
    Saunders Copse
    GU22 0NS Mayford
    Surrey
    British40397900001
    WALKER, Duncan Charles Eades
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritish129346360008
    WOOD, Martin Reay, Mr.
    Kingsdale Road
    HP4 3BS Berkhamsted
    Weavers
    Herts
    Geschäftsführer
    Kingsdale Road
    HP4 3BS Berkhamsted
    Weavers
    Herts
    EnglandBritish89486930002
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Geschäftsführer
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    74974580001
    LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Geschäftsführer
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    100069790001

    Hat CORBY TC LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2012
    Geliefert am 10. Feb. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Okt. 2013Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 23. Okt. 2013Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 23. Okt. 2013Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 23. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Okt. 2011
    Geliefert am 25. Okt. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Okt. 2013Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 18. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Mai 2009
    Geliefert am 13. Mai 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    City exchange 11 albion street leeds t/no WYK880421 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Sept. 2008
    Geliefert am 25. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the west of elizabeth street corby t/no 163390,two parcels of land and buildings on the west side of elizabeth street corby t/no NN128983,land and buidlings in spencer court corby t/no NN150323 (for further details of property charged please refer to form 395) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (As "Obligor Security Trustee")
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Obligor accession deed
    Erstellt am 23. Sept. 2008
    Geliefert am 25. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge any real property,all plant,machinery and other chattels,the obligor accounts,all ahres held by it and all dividends see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (As "Obligor Security Trustee")
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Socttish assignation in security
    Erstellt am 24. März 2000
    Geliefert am 13. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whatsoever of each obligor to the chargee as agent and trustee for the finance parties and to any finance party under each finance document
    Kurze Angaben
    All right title interest and benefit in the ent collection account together with all balances standing to the credit thereof for full details please refer to form 395.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 24. März 2000
    Geliefert am 03. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All assets and moneys over the property (as defined) and benefits in respect of insurances; all book/other debts and licences,consents,rights under any agreement; all rental income.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank,London Branch Asagent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 29. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 01. März 1999
    Geliefert am 03. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the principal of and interest on £75,000,000 in nominal amount of 10 1/4 per cent first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 19TH may 1986 and three supplemental trust deeds dated 30TH march 1987, 22ND february 1989 and 7TH april 1992 respectively
    Kurze Angaben
    F/H 26 to 34 (even numbers) albion street leeds t/n-WYK156991. L/h being a storeroom forming part of trinity street arcade albion street leeds t/n-WYK285921.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 03. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 1998
    Geliefert am 13. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at victoria gardens shopping centre harrogate north yorkshire t/nos: NYK20654 and NYK202690. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 16. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal and interest on £75,000,000 in nominal amount of 10 1/4% first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other monies secured by the trust deeds (as therein defined) due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings k/a 38-40 queens square corby northamptonshire t/n NN178555 and the f/h land an buildings k/a 41-44 queens square, 47 and 48 market walk, 9,10 and 11 the links and chisholm house (including the entrance thereof at groud level) corby northamptonshire t/n's NN178568, NN178555 and NN128983.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited(As Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge (third party)
    Erstellt am 28. Juni 1996
    Geliefert am 10. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or tops estates PLC to the chargee under the loan agreement (as defined), the legal charge or the security documents
    Kurze Angaben
    All that f/h land k/a spencer court mall corby t/no.NN150323 and all that f/h land k/a new post office square corby t/nos.NN150320 and NN157416 and all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 1995
    Geliefert am 10. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the bamber bridge shopping centre, preston t/nos. LA701840 and LA706485 and f/h property k/a 51 warrington street, ashton-under-lyne t/no. GM644617.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 1994
    Geliefert am 25. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    38, 39 & 40 queens square, 29, 30 & 31 market walk, queens square and 32 queens square, 41-46 (incl.) queens square, 47 & 48 market walk, 9, 10 & 11 the links and chisholm house, queens square, 1-5 (incl.) and 6/7 the links, corby, northamptonshire, being part of the land comprised in t/no. NN128983.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 1994
    Geliefert am 25. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Deene house, market square, corby, northamptonshire t/no. NN145263.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Juli 1994
    Geliefert am 20. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the bond street centre k/a land and buildings on the south side of bond street and west side of albion street, leeds t/no. YWE70082 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 1994
    Geliefert am 30. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 1994
    Geliefert am 18. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ashton-under-lyne shopping centre, tameside, greater manchester.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over rental income
    Erstellt am 06. Juli 1993
    Geliefert am 07. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the hongkong and shanghai banking corporation limited as agent for itself and the beneficiaries under the terms of any security document (as defined) and this charge.
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all monies now or hereafter standing in the credit of : the rental income account being three accounts of the company with midland bank PLC london property & construction area office 3RD floor 117 great portland street london wia 4UY sort code 40-05-22 bearing account numbers: current account 31148613:money master account:31148605 money market account:un-numbered.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries.
    Transaktionen
    • 07. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1993
    Geliefert am 01. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the hongkong and shanghai banking corporation limited, as agent for itself and the beneficiaries under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a 26 and 27 new post office square, corby, n orthamptonshire - title no. NN150320, (see ch microfiche for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 01. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 26. Feb. 1993
    Geliefert am 01. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the chargee under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all monies standing to the credit of the rental income account being an account with the agent bearing account no. 074-000449-151 and the property sales accouont being an account of the company with the agent bearing account no. 74-000449-152 (see ch microfiche for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 01. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over construction contract
    Erstellt am 26. Feb. 1993
    Geliefert am 01. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the chargee as agent for itself and the beneficiaries under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge
    Kurze Angaben
    All the company's present and future rights title and interest in and to the construction contract dated 14/10/91 for the construction of a shell and core retail units blocks a and b at st andrew market square, corby, northamptonshire to be carried out by the contractor together with any bond issued pursuant thereto (see ch microfiche for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 01. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third supplemental trust deed
    Erstellt am 09. Apr. 1992
    Geliefert am 14. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000,000 10 1/4% first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other moneys due or to become due to the chargee (the trustees of the said stock) under the deeds constituting and securing the said stock
    Kurze Angaben
    F/H land on the north and west side of longcauseway dewsbury kirklees west yorkshire t/n wyk 157919 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juli 1989
    Geliefert am 01. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Corby town centre, northamptonshire together with the fixed plant machinery & other fixtuers. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    Second supplemental trust deed
    Erstellt am 22. Feb. 1989
    Geliefert am 28. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    50,000,000 10 1/4 % first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and interest thereon and all other moneys intended to be secured by the deeds as defined.
    Kurze Angaben
    F/H land on the north and west side of longcauneway dewsbury. Kirklees, west yorkshire title no wyk 157919 freehold land lying to the west of longcauneway dewsbury aforesaid. Title no wyk 243684 with bldgs, fixtures etc.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 13. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CORBY TC LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Nov. 2015Beginn der Liquidation
    17. Apr. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0