CORBY TC LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CORBY TC LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02248576 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CORBY TC LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CORBY TC LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Sloane Square SW1W 8ER London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CORBY TC LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HELICAL (CORBY) LIMITED | 15. Nov. 2011 | 15. Nov. 2011 |
| TOPS SHOP PRECINCTS LIMITED | 20. Mai 1988 | 20. Mai 1988 |
| MONORARE LIMITED | 27. Apr. 1988 | 27. Apr. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CORBY TC LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2015 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2015 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CORBY TC LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Pricewaterhouse Coopers Llp 7 More London Riverside London SE1 2RT United Kingdom zum 15 Sloane Square London SW1W 8ER am 02. Juni 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Hanover Square London W1S 1HQ zum Pricewaterhouse Coopers Llp 7 More London Riverside London SE1 2RT am 13. Apr. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Hugo Marcus Vernon Black als Direktor am 16. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Justin Bhalla als Sekretär am 16. März 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Duncan Charles Eades Walker als Geschäftsführer am 16. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Eric Slade als Geschäftsführer am 16. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helical Registrars Limited als Sekretär am 16. März 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Charles Inwood als Geschäftsführer am 16. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Philip Palmer Anderson als Geschäftsführer am 16. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy John Murphy als Geschäftsführer am 16. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert David Criag Sim als Direktor am 16. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 24 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Helical Registrars Limited am 26. Aug. 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 11-15 Farm Street London W1J 5RS zum 5 Hanover Square London W1S 1HQ am 28. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung 24 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung 24 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens ist nicht mehr Teil der Belastung 24 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CORBY TC LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALLA, Justin | Sekretär | 15 Sloane Square SW1W 8ER London Europa Capital Partners Llp United Kingdom | 196676720001 | |||||||||||
| BLACK, Hugo Marcus Vernon | Geschäftsführer | Sloane Square SW1W 8ER London 15 England | United Kingdom | British | 179500420001 | |||||||||
| SIM, Robert David Craig | Geschäftsführer | Sloane Square SW1W 8ER London 15 England | England | British | 153901920001 | |||||||||
| COHEN, Adam Hayden | Sekretär | Baram 64 Galley Lane EN5 4AL Arkley Hertfordshire | British | 205044390001 | ||||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Sekretär | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
| HELICAL REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England |
| 89869830001 | ||||||||||
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
| AKERS, Richard John | Geschäftsführer | Shepherds Down Hill Road GU27 2NH Haslemere Surrey | United Kingdom | English | 73246590001 | |||||||||
| ANDERSON, Thomas Philip Palmer | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United Kingdom | British | 160720640002 | |||||||||
| COHEN, Adam Hayden | Geschäftsführer | Baram 64 Galley Lane EN5 4AL Arkley Hertfordshire | United Kingdom | British | 205044390001 | |||||||||
| DESSON, Ernest Vincent | Geschäftsführer | Meadows Rickmans Lane RH14 0NT Plaistow West Sussex | British | 14948630001 | ||||||||||
| GARROD, Douglas Victor | Geschäftsführer | Westmorland House Station Road RG17 9UP Kintbury Berkshire | England | British | 104783210001 | |||||||||
| GILL, Christopher Marshall | Geschäftsführer | Church Street KT17 4QA Epsom 63 Surrey | United Kingdom | British | 133825020001 | |||||||||
| GOODMAN, Everard Nicholas | Geschäftsführer | 5 Bryanston Court W1H 7HA London | United Kingdom | British | 3080770001 | |||||||||
| INWOOD, John Charles | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United Kingdom | British | 56398550002 | |||||||||
| LAYCOCK, Anthony Ernest | Geschäftsführer | One Shoreham Lane TN13 3DT Sevenoaks Kent | British | 35572520001 | ||||||||||
| LEVY, Jonathan Adrian | Geschäftsführer | 2 St Marks Road TW11 9DD Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 124364140001 | |||||||||
| MCNAIR SCOTT, Nigel Guthrie | Geschäftsführer | Farm Street W1J 5RS London 11-15 United Kingdom | England | British | 6065190002 | |||||||||
| MURPHY, Timothy John | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | 40547240005 | |||||||||
| PATTESON-KNIGHT, Richard Julian | Geschäftsführer | Gadbrook House Gadbrook Road RH3 7AH Betchworth Surrey | England | British | 55013110001 | |||||||||
| SHARPE, Darren John | Geschäftsführer | 192 Noak Hill Road CM12 9UX Billericay Essex | United Kingdom | British | 30525300003 | |||||||||
| SLADE, Michael Eric | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | 38913980001 | |||||||||
| SMITH, Roger Peter | Geschäftsführer | Bramble Lodge Saunders Copse GU22 0NS Mayford Surrey | British | 40397900001 | ||||||||||
| WALKER, Duncan Charles Eades | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | 129346360008 | |||||||||
| WOOD, Martin Reay, Mr. | Geschäftsführer | Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Weavers Herts | England | British | 89486930002 | |||||||||
| LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 5 Strand WC2N 5AF London | 74974580001 | |||||||||||
| LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Geschäftsführer | 5 Strand WC2N 5AF London | 100069790001 |
Hat CORBY TC LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Feb. 2012 Geliefert am 10. Feb. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Okt. 2011 Geliefert am 25. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 08. Mai 2009 Geliefert am 13. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben City exchange 11 albion street leeds t/no WYK880421 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. Sept. 2008 Geliefert am 25. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the west of elizabeth street corby t/no 163390,two parcels of land and buildings on the west side of elizabeth street corby t/no NN128983,land and buidlings in spencer court corby t/no NN150323 (for further details of property charged please refer to form 395) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Obligor accession deed | Erstellt am 23. Sept. 2008 Geliefert am 25. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge any real property,all plant,machinery and other chattels,the obligor accounts,all ahres held by it and all dividends see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Socttish assignation in security | Erstellt am 24. März 2000 Geliefert am 13. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whatsoever of each obligor to the chargee as agent and trustee for the finance parties and to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben All right title interest and benefit in the ent collection account together with all balances standing to the credit thereof for full details please refer to form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 24. März 2000 Geliefert am 03. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All assets and moneys over the property (as defined) and benefits in respect of insurances; all book/other debts and licences,consents,rights under any agreement; all rental income.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 01. März 1999 Geliefert am 03. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee the principal of and interest on £75,000,000 in nominal amount of 10 1/4 per cent first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 19TH may 1986 and three supplemental trust deeds dated 30TH march 1987, 22ND february 1989 and 7TH april 1992 respectively | |
Kurze Angaben F/H 26 to 34 (even numbers) albion street leeds t/n-WYK156991. L/h being a storeroom forming part of trinity street arcade albion street leeds t/n-WYK285921. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Mai 1998 Geliefert am 13. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property at victoria gardens shopping centre harrogate north yorkshire t/nos: NYK20654 and NYK202690. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1996 Geliefert am 16. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal and interest on £75,000,000 in nominal amount of 10 1/4% first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other monies secured by the trust deeds (as therein defined) due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land and buildings k/a 38-40 queens square corby northamptonshire t/n NN178555 and the f/h land an buildings k/a 41-44 queens square, 47 and 48 market walk, 9,10 and 11 the links and chisholm house (including the entrance thereof at groud level) corby northamptonshire t/n's NN178568, NN178555 and NN128983. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge (third party) | Erstellt am 28. Juni 1996 Geliefert am 10. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or tops estates PLC to the chargee under the loan agreement (as defined), the legal charge or the security documents | |
Kurze Angaben All that f/h land k/a spencer court mall corby t/no.NN150323 and all that f/h land k/a new post office square corby t/nos.NN150320 and NN157416 and all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Jan. 1995 Geliefert am 10. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the bamber bridge shopping centre, preston t/nos. LA701840 and LA706485 and f/h property k/a 51 warrington street, ashton-under-lyne t/no. GM644617. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Okt. 1994 Geliefert am 25. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 38, 39 & 40 queens square, 29, 30 & 31 market walk, queens square and 32 queens square, 41-46 (incl.) queens square, 47 & 48 market walk, 9, 10 & 11 the links and chisholm house, queens square, 1-5 (incl.) and 6/7 the links, corby, northamptonshire, being part of the land comprised in t/no. NN128983. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Okt. 1994 Geliefert am 25. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Deene house, market square, corby, northamptonshire t/no. NN145263. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Juli 1994 Geliefert am 20. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the bond street centre k/a land and buildings on the south side of bond street and west side of albion street, leeds t/no. YWE70082 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Juni 1994 Geliefert am 30. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Jan. 1994 Geliefert am 18. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ashton-under-lyne shopping centre, tameside, greater manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over rental income | Erstellt am 06. Juli 1993 Geliefert am 07. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the hongkong and shanghai banking corporation limited as agent for itself and the beneficiaries under the terms of any security document (as defined) and this charge. | |
Kurze Angaben First fixed charge over all monies now or hereafter standing in the credit of : the rental income account being three accounts of the company with midland bank PLC london property & construction area office 3RD floor 117 great portland street london wia 4UY sort code 40-05-22 bearing account numbers: current account 31148613:money master account:31148605 money market account:un-numbered.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Feb. 1993 Geliefert am 01. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the hongkong and shanghai banking corporation limited, as agent for itself and the beneficiaries under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a 26 and 27 new post office square, corby, n orthamptonshire - title no. NN150320, (see ch microfiche for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 26. Feb. 1993 Geliefert am 01. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the chargee under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge over all monies standing to the credit of the rental income account being an account with the agent bearing account no. 074-000449-151 and the property sales accouont being an account of the company with the agent bearing account no. 74-000449-152 (see ch microfiche for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over construction contract | Erstellt am 26. Feb. 1993 Geliefert am 01. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the chargee as agent for itself and the beneficiaries under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge | |
Kurze Angaben All the company's present and future rights title and interest in and to the construction contract dated 14/10/91 for the construction of a shell and core retail units blocks a and b at st andrew market square, corby, northamptonshire to be carried out by the contractor together with any bond issued pursuant thereto (see ch microfiche for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental trust deed | Erstellt am 09. Apr. 1992 Geliefert am 14. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000,000 10 1/4% first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other moneys due or to become due to the chargee (the trustees of the said stock) under the deeds constituting and securing the said stock | |
Kurze Angaben F/H land on the north and west side of longcauseway dewsbury kirklees west yorkshire t/n wyk 157919 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Juli 1989 Geliefert am 01. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Corby town centre, northamptonshire together with the fixed plant machinery & other fixtuers. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental trust deed | Erstellt am 22. Feb. 1989 Geliefert am 28. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 50,000,000 10 1/4 % first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and interest thereon and all other moneys intended to be secured by the deeds as defined. | |
Kurze Angaben F/H land on the north and west side of longcauneway dewsbury. Kirklees, west yorkshire title no wyk 157919 freehold land lying to the west of longcauneway dewsbury aforesaid. Title no wyk 243684 with bldgs, fixtures etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CORBY TC LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0