TECNO RETAIL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TECNO RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02256271 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TECNO RETAIL LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TECNO RETAIL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TECNO RETAIL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHADOW GB LIMITED | 11. Juli 1988 | 11. Juli 1988 |
| FORGEFIRST LIMITED | 11. Mai 1988 | 11. Mai 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TECNO RETAIL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TECNO RETAIL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Liquidation | 1 Seiten | L64.07 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Molyneux als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Hannan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Emmett als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Joanna Boydell als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Chris Yates als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Cashman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Hannan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Cashman als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2009 bis 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | MG01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TECNO RETAIL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYDELL, Joanna | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 164373820001 | |||||
| EMMETT, Sean Robert | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 152701300001 | |||||
| YATES, Chris | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 165227300001 | |||||
| CRABTREE, John Nigel | Sekretär | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | British | 48224770001 | ||||||
| MOLYNEUX, Nicholas John | Sekretär | 168 Kenrick Road Mapperley NG3 6EX Nottingham Nottinghamshire | British | 93529300001 | ||||||
| SPRATLEY, James Peter Conway | Sekretär | 19 Beaconsfield Road St Margarets TW1 3HX Twickenham | British | 28862210003 | ||||||
| BARRON, Paul | Geschäftsführer | Little Copse Knowle Grove GU25 4JD Virginia Water Surrey | Irish | 42811080001 | ||||||
| BINGER, David Ernest | Geschäftsführer | Wood End Firthsden Copse Potten End HP4 2RQ Berkhamsted Hertfordshire | British | 9897020001 | ||||||
| BRITTEN, John Fletcher | Geschäftsführer | Gracious Pond Farm Gracious Pond Road GU24 8HL Chobham Surrey | British | 103341450001 | ||||||
| CASHMAN, David Peter Charles | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 151553190001 | |||||
| COLLIER, Richard John | Geschäftsführer | Spencer House 14 West End Welford NN6 6HJ Northampton Northamptonshire | British | 68393200003 | ||||||
| COULSON, Francis Archer | Geschäftsführer | West Dullater FK17 8HG Callander Perthshire | United Kingdom | British | 56397070001 | |||||
| CRABTREE, John Nigel | Geschäftsführer | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 48224770001 | |||||
| DUNSTONE, Charles William | Geschäftsführer | 84 Campden Street W8 7EN London | British | 43842070001 | ||||||
| EVANS, Nicholas Gareth | Geschäftsführer | 3 Kingsmead Edlesborough LU6 2JN Dunstable Bedfordshire | British | 24811140001 | ||||||
| FAY, Anthony William | Geschäftsführer | Gatesdene House Gatesdene Close Little Gaddesden HP4 1PB Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 5690480002 | |||||
| FRYATT, Andrew Robert | Geschäftsführer | Garden Cottage Kenswick, Lower Broadheath WR2 6QX Worcester Worcestershire | British | 71780340001 | ||||||
| GIDDINGS, Michael John | Geschäftsführer | 3 Nailsworth Road Dorridge B93 8NS Solihull West Midlands | British | 105128310002 | ||||||
| GRAY, Ian Archie | Geschäftsführer | 6 Baronsmead Road SW13 9RR London | England | British | 115801110001 | |||||
| GUTTERIDGE, John | Geschäftsführer | 1 The Avenue MK45 2NR Ampthill Bedfordshire | England | British | 70170890001 | |||||
| HANNAN, Andrew | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 153976980001 | |||||
| HARLING, Michael John | Geschäftsführer | 71 Kings Road HP8 4HN Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 29229870001 | ||||||
| HARRIS, Ian Michael Brian | Geschäftsführer | Meadowsteep Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 116885790001 | |||||
| HENLEY, David Henry | Geschäftsführer | 4 St Nicholas Close Tingrith MK17 9EL Milton Keynes Buckinghamshire | British | 64485210001 | ||||||
| HINE, Derek Leslie | Geschäftsführer | Red Lion Witley Road Holt Heath WR6 6LX Worcester | United Kingdom | British | 61935280001 | |||||
| JOHNSON, David Arthur | Geschäftsführer | 23 Balmoral Close GU34 1QY Alton Hampshire | British | 28862240001 | ||||||
| MCHUGH, Frank | Geschäftsführer | 9 Maidenhair Drive CV23 0SE Rugby Warwickshire | British | 47650310001 | ||||||
| RICHER, Julian | Geschäftsführer | The Pent House 68 Pall Mall SW1Y 5ES London | United Kingdom | British | 61006910002 | |||||
| ROLLASON, William Peter | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester | United Kingdom | British | 67354680003 | |||||
| SAINSBURY, Stephen Paul | Geschäftsführer | 20 Manor Court Manor Road TW2 5DL Twickenham Middlesex | British | 72581570001 | ||||||
| SPRATLEY, James Peter Conway | Geschäftsführer | 19 Beaconsfield Road St Margarets TW1 3HX Twickenham | British | 28862210003 | ||||||
| URRY, Julian | Geschäftsführer | 56 Westgate Tickhill DN11 9NQ Doncaster South Yorkshire | British | 43066640001 |
Hat TECNO RETAIL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 29. Sept. 2009 Geliefert am 06. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Sept. 2009 Geliefert am 02. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 30. Aug. 2007 Geliefert am 17. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental deed | Erstellt am 07. Juni 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 19. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 1999 Geliefert am 10. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Lease security deposit agreement | Erstellt am 21. Sept. 1998 Geliefert am 25. Sept. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £12,054 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All money standing to the credit of the interest bearing account at barclays bank PLC in the name of vodafone group services limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 1997 Geliefert am 06. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Juni 1993 Geliefert am 21. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Jan. 1991 Geliefert am 29. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an guarantee of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 17. Mai 1990 Geliefert am 30. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TECNO RETAIL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0