HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED

HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02256466
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Pinsent Masons Llp
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Part Ground & First Floor Two Parklands Great Park Rubery Birmingham B45 9PZ zum C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB am 20. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Juli 2017

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Patricia Lesley Lee als Geschäftsführer am 31. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 29. Juni 2017

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 28/06/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. März 2016

    Kapitalaufstellung am 01. März 2016

    • Kapital: GBP 67,002
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. März 2015

    Kapitalaufstellung am 02. März 2015

    • Kapital: GBP 67,002
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014

    8 SeitenAA

    Ernennung von Ms Patricia Lesley Lee als Direktor am 22. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Albert Edward Smith als Geschäftsführer am 22. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 13. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 67,002
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Katharine Kandelaki als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 30. Juni 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Albert Edward Smith am 25. Juli 2012

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANSON, David Lindsay
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    Geschäftsführer
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    United KingdomBritishNone170602970001
    BORG, Richard Joseph
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    Sekretär
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    BritishDirector121685170001
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United Kingdom
    British171438140001
    MCGEORGE, James Wallace
    Strother House Farm
    Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Strother House Farm
    Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    British4409690001
    BENEY, Ralph Martin
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    Geschäftsführer
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director85286690001
    BORG, Richard Joseph
    St. James's Square
    SW1Y 4JR London
    31a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St. James's Square
    SW1Y 4JR London
    31a
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector147791080001
    LEE, Patricia Lesley
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    Geschäftsführer
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    MCGEORGE, James Wallace
    Strother House Farm
    Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Strother House Farm
    Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    BritishDirector4409690001
    MCGEORGE, Stephen Andrew
    Stable Cottage
    Strother House Farm Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Stable Cottage
    Strother House Farm Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    BritishManager50999980003
    MCGEORGE, Valerie Amelia
    Strother House Farm
    Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Strother House Farm
    Follingsby Lane
    NE37 3JB Washington
    Tyne & Wear
    BritishDirector4409700001
    SMITH, Albert Edward
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United Kingdom
    EnglandBritishUnited Kingdom77631340001
    SUTHERLAND MCGEORGE, Graeme
    6 West Hill
    High Barnes
    SR4 8PU Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    6 West Hill
    High Barnes
    SR4 8PU Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishManager59266650002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Healthcare Properties (Oxford) Ltd
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parlands
    England
    06. Apr. 2016
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parlands
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer04556634
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 2003
    Geliefert am 24. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that freehold property known as land at thorndale road sunderland SR3 4JT t/n's TY291516 together with land to the east of thorndale road sunderland. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 2000
    Geliefert am 24. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the old school house pickering nook stanley DU151301. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 1999
    Geliefert am 18. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a burn park house north view terrace fence houses sunderland DH4 5NW t/n TY325774. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Aug. 1998
    Geliefert am 14. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a stanley burn house station road wylam northumberland. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed charge on book debts
    Erstellt am 14. Nov. 1997
    Geliefert am 18. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 1997
    Geliefert am 01. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 26 grosvenor road south shields tyne & wear t/n TY53967 fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 1997
    Geliefert am 01. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a beaconsfield old newcastle road cornbridge tynedale t/n ND80056 fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 1997
    Geliefert am 01. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Holly garth brandon lane brandon co durham t/n DU5516 fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 1997
    Geliefert am 01. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a howard castle dacre street morpeth (also k/a howard castle nursing home t/n's ND11141 and ND90100 fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 1990
    Geliefert am 04. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H lands hereditametns & premises being the villa, kibblesworth gateshead t/n ty 206161 fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 03. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Sept. 1988
    Geliefert am 12. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 23. Sept. 1988
    Geliefert am 12. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H lands hereditaments & premises being:- the villa, kibblesworth, gateshead t/nos: ty 51049 and ty 159905.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1988Registrierung einer Belastung

    Hat HOLLYGARTH CARE HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Juli 2017Beginn der Liquidation
    02. Nov. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0