CNC (CITY) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCNC (CITY) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02257640
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CNC (CITY) LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CNC (CITY) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor The Atrium
    31 Church Road
    TW15 2UD Ashford
    Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CNC (CITY) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    QUICKNEAT LIMITED13. Mai 198813. Mai 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CNC (CITY) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CNC (CITY) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CNC (CITY) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2016

    19 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Juni 2013

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Mai 2013

    2 Seiten3.6

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2015

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2014

    13 Seiten4.68

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Vermögensübersicht

    4.20

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor the Atrium Ashford Middlesex TW15 2UD England* am 20. März 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    legacy

    4 SeitenLQ01

    legacy

    4 SeitenLQ01

    legacy

    3 SeitenLQ01

    legacy

    4 SeitenLQ01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 23. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 5,000,000
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Marie Annick Avis am 30. Apr. 2010

    2 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    12 SeitenMG06

    legacy

    9 SeitenMG01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CNC (CITY) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AVIS, Marie Annick
    Brook Hill
    Farley Green Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Brook Hill
    Farley Green Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    British91430630002
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Geschäftsführer
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    AVIS, Marie Annick
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    Sekretär
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    British91430630002
    BLACKETT, Kathleen
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    Sekretär
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    British1501820001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    British2667400001
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Sekretär
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    CARDEN-NOAD, Stephen Mark
    7 Coney Close
    Langley Green
    RH11 7QA Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    7 Coney Close
    Langley Green
    RH11 7QA Crawley
    West Sussex
    British15950300001
    HAVER, Raymond Victor
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    British15226710001
    JOHNSTON, James Vincent
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    British35134150001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Geschäftsführer
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    NEDHAM, Andrew James
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    British66426700001
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005
    VINCENT, Gregory
    2 The Limes
    Sarson Lane, Amport
    SP11 8HX Andover
    Hampshire
    Geschäftsführer
    2 The Limes
    Sarson Lane, Amport
    SP11 8HX Andover
    Hampshire
    EnglandBritish65461840001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002

    Hat CNC (CITY) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 2010
    Geliefert am 07. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The mortgaged property means the real property - f/h land at the north seaton estate, ashington, northumberland t/no ND102631.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 202. Juni 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 2
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 26. Sept. 2009
    Erworben am 23. Dez. 2010
    Geliefert am 12. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Real property means the f/h land at the north seaton estate, ashington, northumberland t/no ND102631 including fixtures, plant, machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2011Registrierung eines Erwerbs (MG06)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 26. Aug. 2009
    Geliefert am 01. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Britannia house spring street 2 ferensway kingston upon hull t/no HS120963, land lying south of wansbeck district hospital t/no ND102630, 9 castle street cardiff t/no WA448850 (for details of further properties charged please refer to the form 395); fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 102. Juni 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 329. Juni 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 410. Juli 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 413. Okt. 2015Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 4
      • Aktenzeichen 1
      • Aktenzeichen 3
    Share charge
    Erstellt am 02. Juli 2009
    Geliefert am 20. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee and/or the hedging counterparty and/or ant associated company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the investments including all rights of enforcement of the same- being the interest of the chargor in one ordinary share of the borrower see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 22. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 2003
    Geliefert am 27. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being plot 29 heol stanlydd cross hands business park cross hands llanelli t/n CYM125557. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 2001
    Geliefert am 20. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9 castle street and 11 castle st,cardiff; WA448850 and WA448854. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juni 2001
    Geliefert am 03. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land on the south side of hamm moor lane chertsey t/n SY700701 and SY700762. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 26. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the senior finance documents (or any of them) to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent)
    Transaktionen
    • 26. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Standard security presented for registration in scotland 21ST july 2000
    Erstellt am 10. Juli 2000
    Geliefert am 03. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the chargee (as security agent and trustee for itself and the finance parties) and to any of the finance parties (as defined) by each charging company and any of the obligors under the senior credit agreement dated 18TH may 2000 including any agreement,deed or other document supplemental thereto or in corroboration or in substitution thereof
    Kurze Angaben
    Subject on the southwest side of stirling road airdrie t/n LAN77108.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland 21ST july 2000
    Erstellt am 10. Juli 2000
    Geliefert am 03. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the chargee (as security agent and trustee for itself and the finance parties) and to any of the finance parties (as defined) by each charging company and any of the obligors under the senior credit agreement dated 18TH may 2000 including any agreement,deed or other document supplemental thereto or in corroboration or in substitution thereof
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects lying on the north west side of woodrow avenue carfin t/n LAN87412.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland 21ST july 2000
    Erstellt am 10. Juli 2000
    Geliefert am 03. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the chargee (as security agent and trustee for itself and the finance parties) and to any of the finance parties (as defined) by each charging company and any of the obligors under the senior credit agreement dated 18TH may 2000 including any agreement,deed or other document supplemental thereto or in corroboration or in substitution thereof
    Kurze Angaben
    Subject on the north side of the A8 at westferry langbank port glasgow t/n ren 33227.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Juni 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a nene house 10/12 pilgrim street newcastle upon tyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 29. Apr. 1997
    Geliefert am 01. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge dated 31ST march 1994
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of waterlinks house richard street heartlands birmingham. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 1996
    Geliefert am 12. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Queens house 2 holly road twickenham middx t/no mx 447624 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 80/80A fenchurch street london EC3 t/n LN62407, fixed charge the goodwill and assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 34/36 st georges road brighton east sussex t/n's SX112752, SX114788 and SX109674, fixed charge all goodwill and assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 3 queen's circus cheltenham gloucestershire, fixed charge all goodwill, assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 22 imperial square cheltenham gloucestershire, fixed charge all goodwill, assigns benefits of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a victoria house 18-22 albert street fleet hampshire t/n HP347533, fixed charge the goodwill, assigns benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 4 st george's place brighton east sussex t/n ESX24677, fixed charge all goodwill, assigns benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land lying to the south east of london road westerham (otherwise k/a the westerham trading centre flyers way london road westerham kent) t/n K536959, fixed charge all goodwill, assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Aug. 1994
    Geliefert am 08. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage:-parsons house parsons road parsons washington sunderland tyne & wear goodwill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1994
    Geliefert am 01. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage;-emerald house,30/38 high street byfleet surrey goodwill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cnc house 33 high street sunninghill ascot berkshire the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CNC (CITY) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    5
    DatumTyp
    07. März 2013Beginn der Liquidation
    29. Sept. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0